ISI DISTRIBUTION LTD

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaISI DISTRIBUTION LTD
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02478802
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de ISI DISTRIBUTION LTD?

    • Otras actividades de servicios de tecnología de la información (62090) / Información y comunicación

    ¿Dónde se encuentra ISI DISTRIBUTION LTD?

    Dirección de la sede social
    Redwood 2 Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Hampshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ISI DISTRIBUTION LTD?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    IQ SYS LIMITED05 oct 200605 oct 2006
    INTERQUAD SYSTEMS LIMITED29 dic 200029 dic 2000
    INTERQUAD DISTRIBUTION LIMITED14 may 199814 may 1998
    EXOCOM INTERNATIONAL LIMITED03 jul 199003 jul 1990
    POWERBAND LIMITED08 mar 199008 mar 1990

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de ISI DISTRIBUTION LTD?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 jun 2015

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para ISI DISTRIBUTION LTD?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    8 páginasLIQ13

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 10 ago 2018

    9 páginasLIQ03

    Declaración de solvencia

    4 páginasLIQ01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 11 ago 2017

    LRESSP

    Estado de capital el 27 jun 2017

    • Capital: GBP 100
    5 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Share premium account cancelled 20/06/2017
    RES13
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Renuncia del auditor

    1 páginasAUD

    Declaración de confirmación presentada el 08 mar 2017 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Déclaration annuelle établie au 08 mar 2016 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital19 jul 2016

    Estado de capital el 19 jul 2016

    • Capital: GBP 1,100
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2015

    17 páginasAA

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Appointment of dirs 12/10/2015
    RES13

    Cese del nombramiento de Peter Hubbard como director el 29 jun 2015

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr David Watts como director el 26 oct 2015

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Howard Tuffnail como director el 26 oct 2015

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Andy Gass como director el 26 oct 2015

    2 páginasAP01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2014

    19 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 08 mar 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital02 jun 2015

    Estado de capital el 02 jun 2015

    • Capital: GBP 1,100
    SH01

    Cese del nombramiento de Paul Andrew Eccleston como director el 28 nov 2014

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2013

    20 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 08 mar 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital25 mar 2014

    Estado de capital el 25 mar 2014

    • Capital: GBP 1,100
    SH01

    Exercice comptable en cours prolongé du 31 mar 2014 au 30 jun 2014

    3 páginasAA01

    ¿Quiénes son los directivos de ISI DISTRIBUTION LTD?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    OLLIS, Rachel Anne
    Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Redwood 2
    Hampshire
    United Kingdom
    Secretario
    Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Redwood 2
    Hampshire
    United Kingdom
    178574660001
    GASS, Andrew
    Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Redwood 2
    Hampshire
    Director
    Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Redwood 2
    Hampshire
    EnglandBritish49358720003
    TUFFNAIL, Howard
    Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Redwood 2
    Hampshire
    Director
    Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Redwood 2
    Hampshire
    United KingdomCanadian202334610001
    WATTS, David
    Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Redwood 2
    Hampshire
    Director
    Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Redwood 2
    Hampshire
    EnglandBritish160214110001
    ARNETT, Edward Alan
    21 Clearwater Place
    Long Ditton
    KT6 4ET Surbiton
    Surrey
    Secretario
    21 Clearwater Place
    Long Ditton
    KT6 4ET Surbiton
    Surrey
    British84568350002
    HYAMS, Mitchell Spencer
    Pipers Barn
    55 Copperkins Lane
    HP6 5RA Amersham
    Buckinghamshire
    Secretario
    Pipers Barn
    55 Copperkins Lane
    HP6 5RA Amersham
    Buckinghamshire
    British13800580002
    JOHNSON, Ian Paul
    20 Anglesey Drive
    SK12 1BT Poynton
    Ringwood
    Cheshire
    United Kingdom
    Secretario
    20 Anglesey Drive
    SK12 1BT Poynton
    Ringwood
    Cheshire
    United Kingdom
    British136279590001
    PENNELLS, John Richard
    Enclave
    Wych Hill Way
    GU22 0AE Woking
    Surrey
    Secretario
    Enclave
    Wych Hill Way
    GU22 0AE Woking
    Surrey
    British7347950001
    TRAINER, Martin John
    6 Stone Pine Road
    MK43 8GG Bromham
    Bedfordshire
    Secretario
    6 Stone Pine Road
    MK43 8GG Bromham
    Bedfordshire
    British124180840001
    ARNETT, Edward Alan
    21 Clearwater Place
    Long Ditton
    KT6 4ET Surbiton
    Surrey
    Director
    21 Clearwater Place
    Long Ditton
    KT6 4ET Surbiton
    Surrey
    British84568350002
    CORNWALL, Douglas Charles
    Domaine De La Roche
    Le Bigard
    GY8 0HT Forest
    Guernsey
    Channel Islands
    Director
    Domaine De La Roche
    Le Bigard
    GY8 0HT Forest
    Guernsey
    Channel Islands
    United KingdomBritish84669710001
    ECCLESTON, Paul Andrew
    Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Redwood 2
    Hampshire
    United Kingdom
    Director
    Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Redwood 2
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritish139879610001
    FANE, Sean Paul
    Nashgrove Lane
    Finchampstead
    RG40 4HG Wokingham
    131
    Berkshire
    United Kingdom
    Director
    Nashgrove Lane
    Finchampstead
    RG40 4HG Wokingham
    131
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish67225450007
    HERRON, Bonnie Lea
    1959 Trotters Lane
    Stone Mountain
    30087 Georgia
    Usa
    Director
    1959 Trotters Lane
    Stone Mountain
    30087 Georgia
    Usa
    American16958430002
    HUBBARD, Peter
    Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Redwood 2
    Hampshire
    United Kingdom
    Director
    Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Redwood 2
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish167795150001
    HYAMS, Mitchell Spencer
    Pipers Barn
    55 Copperkins Lane
    HP6 5RA Amersham
    Buckinghamshire
    Director
    Pipers Barn
    55 Copperkins Lane
    HP6 5RA Amersham
    Buckinghamshire
    EnglandBritish13800580002
    JAMES, Philip John
    Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Redwood 2
    Hampshire
    United Kingdom
    Director
    Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Redwood 2
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritish118754760002
    JOHNSON, Ian Paul
    20 Anglesey Drive
    SK12 1BT Poynton
    Ringwood
    Cheshire
    United Kingdom
    Director
    20 Anglesey Drive
    SK12 1BT Poynton
    Ringwood
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish136279590001
    MACPHERSON, William Robert George
    Benenden
    TN17 4LG Cranbrook
    Little Nineveh
    Kent
    United Kingdom
    Director
    Benenden
    TN17 4LG Cranbrook
    Little Nineveh
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritish132097710001
    MARTIN, Christian John
    Kingswood House
    Tag Lane Wargrave
    RG10 9ST Reading
    Berkshire
    Director
    Kingswood House
    Tag Lane Wargrave
    RG10 9ST Reading
    Berkshire
    EnglandBritish113992220001
    MCCORMICK, John Edgar
    5275 Cameron Forest Parkway
    FOREIGN Alpharetti
    Georgia
    Usa
    Director
    5275 Cameron Forest Parkway
    FOREIGN Alpharetti
    Georgia
    Usa
    American16958460001
    MINNS, Gregory Leslie John
    113 Paddick Drive
    RG6 4HF Lower Earley
    Berkshire
    Director
    113 Paddick Drive
    RG6 4HF Lower Earley
    Berkshire
    United KingdomBritish72170360001
    PENNELLS, John Richard
    Enclave
    Wych Hill Way
    GU22 0AE Woking
    Surrey
    Director
    Enclave
    Wych Hill Way
    GU22 0AE Woking
    Surrey
    EnglandBritish7347950001
    RIGBY, James Peter
    Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Redwood 2
    Hampshire
    United Kingdom
    Director
    Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Redwood 2
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish88633720001
    RIGBY, Peter, Sir
    Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Redwood 2
    Hampshire
    United Kingdom
    Director
    Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Redwood 2
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish15654920006
    STRANGE, John Leland
    2714 Meadow Church Road
    FOREIGN Duluth
    Georgia
    Usa
    Director
    2714 Meadow Church Road
    FOREIGN Duluth
    Georgia
    Usa
    American16958470001
    TRAINER, Martin John
    6 Stone Pine Road
    MK43 8GG Bromham
    Bedfordshire
    Director
    6 Stone Pine Road
    MK43 8GG Bromham
    Bedfordshire
    EnglandBritish124180840001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de ISI DISTRIBUTION LTD?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Specialist Distribution Group (Sdg) Ltd
    Guildford Road
    Normandy
    GU3 2AW Guildford
    Redwood 2
    England
    06 abr 2016
    Guildford Road
    Normandy
    GU3 2AW Guildford
    Redwood 2
    England
    No
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalEngland And Wales
    Lugar de registroEngland
    Número de registro1769690
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene ISI DISTRIBUTION LTD alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A fixed charge on book and other debts
    Creado el 04 nov 2011
    Entregado el 10 nov 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All book debts and other debts and monetary claims and any rent licence fees or other payments due from any lessee, licensee or occupier of any immovable property wherever.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 10 nov 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 21 nov 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Legal assignment
    Creado el 04 nov 2011
    Entregado el 10 nov 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Any credit balance due under the contract (the contract monies).
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 10 nov 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 21 nov 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest
    Creado el 04 nov 2011
    Entregado el 09 nov 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of fixed equitable charge all purchased debts which fail to vest effectively or absolutely in the security holder pursuant to the agreement see image for full details.
    Personas con derecho
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD ("the Security Holder")
    Transacciones
    • 09 nov 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 21 nov 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    All assets debenture
    Creado el 14 oct 2010
    Entregado el 27 oct 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transacciones
    • 27 oct 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 12 nov 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Fixed & floating charge
    Creado el 15 may 2009
    Entregado el 27 may 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transacciones
    • 27 may 2009Registro de un cargo (395)
    • 06 ago 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 30 oct 2007
    Entregado el 03 nov 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland, as Security Trustee for the Finance Parties
    Transacciones
    • 03 nov 2007Registro de un cargo (395)
    • 09 may 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 03 jun 2004
    Entregado el 05 jun 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 05 jun 2004Registro de un cargo (395)
    • 13 nov 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    All assets debenture
    Creado el 15 nov 2000
    Entregado el 23 nov 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under this debenture
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transacciones
    • 23 nov 2000Registro de un cargo (395)
    • 21 dic 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 02 nov 2000
    Entregado el 07 nov 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 07 nov 2000Registro de un cargo (395)
    • 21 dic 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 05 may 1999
    Entregado el 13 may 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to a guarantee agreement of even date and the deed
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Isc (Guernsey) Limited
    Transacciones
    • 13 may 1999Registro de un cargo (395)
    • 21 dic 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 03 feb 1999
    Entregado el 16 feb 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a loan agreement dated 3 february 1999
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Isc (Guernsey) Limited
    Transacciones
    • 16 feb 1999Registro de un cargo (395)
    • 13 may 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 28 ene 1999
    Entregado el 02 feb 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 02 feb 1999Registro de un cargo (395)
    • 21 dic 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 21 dic 1998
    Entregado el 23 dic 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed charge over all book and other debts present and future and the benefit of all contracts and policies of insurance and by way of floating charge the undertaking and all property assets and rights of the company present and future.
    Personas con derecho
    • Euro Sales Finance PLC
    Transacciones
    • 23 dic 1998Registro de un cargo (395)
    • 21 dic 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene ISI DISTRIBUTION LTD algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    11 ago 2017Inicio de la liquidación
    16 ene 2020Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Robert Nicholas Lewis
    Pricewaterhousecoopers Llp
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Profesional
    Pricewaterhousecoopers Llp
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Laura May Waters
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Profesional
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0