SHIRE PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | SHIRE PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02486738 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de SHIRE PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT LIMITED?
- Otras investigaciones y desarrollo experimental en ciencias naturales e ingeniería (72190) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra SHIRE PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT LIMITED?
| Dirección de la sede social | 1 Kingdom Street W2 6BD London United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SHIRE PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| ROCHGRANGE LIMITED | 29 mar 1990 | 29 mar 1990 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de SHIRE PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2021 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para SHIRE PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Mark Gibbons como director el 08 nov 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 28 jun 2022 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2021 | 31 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Peter Michael Grubin como director el 01 mar 2022 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Kentaro Shirahata como director el 01 mar 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Estado de capital el 11 nov 2021
| 3 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 2 páginas | SH20 | ||||||||||
legacy | 2 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 28 jun 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2020 | 29 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr Mark Gibbons como director el 30 nov 2020 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Marc Stuart Page como director el 30 nov 2020 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Nicholas Hugh Meryon Insall como director el 30 nov 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Sarah Lucy Charsley como director el 30 nov 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 28 jun 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Shire Corporate Services Limited el 28 abr 2020 | 1 páginas | CH04 | ||||||||||
Exercice comptable en cours prolongé du 31 dic 2019 au 31 mar 2020 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Renuncia del auditor | 1 páginas | AUD | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2018 | 32 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 28 jun 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Nicholas Hugh Meryon Insall como director el 28 feb 2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de SHIRE PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAKEDA CORPORATE SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | Kingdom Street W2 6BD London 1 United Kingdom |
| 244206590002 | ||||||||||
| GRUBIN, Peter Michael | Director | Kingdom Street W2 6BD London 1 United Kingdom | England | American | 293835890001 | |||||||||
| PAGE, Marc Stuart | Director | Kingdom Street W2 6BD London 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 277077440001 | |||||||||
| GUTHRIE, Anthony James | Secretario | Hampshire Int Business Park Chineham RG24 8EP Basingstoke Lime Tree Way Hampshire | British | 131668010002 | ||||||||||
| HARRIS, Neil Charles | Secretario | Old Tiles Church Lane SP6 3LE Martin Hampshire | British | 96188470001 | ||||||||||
| MAY, Tatjana Anni Hilde | Secretario | Hampshire International Business Park Chineham RG24 8EP Basingstoke Hampshire | British | 75855670003 | ||||||||||
| MCLEAN, Andrew Firth | Secretario | Beech Cottage London Road RG27 8RN Hartley Wintney Hampshire | British | 55993260003 | ||||||||||
| MCPARTLAND, Peter | Secretario | The Forge House Church End SG8 8JN Barley Hertfordshire | British | 155226180001 | ||||||||||
| RUSSELL, Angus Charles | Secretario | High View Monks Well GU10 1RH Farnham Surrey | British | 52943380002 | ||||||||||
| STRAWBRIDGE, Oliver | Secretario | Kingdom Street W2 6BD London 1 United Kingdom | 202187490001 | |||||||||||
| CARRUTHERS, Fearghas Macgilp Kerr | Director | Kingdom Street W2 6BD London 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 178667180002 | |||||||||
| CHARSLEY, Sarah Lucy | Director | Kingdom Street W2 6BD London 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 239205090001 | |||||||||
| CLARKE, Janet | Director | Hainault Holt Way Hook RG27 9EW Basingstoke Hampshire | British | 14380770001 | ||||||||||
| CLEMENTS, Patrick Norris | Director | Hampshire International Business Park Chineham RG24 8EP Basingstoke Hampshire | United Kingdom | British | 122369120001 | |||||||||
| COLLINS, Clive John | Director | 9 Chanctonbury Close BN16 2JB Rustington West Sussex | British | 55993310001 | ||||||||||
| DAVIS, Trevor | Director | Monks Hill Oast TN27 8QJ Smarden Kent | United Kingdom | British | 37725830001 | |||||||||
| EMMENS, Matthew William | Director | Hampshire International Business Park Chineham RG24 8EP Basingstoke Hampshire | American | 88969740002 | ||||||||||
| FERDINANDO, Josephine Joan Christine | Director | Lime Tree Way Hampshire Int Business Park, Chineham RG24 8EP Basingstoke . Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 132556860001 | |||||||||
| GIBBONS, Mark | Director | Kingdom Street W2 6BD London 1 United Kingdom | England | South African | 248159240001 | |||||||||
| HARTLEY, Daniel William David | Director | Hampshire International Business Park RG24 8EP Basingstoke Hampshire | United Kingdom | Australian | 184526870001 | |||||||||
| INSALL, Nicholas Hugh Meryon | Director | Kingdom Street W2 6BD London 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 248118390001 | |||||||||
| KANIS, John Anthony, Professor | Director | 3 Park Lane S10 2DU Sheffield South Yorkshire | British | 10424430001 | ||||||||||
| MCPARTLAND, Peter | Director | The Forge House Church End SG8 8JN Barley Hertfordshire | England | British | 155226180001 | |||||||||
| MILLER, Amanda | Director | Kingdom Street W2 6BD London 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 186523040021 | |||||||||
| MURRAY, James Robert, Doctor | Director | Lamb House Ludwell SP7 9ND Shaftesbury Dorset | British | 46087170001 | ||||||||||
| RUS, Joseph | Director | 1 Palace Pier Court, Suite 801 Toronto Ontario M8v 3w9 Canada | Canadian | 95909400001 | ||||||||||
| RUSSELL, Angus Charles | Director | Hampshire International Business Park Chineham RG24 8EP Basingstoke Hampshire | United Kingdom | British | 52943380004 | |||||||||
| SHIRAHATA, Kentaro | Director | Kingdom Street W2 6BD London 1 United Kingdom | United Kingdom | Japanese | 248114700001 | |||||||||
| SIMON, Henry | Director | 1 Telegraph Hill NW3 7NU London | British | 35022160001 | ||||||||||
| STAHEL, Rolf | Director | Neatham Sleepers Hill SO22 4NB Winchester Hampshire | United Kingdom | Swiss | 41392130001 | |||||||||
| STAMP, Stephen Antony | Director | Minto Cottage Rectory Lane Bentley GU10 5JS Farnham Surrey | British | 38572920003 | ||||||||||
| STRATFORD, Harry Thomas | Director | The Laws House TD11 3LU Duns Berwickshire | United Kingdom | British | 125826470001 | |||||||||
| TOTTEN, Joseph Wilson, Doctor | Director | Sycamore House Tile Barn Row Woolton Hill RG20 9TF Newbury Berkshire | British | 64168050001 | ||||||||||
| WEBB, Jonathan Ivan William | Director | Kingdom Street W2 6BD London 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 220802930001 | |||||||||
| WILLIAMS, Stephen Philip | Director | Kingdom Street W2 6BD London 1 United Kingdom | England | British | 232177850001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de SHIRE PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shire Pharmaceuticals Group | 06 abr 2016 | Kingdom Street W2 6BD London 1 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene SHIRE PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creado el 23 dic 1999 Entregado el 06 ene 2000 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All obligations (monetary or otherwise ) of the company to the chargee arising under or in connection with the amended and restated credit agreement dated 19TH november 1999, any interest rate swap,cap,collar or similar agreement entered into pursuant to the terms of the credit agreement, any promissory note payable to any lender under the credit agreement evidencing the agrregate indebtedness to any such lender ,any standby or commercial letters of credit any loan request any letter of credit request,the letter dated 19TH november 199 and any agreements defined therein | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Deed poll constituting secured loan notes 1995 | Creado el 19 dic 1994 Entregado el 05 ene 1995 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee in respect of the £10,000,000 10% fixed rate secured loan notes 1995 originally constituted by the deed poll or under the deed poll; and all reasonable costs, charges and expenses incurred under or in respect of the deed poll or the additional security documentation (as defined therein) by the noteholders or any by any receiver appointed under the deed poll or under the additional security documentation and all other monies properly paid by any such receiver | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0