SHIRE PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT LIMITED

SHIRE PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaSHIRE PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02486738
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de SHIRE PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT LIMITED?

    • Otras investigaciones y desarrollo experimental en ciencias naturales e ingeniería (72190) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra SHIRE PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT LIMITED?

    Dirección de la sede social
    1 Kingdom Street
    W2 6BD London
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SHIRE PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    ROCHGRANGE LIMITED29 mar 199029 mar 1990

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de SHIRE PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2021

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para SHIRE PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cese del nombramiento de Mark Gibbons como director el 08 nov 2022

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 28 jun 2022 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2021

    31 páginasAA

    Nombramiento de Peter Michael Grubin como director el 01 mar 2022

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Kentaro Shirahata como director el 01 mar 2022

    1 páginasTM01

    Estado de capital el 11 nov 2021

    • Capital: GBP 1
    3 páginasSH19

    legacy

    2 páginasSH20

    legacy

    2 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Declaración de confirmación presentada el 28 jun 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2020

    29 páginasAA

    Nombramiento de Mr Mark Gibbons como director el 30 nov 2020

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Marc Stuart Page como director el 30 nov 2020

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Nicholas Hugh Meryon Insall como director el 30 nov 2020

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Sarah Lucy Charsley como director el 30 nov 2020

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 28 jun 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cambio de datos del secretario Shire Corporate Services Limited el 28 abr 2020

    1 páginasCH04

    Exercice comptable en cours prolongé du 31 dic 2019 au 31 mar 2020

    1 páginasAA01

    Renuncia del auditor

    1 páginasAUD

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2018

    32 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 28 jun 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Mr Nicholas Hugh Meryon Insall como director el 28 feb 2019

    2 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de SHIRE PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    TAKEDA CORPORATE SERVICES LIMITED
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónSociedad limitada del Reino Unido
    Número de registro11022500
    244206590002
    GRUBIN, Peter Michael
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    Director
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    EnglandAmerican293835890001
    PAGE, Marc Stuart
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    Director
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritish277077440001
    GUTHRIE, Anthony James
    Hampshire Int Business Park
    Chineham
    RG24 8EP Basingstoke
    Lime Tree Way
    Hampshire
    Secretario
    Hampshire Int Business Park
    Chineham
    RG24 8EP Basingstoke
    Lime Tree Way
    Hampshire
    British131668010002
    HARRIS, Neil Charles
    Old Tiles
    Church Lane
    SP6 3LE Martin
    Hampshire
    Secretario
    Old Tiles
    Church Lane
    SP6 3LE Martin
    Hampshire
    British96188470001
    MAY, Tatjana Anni Hilde
    Hampshire International Business
    Park Chineham
    RG24 8EP Basingstoke
    Hampshire
    Secretario
    Hampshire International Business
    Park Chineham
    RG24 8EP Basingstoke
    Hampshire
    British75855670003
    MCLEAN, Andrew Firth
    Beech Cottage
    London Road
    RG27 8RN Hartley Wintney
    Hampshire
    Secretario
    Beech Cottage
    London Road
    RG27 8RN Hartley Wintney
    Hampshire
    British55993260003
    MCPARTLAND, Peter
    The Forge House
    Church End
    SG8 8JN Barley
    Hertfordshire
    Secretario
    The Forge House
    Church End
    SG8 8JN Barley
    Hertfordshire
    British155226180001
    RUSSELL, Angus Charles
    High View
    Monks Well
    GU10 1RH Farnham
    Surrey
    Secretario
    High View
    Monks Well
    GU10 1RH Farnham
    Surrey
    British52943380002
    STRAWBRIDGE, Oliver
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    Secretario
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    202187490001
    CARRUTHERS, Fearghas Macgilp Kerr
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    Director
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritish178667180002
    CHARSLEY, Sarah Lucy
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    Director
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritish239205090001
    CLARKE, Janet
    Hainault Holt Way
    Hook
    RG27 9EW Basingstoke
    Hampshire
    Director
    Hainault Holt Way
    Hook
    RG27 9EW Basingstoke
    Hampshire
    British14380770001
    CLEMENTS, Patrick Norris
    Hampshire International Business
    Park Chineham
    RG24 8EP Basingstoke
    Hampshire
    Director
    Hampshire International Business
    Park Chineham
    RG24 8EP Basingstoke
    Hampshire
    United KingdomBritish122369120001
    COLLINS, Clive John
    9 Chanctonbury Close
    BN16 2JB Rustington
    West Sussex
    Director
    9 Chanctonbury Close
    BN16 2JB Rustington
    West Sussex
    British55993310001
    DAVIS, Trevor
    Monks Hill Oast
    TN27 8QJ Smarden
    Kent
    Director
    Monks Hill Oast
    TN27 8QJ Smarden
    Kent
    United KingdomBritish37725830001
    EMMENS, Matthew William
    Hampshire International Business
    Park Chineham
    RG24 8EP Basingstoke
    Hampshire
    Director
    Hampshire International Business
    Park Chineham
    RG24 8EP Basingstoke
    Hampshire
    American88969740002
    FERDINANDO, Josephine Joan Christine
    Lime Tree Way
    Hampshire Int Business Park, Chineham
    RG24 8EP Basingstoke
    .
    Hampshire
    United Kingdom
    Director
    Lime Tree Way
    Hampshire Int Business Park, Chineham
    RG24 8EP Basingstoke
    .
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish132556860001
    GIBBONS, Mark
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    Director
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    EnglandSouth African248159240001
    HARTLEY, Daniel William David
    Hampshire International Business Park
    RG24 8EP Basingstoke
    Hampshire
    Director
    Hampshire International Business Park
    RG24 8EP Basingstoke
    Hampshire
    United KingdomAustralian184526870001
    INSALL, Nicholas Hugh Meryon
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    Director
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritish248118390001
    KANIS, John Anthony, Professor
    3 Park Lane
    S10 2DU Sheffield
    South Yorkshire
    Director
    3 Park Lane
    S10 2DU Sheffield
    South Yorkshire
    British10424430001
    MCPARTLAND, Peter
    The Forge House
    Church End
    SG8 8JN Barley
    Hertfordshire
    Director
    The Forge House
    Church End
    SG8 8JN Barley
    Hertfordshire
    EnglandBritish155226180001
    MILLER, Amanda
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    Director
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritish186523040021
    MURRAY, James Robert, Doctor
    Lamb House
    Ludwell
    SP7 9ND Shaftesbury
    Dorset
    Director
    Lamb House
    Ludwell
    SP7 9ND Shaftesbury
    Dorset
    British46087170001
    RUS, Joseph
    1 Palace Pier Court, Suite 801
    Toronto
    Ontario M8v 3w9
    Canada
    Director
    1 Palace Pier Court, Suite 801
    Toronto
    Ontario M8v 3w9
    Canada
    Canadian95909400001
    RUSSELL, Angus Charles
    Hampshire International Business
    Park Chineham
    RG24 8EP Basingstoke
    Hampshire
    Director
    Hampshire International Business
    Park Chineham
    RG24 8EP Basingstoke
    Hampshire
    United KingdomBritish52943380004
    SHIRAHATA, Kentaro
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    Director
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    United KingdomJapanese248114700001
    SIMON, Henry
    1 Telegraph Hill
    NW3 7NU London
    Director
    1 Telegraph Hill
    NW3 7NU London
    British35022160001
    STAHEL, Rolf
    Neatham Sleepers Hill
    SO22 4NB Winchester
    Hampshire
    Director
    Neatham Sleepers Hill
    SO22 4NB Winchester
    Hampshire
    United KingdomSwiss41392130001
    STAMP, Stephen Antony
    Minto Cottage Rectory Lane
    Bentley
    GU10 5JS Farnham
    Surrey
    Director
    Minto Cottage Rectory Lane
    Bentley
    GU10 5JS Farnham
    Surrey
    British38572920003
    STRATFORD, Harry Thomas
    The Laws House
    TD11 3LU Duns
    Berwickshire
    Director
    The Laws House
    TD11 3LU Duns
    Berwickshire
    United KingdomBritish125826470001
    TOTTEN, Joseph Wilson, Doctor
    Sycamore House Tile Barn Row
    Woolton Hill
    RG20 9TF Newbury
    Berkshire
    Director
    Sycamore House Tile Barn Row
    Woolton Hill
    RG20 9TF Newbury
    Berkshire
    British64168050001
    WEBB, Jonathan Ivan William
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    Director
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritish220802930001
    WILLIAMS, Stephen Philip
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    Director
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    EnglandBritish232177850001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de SHIRE PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Shire Pharmaceuticals Group
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    England
    06 abr 2016
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Unlimited Liability Company
    País de registroEngland & Wales
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroEngland & Wales
    Número de registro2883758
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene SHIRE PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 23 dic 1999
    Entregado el 06 ene 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All obligations (monetary or otherwise ) of the company to the chargee arising under or in connection with the amended and restated credit agreement dated 19TH november 1999, any interest rate swap,cap,collar or similar agreement entered into pursuant to the terms of the credit agreement, any promissory note payable to any lender under the credit agreement evidencing the agrregate indebtedness to any such lender ,any standby or commercial letters of credit any loan request any letter of credit request,the letter dated 19TH november 199 and any agreements defined therein
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Dlj Capital Funding Inc.
    Transacciones
    • 06 ene 2000Registro de un cargo (395)
    • 02 ene 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed poll constituting secured loan notes 1995
    Creado el 19 dic 1994
    Entregado el 05 ene 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee in respect of the £10,000,000 10% fixed rate secured loan notes 1995 originally constituted by the deed poll or under the deed poll; and all reasonable costs, charges and expenses incurred under or in respect of the deed poll or the additional security documentation (as defined therein) by the noteholders or any by any receiver appointed under the deed poll or under the additional security documentation and all other monies properly paid by any such receiver
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The "Noteholders"
    Transacciones
    • 05 ene 1995Registro de un cargo (395)
    • 03 ago 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0