HITHERCROFT COURT MANAGEMENT COMPANY LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | HITHERCROFT COURT MANAGEMENT COMPANY LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Activa |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 02489297 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | No |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de HITHERCROFT COURT MANAGEMENT COMPANY LIMITED?
- Administración de bienes inmobiliarios por cuenta ajena (68320) / Actividades inmobiliarias
¿Dónde se encuentra HITHERCROFT COURT MANAGEMENT COMPANY LIMITED?
Dirección de la sede social | 2 Hithercroft Court Wallingford OX10 9BT Oxfordshire |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de HITHERCROFT COURT MANAGEMENT COMPANY LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
INTERCEDE 801 LIMITED | 05 abr 1990 | 05 abr 1990 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de HITHERCROFT COURT MANAGEMENT COMPANY LIMITED?
Vencido | No |
---|---|
Próximas cuentas | |
Próximo período contable finaliza el | 30 jun 2024 |
Próximas cuentas vencen el | 31 mar 2025 |
Últimas cuentas | |
Últimas cuentas cerradas hasta | 30 jun 2023 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para HITHERCROFT COURT MANAGEMENT COMPANY LIMITED?
Última declaración de confirmación cerrada hasta | 21 mar 2025 |
---|---|
Próxima declaración de confirmación vence | 04 abr 2025 |
Última declaración de confirmación | |
Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 21 mar 2024 |
Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para HITHERCROFT COURT MANAGEMENT COMPANY LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Cese del nombramiento de Peter Charles Edward Woollcott como secretario el 07 may 2024 | 1 páginas | TM02 | ||
Cese del nombramiento de Peter Charles Edward Woollcott como director el 07 may 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 21 mar 2024 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Modification des détails de Chiltern Connections Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 21 mar 2024 | 2 páginas | PSC05 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 jun 2023 | 7 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 21 mar 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cambio de datos del director Mr John Rowland Herring el 28 mar 2023 | 2 páginas | CH01 | ||
Modification des détails de Mr John Rowland Herring en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 28 mar 2023 | 2 páginas | PSC04 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 jun 2022 | 7 páginas | AA | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 jun 2021 | 7 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 21 mar 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 30 jun 2020 | 2 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 21 mar 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 30 jun 2019 | 2 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 21 mar 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 21 mar 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 30 jun 2018 | 2 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 21 mar 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Notification de Chiltern Connections Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016 | 2 páginas | PSC02 | ||
Declaración de confirmación presentada el 21 mar 2017 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Notification de John Rowland Herring en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016 | 2 páginas | PSC01 | ||
Notification de Nicholas Nye en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016 | 2 páginas | PSC01 | ||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 30 jun 2017 | 2 páginas | AA | ||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 30 jun 2016 | 2 páginas | AA | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 jun 2015 | 6 páginas | AA | ||
¿Quiénes son los directivos de HITHERCROFT COURT MANAGEMENT COMPANY LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERRING, John Rowland | Director | 2 Hithercroft Court Wallingford OX10 9BT Oxfordshire | England | British | Company Director | 78277420003 | ||||
NYE, Nicholas | Director | Bezants 33 Winterbrook OX10 9EB Wallingford Oxfordshire | England | British | Managing Director | 83804040001 | ||||
CUFLEY, Sean Dominic Hardy | Secretario | Bank Cottage Haywards Heath Road Balcombe RH17 6NF Haywards Heath West Sussex | British | Chartered Accountant | 9150920001 | |||||
DRAGONETTI, Peter Hugh | Secretario | Covert Cottage Hill Bottom, Whitchurch Hill RG8 7PT Reading Berkshire | British | 64145420001 | ||||||
FAULKS, Howard Stephen | Secretario | 63 Summerleaze Road SL6 8ER Maidenhead Berkshire | British | 33582210001 | ||||||
HIRD, Ian | Secretario | Foxwarren Elmshott Close Penn HP10 8JR High Wycombe Buckinghamshire | British | 7658080001 | ||||||
SLEE, Robert Kenneth | Secretario | Greencourt Sunnydale BR6 8LY Farnborough Kent | British | Property Investor | 76696080001 | |||||
SMITH, Andrew Charles | Secretario | 6 South View Close Codsall WV8 2JD Wolverhampton West Midlands | British | 2899990007 | ||||||
WATSON, Peter Stanley | Secretario | Waterfield Cottage Manor Road RG8 9EN Goring-On-Thames Oxon | British | 6874760002 | ||||||
WATSON, Peter Stanley | Secretario | Waterfield Cottage Manor Road RG8 9EN Goring-On-Thames Oxon | British | 6874760002 | ||||||
WOOLLCOTT, Peter Charles Edward | Secretario | Brindles Bridle Road, Whitchurch RG8 7PR Reading Berkshire | British | Managing Director | 83804200001 | |||||
MITRE SECRETARIES LIMITED | Secretario designado corporativo | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London | 900004680001 | |||||||
ASHENDEN, Andrew | Director | Woodclose 12 Milbourne Lane KT10 9DX Esher Surrey | British | Company Director | 23595530001 | |||||
CLARK, Hugh Victor | Director | 23 Carisbrooke Road Perton WV6 7UU Wolverhampton West Midlands | British | Corporate Treasurer | 38294550001 | |||||
COLLINS, Anthony John | Director | Ashtrees Little Hyde Lane Fryerning CM4 0HJ Ingatestone Essex | England | British | 17457310001 | |||||
CUFLEY, Sean Dominic Hardy | Director | Bank Cottage Haywards Heath Road Balcombe RH17 6NF Haywards Heath West Sussex | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 9150920001 | ||||
DONNELLY, Vincent John | Director | Rosehaugh Estates Plc 17 Welbeck Street W1M 7PF London | British | Company Director | 9447170001 | |||||
DONNELLY, Vincent John | Director | 16 Gomer Place TW11 9AR Teddington Middlesex | British | Company Director | 28938100001 | |||||
KEMP, Christopher Malcolm Henry | Director | The Croft Uttoxeter Road Abbots Bromley WS15 3EQ Rugeley Staffordshire | British | Chartered Accountant | 34030730001 | |||||
LACEY, Gordon James | Director | Paxtons Fairstead Road CM3 2BV Terling Chelmsford Essex | British | Director | 56362710001 | |||||
LOVELL, Stephen Roy | Director | C/O Capricorn Programmes Ltd Hithercroft Court OX10 9BT Wallingford Oxfordshire | British | Managing Director | 36220220001 | |||||
MASON, Terence Harold | Director | Stratton Court Long Common WV5 7AX Claverley Shropshire | England | British | Company Director | 3741500002 | ||||
NESBITT, Andrew Leslie | Director | 9 Manor Road TW9 1YD Richmond Surrey | British | Director | 7462460001 | |||||
ORGAN, Colin | Director | 1 Paddock Close OX10 6RS Benson Oxfordshire | United Kingdom | British | Car Accessory Retailer | 83803970001 | ||||
PELLING, Timothy Gordon | Director | Walnut Tree House Mill Road Shiplake RG9 3LW Henley On Thames Oxfordshire | England | British | Chartered Surveyor | 20364950001 | ||||
REEVES, Barbara | Director designado | Flat 2 24 Bracknell Gardens NW3 7ED London | British | 900004670001 | ||||||
SLEE, Robert Kenneth | Director | The Hayes School Lane, Kilmersdon BA3 5TE Radstock Somerset | United Kingdom | British | Property Investor | 76696080005 | ||||
TWISLETON WYKEHAM FIENNES, Richard George | Director | 54 Haldane Road SW6 7EU London | British | Chartered Surveyor | 78546300001 | |||||
WINDMILL, Robert John | Director designado | 3 Gunter Grove SW10 0UN London | British | 900004660001 | ||||||
WOOLLCOTT, Peter Charles Edward | Director | Brindles Bridle Road, Whitchurch RG8 7PR Reading Berkshire | England | British | Managing Director | 83804200001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de HITHERCROFT COURT MANAGEMENT COMPANY LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mr John Rowland Herring | 06 abr 2016 | 2 Hithercroft Court Wallingford OX10 9BT Oxfordshire | No | ||||||||||
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Mr Nicholas Nye | 06 abr 2016 | 2 Hithercroft Court Wallingford OX10 9BT Oxfordshire | No | ||||||||||
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Chiltern Connections Limited | 06 abr 2016 | Verda Park OX10 9SJ Wallingford 5 Oxfordshire England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0