CHURCHWARD PLC
Visión general
| Nombre de la empresa | CHURCHWARD PLC |
|---|---|
| Estado de la empresa | Liquidación |
| Forma jurídica | Sociedad anónima cotizada |
| Número de empresa | 02489314 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de CHURCHWARD PLC?
- Construcción de edificios comerciales (41201) / Construcción
¿Dónde se encuentra CHURCHWARD PLC?
| Dirección de la sede social | Pwc 8th Floor, Central Square 29 Wellington Street LS1 4DL Leeds West Yorkshire |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CHURCHWARD PLC?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| INTERCEDE 807 LIMITED | 05 abr 1990 | 05 abr 1990 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de CHURCHWARD PLC?
| Vencido | Sí |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2017 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 jun 2018 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2016 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para CHURCHWARD PLC?
| Vencido | Sí |
|---|---|
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 05 abr 2019 |
| Próxima declaración de confirmación vence | 19 abr 2019 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 05 abr 2018 |
| Vencido | Sí |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para CHURCHWARD PLC?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia | 4 páginas | NDISC | ||
Domicilio social registrado cambiado de Crown House Birch Street Wolverhampton WV1 4JX United Kingdom a Pwc 8th Floor, Central Square 29 Wellington Street Leeds West Yorkshire LS1 4DL el 22 jul 2019 | 3 páginas | AD01 | ||
Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia | 4 páginas | NDISC | ||
Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia | 4 páginas | NDISC | ||
Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia | 4 páginas | NDISC | ||
Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia | 4 páginas | NDISC | ||
Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia | 4 páginas | NDISC | ||
Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia | 4 páginas | NDISC | ||
Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia | 4 páginas | NDISC | ||
Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia | 4 páginas | NDISC | ||
Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia | 4 páginas | NDISC | ||
Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia | 4 páginas | NDISC | ||
Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia | 4 páginas | NDISC | ||
Modification des détails de Carillion Construction Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 oct 2018 | 2 páginas | PSC05 | ||
Domicilio social registrado cambiado de Carillion House 84 Salop Street Wolverhampton WV3 0SR a Crown House Birch Street Wolverhampton WV1 4JX el 01 oct 2018 | 1 páginas | AD01 | ||
Cese del nombramiento de Mark William Orriss como director el 18 jun 2018 | 1 páginas | TM01 | ||
Orden del tribunal para liquidar | 2 páginas | COCOMP | ||
Cese del nombramiento de Richard Francis Tapp como secretario el 25 jun 2018 | 1 páginas | TM02 | ||
Cambio de datos del director Mr Mark William Orriss el 25 jun 2018 | 2 páginas | CH01 | ||
Cese del nombramiento de Simon Paul Eastwood como director el 18 jun 2018 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 05 abr 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cambio de datos del director Mr Mark William Orriss el 08 ene 2018 | 2 páginas | CH01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2016 | 14 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 05 abr 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2015 | 14 páginas | AA | ||
¿Quiénes son los directivos de CHURCHWARD PLC?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANKS, Alan Dudley | Secretario | 4 Collison Close SG4 0RE Hitchin Hertfordshire | British | 34802920001 | ||||||
| FITZHUGH, Dirk Olaf | Secretario | Beesdau House Mount Road Tettenhall Wood WV6 8HT Wolverhampton | British | 612090001 | ||||||
| MCCORMACK, James Joseph | Secretario | Broome House Chapel Lane Knockin Heath SY10 8EB Oswestry Shropshire | British | 678610003 | ||||||
| MCEWAN, Euan | Secretario | 2 Bradshaw Close The Fairways PE28 4UZ Brampton Cambridgeshire | British | 110597480001 | ||||||
| SMITH, Andrew Charles | Secretario | 6 South View Close Codsall WV8 2JD Wolverhampton West Midlands | British | 2899990007 | ||||||
| TAPP, Richard Francis | Secretario | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | British | 173852420001 | ||||||
| BAKER, Jeremy | Director | 19 Lynmouth Drive Sully CF64 5TP Penarth South Glamorgan | Wales | British | 19938460005 | |||||
| BANKS, Alan Dudley | Director | 4 Collison Close SG4 0RE Hitchin Hertfordshire | British | 34802920001 | ||||||
| COLLINS, Anthony John | Director | Ashtrees Little Hyde Lane Fryerning CM4 0HJ Ingatestone Essex | England | British | 17457310001 | |||||
| COOPER, Geoffrey Arthur | Director | 17 Chamberlain Road Hanbury Park WR2 4PP St Johns Worcester | British | 9566080001 | ||||||
| CUFLEY, Sean Dominic Hardy | Director | Bank Cottage Haywards Heath Road Balcombe RH17 6NF Haywards Heath West Sussex | United Kingdom | British | 9150920001 | |||||
| EASTWOOD, Simon Paul | Director | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | United Kingdom | British | 35184590004 | |||||
| GIRLING, Christopher Francis | Director | 12 Spithead Close PO34 5AZ Seaview Isle Of Wight | British | 67125270002 | ||||||
| HAMILTON, Michael | Director | 23 Clarence Terrace NW1 4RD London | British | 103460530001 | ||||||
| LEWIS, Judith Ann | Director | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | United Kingdom | British | 288989040001 | |||||
| MCCORMACK, James Joseph | Director | Broome House Chapel Lane Knockin Heath SY10 8EB Oswestry Shropshire | British | 678610003 | ||||||
| MCDONOUGH, John | Director | Birch Street WV1 4HY Wolverhampton 24 West Midlands United Kingdom | Uk | British | 74536340007 | |||||
| MCEWAN, Euan | Director | 2 Bradshaw Close The Fairways PE28 4UZ Brampton Cambridgeshire | British | 110597480001 | ||||||
| MORRISON, Michael John | Director | Colston Bassett Hall Colston Bassett NG12 3FB Nottingham | United Kingdom | British | 8584520002 | |||||
| ORRISS, Mark William | Director | 7-12 Tavistock Street WC1H 9LT London Lynton House, 2nd Floor United Kingdom | England | British | 77169180001 | |||||
| PELLARD, Brian | Director | 33 Wyvern Road B74 2PS Sutton Coldfield West Midlands | British | 33408310001 | ||||||
| REEVES, Steven Keith | Director | Darragh House, Burnt Oak Lane Newdigate RH5 5BJ Dorking Surrey | United Kingdom | British | 33796110001 | |||||
| ROBINSON, Roger William | Director | Applewood Barn Bank Road Little Witley WR6 6LS Worcester Worcestershire | British | 33421810001 | ||||||
| SHARPLES, Bernard John | Director | Old Meadow Stockton Road WR6 6AT Abberley Worcestershire | United Kingdom | British | 36242390003 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de CHURCHWARD PLC?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carillion Construction Limited | 06 abr 2016 | Birch Street WV1 4JX Wolverhampton Crown House United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene CHURCHWARD PLC alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Fixed and floating charge | Creado el 08 nov 1990 Entregado el 12 nov 1990 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Breve descripción Land at churchward swindon wilts (part of the former brel site). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Fixed and floating charge | Creado el 08 nov 1990 Entregado el 12 nov 1990 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 29/6/90 and/or the charge | |
Breve descripción All that f/hold land & buildings erected thereon or on part(s) thereof situate at swindon wilts comprising 38.64 acres t/n :- wt 68801. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene CHURCHWARD PLC algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación forzosa |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0