ANDRE BALDET LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaANDRE BALDET LIMITED
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02489508
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenesNo
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de ANDRE BALDET LIMITED?

    • Venta de coches nuevos y vehículos de motor ligeros (45111) / Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas
    • Venta de coches usados y vehículos de motor ligeros (45112) / Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas

    ¿Dónde se encuentra ANDRE BALDET LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Loxley House 2 0akwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ANDRE BALDET LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    HIREMATCH LIMITED05 abr 199005 abr 1990

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de ANDRE BALDET LIMITED?

    VencidoNo
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el31 dic 2025
    Próximas cuentas vencen el30 sept 2026
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2024

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para ANDRE BALDET LIMITED?

    Última declaración de confirmación cerrada hasta31 mar 2026
    Próxima declaración de confirmación vence14 abr 2026
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta31 mar 2025
    VencidoNo

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para ANDRE BALDET LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2024

    6 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 31 mar 2025 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Exercice comptable précédent raccourci du 31 ene 2025 au 31 dic 2024

    1 páginasAA01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 ene 2024

    7 páginasAA

    Nombramiento de Mr Richard John Thomas como director el 02 sept 2024

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Richard James Maloney como director el 01 jul 2024

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Mark Simon Willis como director el 28 jun 2024

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 31 mar 2024 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Mr Neil Williamson como director el 01 feb 2024

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de William Berman como director el 31 ene 2024

    1 páginasTM01

    Exercice comptable précédent prolongé du 31 dic 2023 au 31 ene 2024

    1 páginasAA01

    Cancelación total de la carga 024895080026

    4 páginasMR04

    Cese del nombramiento de Martin Shaun Casha como director el 07 oct 2023

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2022

    7 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 31 mar 2023 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2021

    7 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 31 mar 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Registro de la carga 024895080026, creada el 18 mar 2022

    74 páginasMR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2020

    7 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 31 mar 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2019

    7 páginasAA

    Nombramiento de Mr William Berman como director el 09 abr 2020

    2 páginasAP01

    Declaración de confirmación presentada el 31 mar 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2018

    7 páginasAA

    Cese del nombramiento de Mark Philip Herbert como director el 30 jun 2019

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de ANDRE BALDET LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MALONEY, Richard James
    Loxley House 2 0akwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Secretario
    Loxley House 2 0akwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    British110894220002
    MALONEY, Richard James
    Loxley House 2 0akwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Director
    Loxley House 2 0akwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritish319094660001
    THOMAS, Richard John
    Loxley House 2 0akwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Director
    Loxley House 2 0akwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritish327027470001
    WILLIAMSON, Neil
    Loxley House 2 0akwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Director
    Loxley House 2 0akwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritish319092180001
    PENDRAGON MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    2 Oakwood Court
    Little Oak Drive
    NG15 0DR Annesley
    Loxley House
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Director corporativo
    2 Oakwood Court
    Little Oak Drive
    NG15 0DR Annesley
    Loxley House
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónSociedad limitada del Reino Unido
    Número de registro2304195
    110674970001
    BENNETT, Michael Ronald
    2 Kentmere Road
    HP21 7HZ Aylesbury
    Buckinghamshire
    Secretario
    2 Kentmere Road
    HP21 7HZ Aylesbury
    Buckinghamshire
    British75618940001
    BOOTH, Brenda
    62 Redesmere Park
    Urmston
    M41 9EP Manchester
    Lancashire
    Secretario
    62 Redesmere Park
    Urmston
    M41 9EP Manchester
    Lancashire
    British16249170005
    CUNNINGTON, Dorothy Mabel
    192 Park Lane
    Duston
    NN5 6QW Northampton
    Northamptonshire
    Secretario
    192 Park Lane
    Duston
    NN5 6QW Northampton
    Northamptonshire
    British11936780001
    DANNHAUSER, David Stephen
    28 Carrington Square
    HA3 6TF Harrow
    Middlesex
    Secretario
    28 Carrington Square
    HA3 6TF Harrow
    Middlesex
    British55176170002
    ELLISON, Martin Edward
    1a Longcroft Avenue
    AL5 2QY Harpenden
    Hertfordshire
    Secretario
    1a Longcroft Avenue
    AL5 2QY Harpenden
    Hertfordshire
    British97753620001
    HOLROYD, John
    Arncliffe House Farm
    Starbotton
    BD23 5HY Skipton
    North Yorkshire
    Secretario
    Arncliffe House Farm
    Starbotton
    BD23 5HY Skipton
    North Yorkshire
    British21483450001
    LINTOTT, Graham Gordon
    Hatch House Thorndon Park
    Herongate
    CM13 3SA Brentwood
    Essex
    Secretario
    Hatch House Thorndon Park
    Herongate
    CM13 3SA Brentwood
    Essex
    British57169010001
    PERRY, Brian
    46 Marlborough Avenue
    Cheadle Hulme
    SK8 7AW Cheadle
    Cheshire
    Secretario
    46 Marlborough Avenue
    Cheadle Hulme
    SK8 7AW Cheadle
    Cheshire
    British10759770001
    SYKES, Hilary Claire
    Loxley House 2 0akwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Secretario
    Loxley House 2 0akwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    British41559790001
    ANDREWS, Giles Edward Charles
    Flat 36 50 Narrow Street
    E14 8BP London
    Director
    Flat 36 50 Narrow Street
    E14 8BP London
    British37743280001
    BALDET, Andre Georges Jean
    Stone Gables High Street
    Milton Malsor
    NN7 3AS Northampton
    Northamptonshire
    Director
    Stone Gables High Street
    Milton Malsor
    NN7 3AS Northampton
    Northamptonshire
    French46302120001
    BALDET-CLARK, Andrea Hilary
    1 Manor Cottage
    Quinton
    NN7 2EF Northampton
    Northamptonshire
    Director
    1 Manor Cottage
    Quinton
    NN7 2EF Northampton
    Northamptonshire
    British11936800001
    BARBER, Richard Charles
    Dancer's End Lodge
    Dancers End
    HP23 6JY Tring
    Hertfordshire
    Director
    Dancer's End Lodge
    Dancers End
    HP23 6JY Tring
    Hertfordshire
    British34307140002
    BERMAN, William
    Loxley House 2 0akwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Director
    Loxley House 2 0akwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    United StatesAmerican258126160001
    BIGGS, Anthony Mark
    Lime Tree House
    2 Braddens Furlong
    HP18 9BL Long Crendon
    Buckinghamshire
    Director
    Lime Tree House
    2 Braddens Furlong
    HP18 9BL Long Crendon
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish46681000002
    BRAMALL, Douglas Charles Antony
    Warren Farm Warren Lane
    Brearton
    HG3 3DB Harrogate
    Director
    Warren Farm Warren Lane
    Brearton
    HG3 3DB Harrogate
    United KingdomBritish29331220001
    BROWN, Angus Lushington Wylie
    2 Rockford Lodge
    WA16 8AH Knutsford
    Cheshire
    Director
    2 Rockford Lodge
    WA16 8AH Knutsford
    Cheshire
    British10759780001
    CASHA, Martin Shaun
    Loxley House 2 0akwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Director
    Loxley House 2 0akwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish41114490010
    DAVIS, Andrew Michael
    57 Lache Lane
    CH4 7LP Chester
    Cheshire
    Director
    57 Lache Lane
    CH4 7LP Chester
    Cheshire
    United KingdomBritish63557750001
    DAY, John Osborne
    5 Camellia Way
    Simons Park
    RG41 3NB Wokingham
    Berkshire
    Director
    5 Camellia Way
    Simons Park
    RG41 3NB Wokingham
    Berkshire
    British76450060001
    EGERTON, Peter John
    The Wilderness
    Lea Laughton Horton
    ST13 8PZ Rudyard
    Staffordshire
    Director
    The Wilderness
    Lea Laughton Horton
    ST13 8PZ Rudyard
    Staffordshire
    British17294880001
    ELLISON, Martin Edward
    1a Longcroft Avenue
    AL5 2QY Harpenden
    Hertfordshire
    Director
    1a Longcroft Avenue
    AL5 2QY Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritish97753620001
    FINN, Trevor Garry
    Loxley House 2 0akwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Director
    Loxley House 2 0akwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish2652610013
    FORSYTH, David Robertson
    Scotland Cottage
    Melbourne
    DE73 1BH Derby
    Director
    Scotland Cottage
    Melbourne
    DE73 1BH Derby
    United KingdomBritish55127120002
    HERBERT, Mark Philip
    Loxley House 2 0akwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Director
    Loxley House 2 0akwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritish123285980005
    HOLDEN, Timothy Paul
    Loxley House 2 0akwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Director
    Loxley House 2 0akwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritish148034310003
    HOLROYD, John
    Arncliffe House Farm
    Starbotton
    BD23 5HY Skipton
    North Yorkshire
    Director
    Arncliffe House Farm
    Starbotton
    BD23 5HY Skipton
    North Yorkshire
    British21483450001
    LINTOTT, Graham Gordon
    Hatch House Thorndon Park
    Herongate
    CM13 3SA Brentwood
    Essex
    Director
    Hatch House Thorndon Park
    Herongate
    CM13 3SA Brentwood
    Essex
    British57169010001
    MURRAY, Alec Barclay
    24 Harrop Road
    Hale
    WA15 9DQ Altrincham
    Cheshire
    Director
    24 Harrop Road
    Hale
    WA15 9DQ Altrincham
    Cheshire
    United KingdomBritish163818290001
    NERDRUM, Arild
    30 Carlton Hill
    NW8 0JY London
    Director
    30 Carlton Hill
    NW8 0JY London
    Norwegian4137560001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de ANDRE BALDET LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Bramall Quicks Limited
    Little Oak Drive
    Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Loxley House
    England
    06 abr 2016
    Little Oak Drive
    Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Loxley House
    England
    No
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroEngland & Wales
    Número de registro158215
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0