BARHAM REORGANISATIONS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | BARHAM REORGANISATIONS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02489731 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de BARHAM REORGANISATIONS LIMITED?
- Otras actividades de apoyo a los negocios n.c.p. (82990) / Actividades administrativas y de apoyo
¿Dónde se encuentra BARHAM REORGANISATIONS LIMITED?
| Dirección de la sede social | Mortimer House 37-41 Mortimer Street W1T 3JH London |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de BARHAM REORGANISATIONS LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| INTERCEDE 830 LIMITED | 05 abr 1990 | 05 abr 1990 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de BARHAM REORGANISATIONS LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2011 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para BARHAM REORGANISATIONS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 05 abr 2013 avec liste complète des actionnaires | 8 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cambio de datos del director Mr Adam Christopher Walker el 01 mar 2013 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Emily Louise Martin el 03 ago 2012 | 2 páginas | CH03 | ||||||||||
Estado de capital el 26 jul 2012
| 4 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 2 páginas | SH20 | ||||||||||
legacy | 2 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 05 abr 2012 avec liste complète des actionnaires | 8 páginas | AR01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2011 | 15 páginas | AA | ||||||||||
Cambio de datos del director Rupert John Joseph Hopley el 01 mar 2012 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Nombramiento de Rupert John Joseph Hopley como director el 01 nov 2011 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Rachel Elizabeth Jacobs como director el 16 sept 2011 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de John William Burton como director el 31 ago 2011 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Gareth Richard Wright el 19 ago 2011 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Nombramiento de Emily Louise Martin como secretario | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2010 | 14 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 05 abr 2011 avec liste complète des actionnaires | 9 páginas | AR01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Mark Kerswell como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Peter Stephen Rigby el 05 oct 2010 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Adam Christopher Walker el 05 oct 2010 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Miss Julie Louise Wilson el 27 sept 2010 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2009 | 16 páginas | AA | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de BARHAM REORGANISATIONS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTIN, Emily Louise | Secretario | 37-41 Mortimer Street W1T 3JH London Mortimer House United Kingdom | 160502420001 | |||||||
| WOOLLARD, Julie Louise | Secretario | 37/41 Mortimer Street W1T 3JH London Mortimer House England | British | 139159370002 | ||||||
| HOPLEY, Rupert John Joseph | Director | 6300 Zug Gubelstrasse 11 Switzerland | Switzerland | British | 164632060002 | |||||
| RIGBY, Peter Stephen | Director | 37/41 Mortimer Street W1T 3JH London Mortimer House England | Switzerland | British | 69164290007 | |||||
| WALKER, Adam Christopher | Director | 37/41 Mortimer Street W1T 3JH London Mortimer House England | Switzerland | British | 129368430003 | |||||
| WRIGHT, Gareth Richard | Director | 37/41 Mortimer Street W1T 3JH London Mortimer House England | England | British | 131115190002 | |||||
| CALLABY, Andrea Mary | Secretario | 5 Thornton Drive CO4 5WB Colchester Essex | British | 70352690002 | ||||||
| HAYWARD, Pearl Catherine | Secretario | 60 Idmiston Square KT4 7SY Worcester Park Surrey | British | 61319730001 | ||||||
| LODGE, David William | Secretario | 19 Windermere Drive CM7 8UB Braintree Essex | British | 10640040001 | ||||||
| PEACH, Inez Mary | Secretario | Silverwood Station Road Semley SP7 9AH Shaftesbury Dorset | British | 9976010001 | ||||||
| RICHMOND, Sonia Anna | Secretario | 8 Viscount Gardens KT14 6HE Byfleet Surrey | British | 118535490002 | ||||||
| WHITE, Teresa Catherine | Secretario | 2 Cuckoo Dene W7 3DP London | British | 65724350001 | ||||||
| WITHERS, John Martin | Secretario | High Trees Farm 2 Lexden Road West Bergholt CO6 3BT Colchester Essex | British | 41682250002 | ||||||
| BURTON, John William | Director | Mortimer House 37-41 Mortimer Street W1T 3JH London | United Kingdom | British | 113684810001 | |||||
| CROPPER, Anthony Graham | Director | Meadow House Moules Lane Hadstock CB21 4PD Cambridge Cambridgeshire | England | British | 8664640001 | |||||
| FOYE, Anthony Martin | Director | Lynwood White Lane RG26 5TN Hannington Hampshire | United Kingdom | British | 99515780001 | |||||
| GILBERTSON, David Stuart | Director | Casa Maria Spaniard's End Hampstead NW3 7JG London | United Kingdom | British | 10921820004 | |||||
| JACOBS, Rachel Elizabeth | Director | 37/41 Mortimer Street W1T 3JH London Mortimer House England | United Kingdom | British | 92334500004 | |||||
| KERSWELL, Mark Henry | Director | 37/41 Mortimer Street W1T 3JH London Mortimer House England | England | British | 82609620003 | |||||
| SHUKER, Anne | Director | 215e Elgin Avenue W9 1NH London | British | 47170320001 | ||||||
| WILKINSON, James Henry | Director | 2 The Nursery Sutton Courtenay OX14 4UA Abingdon Oxfordshire | United Kingdom | British | 56006210002 | |||||
| WITHERS, John Martin | Director | High Trees Farm 2 Lexden Road West Bergholt CO6 3BT Colchester Essex | British | 41682250002 | ||||||
| WYLES, Rhona Irene | Director | 43 Blomfield Road W9 2PF London | British | 51215380001 |
¿Tiene BARHAM REORGANISATIONS LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Security document | Creado el 29 mar 1996 Entregado el 15 abr 1996 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the guarantee (as defined) | |
Breve descripción Charge of all sums of money which may now or in future be deposited in the name of the company in account number: 37356992, sort code: 40-05-15, ref: midland bank re barham reorganisations limited ("the account") with the bank, together with all interest accruing thereon from time to time. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Security document | Creado el 28 dic 1995 Entregado el 05 ene 1996 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of each financing document (as defined) | |
Breve descripción The shares being 3 ordinary shares in ibc (overseas investments) limited and by way of first floating charge all its asseyts not charged in para.1 Of the mortgage. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Acquisition of property | Creado el 07 oct 1994 Adquirido el 21 dic 1995 Entregado el 11 ene 1996 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada The secured liabilities (as defined in the security document dated 7TH october 1994) | |
Breve descripción All shares and a floating charge over the assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0