BARHAM REORGANISATIONS LIMITED

BARHAM REORGANISATIONS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaBARHAM REORGANISATIONS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02489731
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de BARHAM REORGANISATIONS LIMITED?

    • Otras actividades de apoyo a los negocios n.c.p. (82990) / Actividades administrativas y de apoyo

    ¿Dónde se encuentra BARHAM REORGANISATIONS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Mortimer House
    37-41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de BARHAM REORGANISATIONS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    INTERCEDE 830 LIMITED05 abr 199005 abr 1990

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de BARHAM REORGANISATIONS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2011

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para BARHAM REORGANISATIONS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Déclaration annuelle établie au 05 abr 2013 avec liste complète des actionnaires

    8 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital25 abr 2013

    Estado de capital el 25 abr 2013

    • Capital: GBP 101
    SH01

    Cambio de datos del director Mr Adam Christopher Walker el 01 mar 2013

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del secretario Emily Louise Martin el 03 ago 2012

    2 páginasCH03

    Estado de capital el 26 jul 2012

    • Capital: GBP 101
    4 páginasSH19

    legacy

    2 páginasSH20

    legacy

    2 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Reduction of share premium account 19/07/2012
    RES13

    Déclaration annuelle établie au 05 abr 2012 avec liste complète des actionnaires

    8 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2011

    15 páginasAA

    Cambio de datos del director Rupert John Joseph Hopley el 01 mar 2012

    2 páginasCH01

    Nombramiento de Rupert John Joseph Hopley como director el 01 nov 2011

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Rachel Elizabeth Jacobs como director el 16 sept 2011

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de John William Burton como director el 31 ago 2011

    1 páginasTM01

    Cambio de datos del director Mr Gareth Richard Wright el 19 ago 2011

    2 páginasCH01

    Nombramiento de Emily Louise Martin como secretario

    2 páginasAP03

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2010

    14 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 05 abr 2011 avec liste complète des actionnaires

    9 páginasAR01

    Cese del nombramiento de Mark Kerswell como director

    1 páginasTM01

    Cambio de datos del director Mr Peter Stephen Rigby el 05 oct 2010

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Adam Christopher Walker el 05 oct 2010

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del secretario Miss Julie Louise Wilson el 27 sept 2010

    1 páginasCH03

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2009

    16 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de BARHAM REORGANISATIONS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MARTIN, Emily Louise
    37-41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    United Kingdom
    Secretario
    37-41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    United Kingdom
    160502420001
    WOOLLARD, Julie Louise
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    Secretario
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    British139159370002
    HOPLEY, Rupert John Joseph
    6300 Zug
    Gubelstrasse 11
    Switzerland
    Director
    6300 Zug
    Gubelstrasse 11
    Switzerland
    SwitzerlandBritish164632060002
    RIGBY, Peter Stephen
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    Director
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    SwitzerlandBritish69164290007
    WALKER, Adam Christopher
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    Director
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    SwitzerlandBritish129368430003
    WRIGHT, Gareth Richard
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    Director
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    EnglandBritish131115190002
    CALLABY, Andrea Mary
    5 Thornton Drive
    CO4 5WB Colchester
    Essex
    Secretario
    5 Thornton Drive
    CO4 5WB Colchester
    Essex
    British70352690002
    HAYWARD, Pearl Catherine
    60 Idmiston Square
    KT4 7SY Worcester Park
    Surrey
    Secretario
    60 Idmiston Square
    KT4 7SY Worcester Park
    Surrey
    British61319730001
    LODGE, David William
    19 Windermere Drive
    CM7 8UB Braintree
    Essex
    Secretario
    19 Windermere Drive
    CM7 8UB Braintree
    Essex
    British10640040001
    PEACH, Inez Mary
    Silverwood Station Road
    Semley
    SP7 9AH Shaftesbury
    Dorset
    Secretario
    Silverwood Station Road
    Semley
    SP7 9AH Shaftesbury
    Dorset
    British9976010001
    RICHMOND, Sonia Anna
    8 Viscount Gardens
    KT14 6HE Byfleet
    Surrey
    Secretario
    8 Viscount Gardens
    KT14 6HE Byfleet
    Surrey
    British118535490002
    WHITE, Teresa Catherine
    2 Cuckoo Dene
    W7 3DP London
    Secretario
    2 Cuckoo Dene
    W7 3DP London
    British65724350001
    WITHERS, John Martin
    High Trees Farm
    2 Lexden Road West Bergholt
    CO6 3BT Colchester
    Essex
    Secretario
    High Trees Farm
    2 Lexden Road West Bergholt
    CO6 3BT Colchester
    Essex
    British41682250002
    BURTON, John William
    Mortimer House
    37-41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Director
    Mortimer House
    37-41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    United KingdomBritish113684810001
    CROPPER, Anthony Graham
    Meadow House
    Moules Lane Hadstock
    CB21 4PD Cambridge
    Cambridgeshire
    Director
    Meadow House
    Moules Lane Hadstock
    CB21 4PD Cambridge
    Cambridgeshire
    EnglandBritish8664640001
    FOYE, Anthony Martin
    Lynwood
    White Lane
    RG26 5TN Hannington
    Hampshire
    Director
    Lynwood
    White Lane
    RG26 5TN Hannington
    Hampshire
    United KingdomBritish99515780001
    GILBERTSON, David Stuart
    Casa Maria
    Spaniard's End Hampstead
    NW3 7JG London
    Director
    Casa Maria
    Spaniard's End Hampstead
    NW3 7JG London
    United KingdomBritish10921820004
    JACOBS, Rachel Elizabeth
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    Director
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    United KingdomBritish92334500004
    KERSWELL, Mark Henry
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    Director
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    EnglandBritish82609620003
    SHUKER, Anne
    215e Elgin Avenue
    W9 1NH London
    Director
    215e Elgin Avenue
    W9 1NH London
    British47170320001
    WILKINSON, James Henry
    2 The Nursery
    Sutton Courtenay
    OX14 4UA Abingdon
    Oxfordshire
    Director
    2 The Nursery
    Sutton Courtenay
    OX14 4UA Abingdon
    Oxfordshire
    United KingdomBritish56006210002
    WITHERS, John Martin
    High Trees Farm
    2 Lexden Road West Bergholt
    CO6 3BT Colchester
    Essex
    Director
    High Trees Farm
    2 Lexden Road West Bergholt
    CO6 3BT Colchester
    Essex
    British41682250002
    WYLES, Rhona Irene
    43 Blomfield Road
    W9 2PF London
    Director
    43 Blomfield Road
    W9 2PF London
    British51215380001

    ¿Tiene BARHAM REORGANISATIONS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Security document
    Creado el 29 mar 1996
    Entregado el 15 abr 1996
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the guarantee (as defined)
    Breve descripción
    Charge of all sums of money which may now or in future be deposited in the name of the company in account number: 37356992, sort code: 40-05-15, ref: midland bank re barham reorganisations limited ("the account") with the bank, together with all interest accruing thereon from time to time. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 15 abr 1996Registro de un cargo (395)
    Security document
    Creado el 28 dic 1995
    Entregado el 05 ene 1996
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of each financing document (as defined)
    Breve descripción
    The shares being 3 ordinary shares in ibc (overseas investments) limited and by way of first floating charge all its asseyts not charged in para.1 Of the mortgage. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Samuel Montagu & Co. Limited
    Transacciones
    • 05 ene 1996Registro de un cargo (395)
    Acquisition of property
    Creado el 07 oct 1994
    Adquirido el 21 dic 1995
    Entregado el 11 ene 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    The secured liabilities (as defined in the security document dated 7TH october 1994)
    Breve descripción
    All shares and a floating charge over the assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Samuel Montagu & Co. Limited
    Transacciones
    • 11 ene 1996Registro de una adquisición (400)
    • 18 jun 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0