SOVEREIGN QUAY LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | SOVEREIGN QUAY LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02493276 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de SOVEREIGN QUAY LIMITED?
- Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción
¿Dónde se encuentra SOVEREIGN QUAY LIMITED?
| Dirección de la sede social | 8th Floor The Point 37 North Wharf Road W2 1AF London United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SOVEREIGN QUAY LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| SIMCO 323 LIMITED | 18 abr 1990 | 18 abr 1990 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de SOVEREIGN QUAY LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2019 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para SOVEREIGN QUAY LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 1 páginas | DS01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Nicholas Keith Chevis el 23 jun 2020 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Silvana Nerina Glibota-Vigo como secretario el 31 jul 2020 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 02 jun 2020 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
legacy | 2 páginas | SH20 | ||||||||||
Estado de capital el 28 may 2020
| 5 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 2 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2019 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mrs Silvana Nerina Glibota-Vigo como secretario el 15 nov 2019 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Michael Hampson como secretario el 14 nov 2019 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 02 jun 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2018 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 02 jun 2018 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2017 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 50 Eastbourne Terrace Paddington London W2 6LG a 8th Floor the Point 37 North Wharf Road London W2 1AF el 04 dic 2017 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 02 jun 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Ronald David James Maher como director el 08 may 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Stuart Parker como director el 08 may 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Jayne Elizabeth Maclennan como director el 31 mar 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Ronald David James Maher como director el 31 mar 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2016 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr Michael Hampson como secretario el 22 jul 2016 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de SOVEREIGN QUAY LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVIS, Nicholas Keith | Director | King Street AB24 5RP Aberdeen 395 | England | British | 52041130003 | |||||
| PARKER, Stuart | Director | King Street AB24 5RP Aberdeen 395 United Kingdom | England | British | 231121360001 | |||||
| BARRIE, Sidney | Secretario | King Street AB24 5RP Aberdeen 395 | British | 86630001 | ||||||
| GLIBOTA-VIGO, Silvana Nerina | Secretario | King Street AB24 5RP Aberdeen 395 Scotland | 264608240001 | |||||||
| GOULDING, Lorraine | Secretario | 29 Churchgate Gildersome Morley LS27 7HA Leeds | British | 37391500001 | ||||||
| HAMPSON, Michael | Secretario | King Street AB24 5RP Aberdeen 395 United Kingdom | 215923870001 | |||||||
| LEWIS, Paul Michael | Secretario | King Street AB24 5RP Aberdeen 395 United Kingdom | 162172470001 | |||||||
| RUPPEL, Brenda Louise | Secretario | 26 Broadhinton Road SW4 0LT London | British | 59744930003 | ||||||
| WARD, David John | Secretario | Top Flat 27 Cotham Grove Cotham BS6 6AN Bristol | British | 1535540001 | ||||||
| WELCH, Robert John | Secretario | King Street AB24 5RP Aberdeen 395 Scotland | 188654750001 | |||||||
| WRIGHT, Richard David | Secretario | 124 Old Street BS21 6BJ Clevedon North Somerset | British | 56778740001 | ||||||
| AHLERS, Keith Norman | Director | 7 Burnbrae Road West Parley BH22 8RL Wimborne Dorset | British | 12092360001 | ||||||
| BARRIE, Sidney | Director | King Street AB24 5RP Aberdeen 395 United Kingdom | Scotland | British | 86630001 | |||||
| BOWER, John Rolove | Director | 11 Beaumont Road Off Bench Lane Darton S75 5JL Barnsley South Yorkshire | British | 36336720001 | ||||||
| BROWLEE, George William | Director | 118 Huddersfield Road HD6 3RH Brighouse W Yorkshire | British | 27668030001 | ||||||
| BUCHAN, Ian James | Director | 1a Church Terrace Scissett HD8 9JT Huddersfield West Yorkshire | British | 33597610001 | ||||||
| BUCHAN, Ian James | Director | 1a Church Terrace Scissett HD8 9JT Huddersfield West Yorkshire | British | 33597610001 | ||||||
| DUNCAN, Robert Alexander | Director | 21 Rubislaw Den South AB15 4BD Aberdeen Scotland | British | 48510002 | ||||||
| FINCH, Dean Kendal | Director | Corrachree House Tarland AB34 4UP Aboyne | United Kingdom | British | 99214880001 | |||||
| LANAGHAN, Iain Malcolm, Mr. | Director | Ernan Lodge 82 Beechgrove Terrace AB15 5EY Aberdeen | Scotland | British | 58524600004 | |||||
| LAWSON, Derek Edgar | Director | 74 Easter Bankton EH54 9BE Livingston West Lothian | British | 1099420001 | ||||||
| LEWIS, Richard Anthony | Director | Northlands 10 Lacey Street Horbury WF4 5HP Wakefield West Yorkshire | England | British | 34902060001 | |||||
| LEWIS, Richard Anthony | Director | Northlands 10 Lacey Street Horbury WF4 5HP Wakefield West Yorkshire | England | British | 34902060001 | |||||
| MACLENNAN, Jayne Elizabeth | Director | King Street AB24 5RP Aberdeen 395 | Scotland | British | 116899720001 | |||||
| MAHER, Ronald David James | Director | King Street AB24 5RP Aberdeen 395 United Kingdom | United Kingdom | British | 228999180001 | |||||
| MCLAUGHLIN, James, Mr. | Director | Snow Meadow Barn Middle Stoughton BS28 4PT Wedmore Somerset | Uk | British | 107447050001 | |||||
| OSBALDISTON, John Anthony | Director | Ashley House Manor Road HP10 8HY Penn Buckinghamshire | England | British | 100098300001 | |||||
| SMALLWOOD, Trevor | Director | Bramble Cottage Dinghurst Road BS25 5PJ Churchill North Somerset | United Kingdom | British | 1535550001 | |||||
| SMALLWOOD, Trevor | Director | Bramble Cottage Dinghurst Road BS25 5PJ Churchill North Somerset | United Kingdom | British | 1535550001 | |||||
| WHITE, Philip Michael | Director | 257 Abbeydale Road South Dore S17 3LB Sheffield South Yorkshire | British | 5721830001 | ||||||
| WHITE, Philip Michael | Director | 257 Abbeydale Road South Dore S17 3LB Sheffield South Yorkshire | British | 5721830001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de SOVEREIGN QUAY LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rider Holdings Limited | 06 abr 2016 | Donisthorpe Street LS10 1PL Leeds Hunslet Park Depot West Yorkshire England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene SOVEREIGN QUAY LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Mortgage debenture | Creado el 21 jul 1993 Entregado el 27 jul 1993 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 14 feb 1992 Entregado el 26 feb 1992 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £75,250 due from the company to rider holdings limited under the terms of the charge. | |
Breve descripción 7 bridge end leeds west yorkshire registered at h m land registry under t/n wyk 331022. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0