HOZELOCK GROUP LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | HOZELOCK GROUP LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02496708 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de HOZELOCK GROUP LIMITED?
- fabricación de otros productos de plástico (22290) / Industrias manufactureras
¿Dónde se encuentra HOZELOCK GROUP LIMITED?
| Dirección de la sede social | Midpoint Park Minworth B76 1AB Sutton Coldfield |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de HOZELOCK GROUP LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| FLYVILLE LIMITED | 27 abr 1990 | 27 abr 1990 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de HOZELOCK GROUP LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 sept 2019 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para HOZELOCK GROUP LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida | 1 páginas | SOAS(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 1 páginas | DS01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 21 abr 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Yves Emile Pierre Belegaud como director el 17 dic 2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cessation de Guerric Ballu en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 17 dic 2019 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Guerric Ballu como director el 17 dic 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2019 | 20 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 21 abr 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2018 | 18 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 21 abr 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2017 | 18 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr Emmanuel Julien Perrousset como secretario el 30 nov 2017 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Gary Thorington Jones como secretario el 30 nov 2017 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 21 abr 2017 con actualizaciones | 6 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2016 | 15 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 21 abr 2016 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nombramiento de Mr Gary Thorington Jones como secretario el 24 mar 2016 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Helen Semmens como secretario el 23 mar 2016 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Exercice comptable en cours prolongé du 31 ago 2016 au 30 sept 2016 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 ago 2015 | 13 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr Helen Semmens como secretario el 01 ago 2015 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 ago 2014 | 14 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 21 abr 2015 avec liste complète des actionnaires | 3 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de HOZELOCK GROUP LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERROUSSET, Emmanuel Julien | Secretario | Midpoint Park Minworth B76 1AB Sutton Coldfield | 240709370001 | |||||||
| BALLU, Marc | Director | Midpoint Park Minworth B76 1AB Sutton Coldfield | United Kingdom | French | 174120160002 | |||||
| BELEGAUD, Yves Emile Pierre | Director | Midpoint Park Minworth B76 1AB Sutton Coldfield | France | French | 265689980001 | |||||
| JONES, Gary Thorington | Secretario | Midpoint Park Minworth B76 1AB Sutton Coldfield | 207074230001 | |||||||
| POTTER, Donald Stanley | Secretario | Crispins 64 The Avenue Worminghall HP18 9LE Aylesbury Buckinghamshire | British | 14077190001 | ||||||
| SEMMENS, Helen | Secretario | Midpoint Park Minworth B76 1AB Sutton Coldfield | 199904670001 | |||||||
| WOOD, Martin | Secretario | Midpoint Park Minworth B76 1AB Sutton Coldfield | 153428180001 | |||||||
| ADAMS, Peter George | Director | Lower Northcott Farm Sheldon EX15 2JF Cullompton Devon | British | 112143030001 | ||||||
| ALGAR, David Stanley | Director | Midpoint Park Minworth B76 1AB Sutton Coldfield | England | British | 104137450004 | |||||
| BALLU, Guerric | Director | Midpoint Park Minworth B76 1AB Sutton Coldfield | France | French | 80574650002 | |||||
| CODLING, David Fletcher | Director | Bowers Farm Magpie Lane HP7 0LU Coleshill Amersham Buckinghamshire | British | 14064770002 | ||||||
| DUDEK, Michael Henry | Director | Walnut Tree Cottage Walton Lane Wellesbourne CV35 9RD Warwickshire | British | 39236340002 | ||||||
| FEWELL, Peter William Charles | Director | Mount Pleasant Farm Thame Road OX44 7HX Great Milton Oxon | British | 14037250003 | ||||||
| FLEURAT, Pierre | Director | 9 Avenue Elisee Reclus FOREIGN 75007 Paris France | French | 72217940002 | ||||||
| FOBEL, Anthony Peter | Director | 1st Floor Flat 105 King Henrys Road NW3 3QX London | British | 71917500001 | ||||||
| HALL, Stephen John | Director | Adringal Cottages Horton Horton Hill BS37 6QP Bristol 1 | England | British | 147526740001 | |||||
| HARGREAVES, David | Director | Willards Farm The Common Dunsfold GU8 4LB Godalming Surrey | British | 54809160001 | ||||||
| HART, Raymond John | Director | Witches Broom Raggleswood BR7 5NH Chislehurst Kent | British | 63042500002 | ||||||
| MACKENZIE, Alexander Donald | Director | Shalden Lodge Shalden Lane Shalden GU34 4DU Alton Hampshire | United Kingdom | British | 105120270001 | |||||
| MASKELL, Philip John | Director | 1 Grange Cottages Broad Common Road RG10 0RD Hurst Berkshire | British | 5733160002 | ||||||
| POTTER, Donald Stanley | Director | Crispins 64 The Avenue Worminghall HP18 9LE Aylesbury Buckinghamshire | England | British | 14077190001 | |||||
| ROLLAND, Stuart Stacy | Director | Rosemary Cottage Northchurch HP4 3QS Berkhamsted Hertfordshire | United Kingdom | British | 206839450001 | |||||
| RUSH, Peter John | Director | 2 The Conifers Birches Lane CV8 2BF Kenilworth Warwickshire | England | British | 94039640002 | |||||
| SNOWDEN, Paul Boothby | Director | 10 Dunton Close Four Oaks B75 5QD Sutton Coldfield Birmingham | British | 69874210002 | ||||||
| WALKER, Gerald Neill | Director | The Laurels 5 Aston Gardens Aston Rowant OX49 5SY Watlington Oxfordshire | British | 84568760001 | ||||||
| WOOD, Martin Richard | Director | Midpoint Park Minworth B76 1AB Sutton Coldfield | England | British | 152495780001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de HOZELOCK GROUP LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado |
|---|---|---|---|
| Mr Guerric Ballu | 06 abr 2016 | Midpoint Park Minworth B76 1AB Sutton Coldfield | Sí |
Nacionalidad: French País de residencia: France | |||
Naturaleza del control
| |||
| Mr Marc Ballu | 06 abr 2016 | Midpoint Park Minworth B76 1AB Sutton Coldfield | No |
Nacionalidad: French País de residencia: United Kingdom | |||
Naturaleza del control
| |||
¿Tiene HOZELOCK GROUP LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Guarantee & debenture | Creado el 15 mar 2010 Entregado el 24 mar 2010 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Guarantee & debenture | Creado el 16 ene 2009 Entregado el 17 ene 2009 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Guarantee and debenture | Creado el 29 jul 1999 Entregado el 12 ago 1999 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the credit agreement (as defined) | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture and guarantee | Creado el 30 jun 1993 Entregado el 07 jul 1993 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the facilities agreement dated 25TH april 1990 (as defined) | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture & guarantee. | Creado el 17 jul 1990 Entregado el 06 ago 1990 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein on the chargee under the terms of the facilities agreement dated 17/7/90 and this charge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0