OPSIS PRACTICE MANAGEMENT SOLUTIONS LTD
Visión general
| Nombre de la empresa | OPSIS PRACTICE MANAGEMENT SOLUTIONS LTD |
|---|---|
| Estado de la empresa | Liquidación |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02498463 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de OPSIS PRACTICE MANAGEMENT SOLUTIONS LTD?
- Actividades de consultoría en tecnología de la información (62020) / Información y comunicación
¿Dónde se encuentra OPSIS PRACTICE MANAGEMENT SOLUTIONS LTD?
| Dirección de la sede social | 1 More London Place SE1 2AF London |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de OPSIS PRACTICE MANAGEMENT SOLUTIONS LTD?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| STUKELEY COMPUTER SERVICES LIMITED | 20 oct 1995 | 20 oct 1995 |
| SWAINFIELD LIMITED | 02 may 1990 | 02 may 1990 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de OPSIS PRACTICE MANAGEMENT SOLUTIONS LTD?
| Vencido | Sí |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 28 feb 2024 |
| Próximas cuentas vencen el | 28 feb 2025 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 28 feb 2023 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para OPSIS PRACTICE MANAGEMENT SOLUTIONS LTD?
| Vencido | Sí |
|---|---|
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 05 jun 2025 |
| Próxima declaración de confirmación vence | 19 jun 2025 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 05 jun 2024 |
| Vencido | Sí |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para OPSIS PRACTICE MANAGEMENT SOLUTIONS LTD?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombramiento de un liquidador voluntario | 11 páginas | 600 | ||||||||||
Destitución del liquidador por orden judicial | 9 páginas | LIQ10 | ||||||||||
Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada The Mailbox Level 3 101 Wharfside Street Birmingham B1 1RF | 2 páginas | AD03 | ||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado a The Mailbox Level 3 101 Wharfside Street Birmingham B1 1RF | 2 páginas | AD02 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de The Mailbox Level 3 101 Wharfside Street Birmingham B1 1RF United Kingdom a 1 More London Place London SE1 2AF el 26 feb 2025 | 3 páginas | AD01 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 3 páginas | 600 | ||||||||||
Declaración de solvencia | 5 páginas | LIQ01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 05 jun 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 28 feb 2023 | 19 páginas | AA | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 71 páginas | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE2 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | AGREEMENT2 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Gordon James Wilson como director el 05 jul 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Stephen Eric Dews como director el 09 jun 2023 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Simon David Walsh como director el 09 jun 2023 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 05 jun 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 28 feb 2022 | 23 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Richard James Kerr como director el 10 feb 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Ditton Park Riding Court Road Datchet Berkshire SL3 9LL United Kingdom a The Mailbox Level 3 101 Wharfside Street Birmingham B1 1RF el 15 jul 2022 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Modification des détails de Alphalaw Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 15 jul 2022 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 30 may 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Mrs Jayne Louise Aspell como secretario el 26 abr 2022 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Natalie Amanda Shaw como secretario el 26 abr 2022 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de OPSIS PRACTICE MANAGEMENT SOLUTIONS LTD?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASPELL, Jayne Louise | Secretario | More London Place SE1 2AF London 1 | 295477220001 | |||||||
| DEWS, Stephen Eric | Director | The Mailbox Level 3 101 Wharfside Street B1 1RF Birmingham Advanced Computer Software Group Limited United Kingdom | United Kingdom | British | 310006210001 | |||||
| WALSH, Simon David | Director | The Mailbox Level 3 101 Wharfside Street B1 1RF Birmingham Advanced Computer Software Group Limited United Kingdom | England | British | 298153810001 | |||||
| CHALLINGER, Sara | Secretario | Hollyoak 2a Cricket Hill Finchampstead RG40 3TN Wokingham Berkshire | British | 123713140001 | ||||||
| ONEILL, Brian | Secretario | 7 Grangewood Rochestown Avenue Dun Laoghaire County Dublin Eire | Irish | 74453030001 | ||||||
| ROBERTS, Neal Anthony | Secretario | Chelford Road WA16 8GS Knutsford Booths Park 4 Cheshire England | British | 140194900001 | ||||||
| ROBINSON, Lucy | Secretario | 25 West Street PE9 2PR Stanford Lincolnshire | British | 75582700001 | ||||||
| SHAW, Natalie Amanda | Secretario | 101 Wharfside Street B1 1RF Birmingham The Mailbox United Kingdom | 251005690001 | |||||||
| WALKER, Julia Lloyd | Secretario | Stukeley House 9 Barnhill Stamford PE9 2AE Peterborough Lincolnshire | British | 27935220001 | ||||||
| WILLIAMS, Denise | Secretario | Portsmouth Road KT11 1TF Cobham Munro House Surrey United Kingdom | British | 176952500001 | ||||||
| BOLIN, Bret Richard, Mr. | Director | Riding Court Road SL3 9LL Datchet Ditton Park Berkshire United Kingdom | United States | American | 198635550001 | |||||
| CHALLINGER, Sara | Director | Hollyoak 2a Cricket Hill Finchampstead RG40 3TN Wokingham Berkshire | British | 123713140001 | ||||||
| CROMPTON, Kerry Jane | Director | Chelford Road WA16 8GS Knutsford Booths Park 4 Cheshire England | United Kingdom | British | 158261930001 | |||||
| FIRTH, Barbara Ann | Director | Portsmouth Road KT11 1TF Cobham Munro House Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | 73934790009 | |||||
| GIBSON, Paul David | Director | Portsmouth Road KT11 1TF Cobham Munro House Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | 192439290001 | |||||
| HICKS, Andrew William | Director | Riding Court Road SL3 9LL Datchet Ditton Park Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 309297040001 | |||||
| KERR, Richard James | Director | 101 Wharfside Street B1 1RF Birmingham The Mailbox Level 3 United Kingdom | England | British | 118897360002 | |||||
| LEUW, Martin Philip | Director | Riding Court Road Datchet SL3 9JT Slough Riding Court House Berkshire | United Kingdom | British | 141644370001 | |||||
| MILLWARD, Guy Leighton | Director | Portsmouth Road KT11 1TF Cobham Munro House Surrey | United Kingdom | British | 203759730001 | |||||
| MILLWARD, Guy Leighton | Director | Portsmouth Road KT11 1TF Cobham Munro House Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | 203759730001 | |||||
| MURRIA, Vinodka | Director | Portsmouth Road KT11 1TF Cobham Munro House Surrey United Kingdom | England | British | 57998050007 | |||||
| ONEILL, Brian | Director | 7 Grangewood Rochestown Avenue Dun Laoghaire County Dublin Eire | Irish | 74453030001 | ||||||
| PREEDY, Richard Ian | Director | Chelford Road WA16 8GS Knutsford Booths Park 4 Cheshire England | England | British | 123433610003 | |||||
| ROBERTS, Neal Anthony | Director | Chelford Road WA16 8GS Knutsford Booths Park 4 Cheshire England | England | British | 12470210004 | |||||
| WALKER, Julia Lloyd | Director | Stukeley House 9 Barnhill Stamford PE9 2AE Peterborough Lincolnshire | British | 27935220001 | ||||||
| WALKER, Peter | Director | Stukeley House 9 Barn Hill PE9 2AE Stamford Lincolnshire | British | 31177100001 | ||||||
| WILSON, Gordon James | Director | 101 Wharfside Street B1 1RF Birmingham The Mailbox Level 3 United Kingdom | United Kingdom | British | 200853210001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de OPSIS PRACTICE MANAGEMENT SOLUTIONS LTD?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphalaw Limited | 06 abr 2016 | 101 Wharfside Street B1 1RF Birmingham The Mailbox Level 3 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene OPSIS PRACTICE MANAGEMENT SOLUTIONS LTD algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0