NSIP (ETS) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaNSIP (ETS) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02504173
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de NSIP (ETS) LIMITED?

    • Actividades de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural (09100) / Explotación de minas y canteras

    ¿Dónde se encuentra NSIP (ETS) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Suite 1, 3rd Floor 11-12 St James's Square
    SW1Y 4LB London
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de NSIP (ETS) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    CH4 PIPELINES LIMITED28 jul 200328 jul 2003
    CALENERGY GAS (PIPELINES) LIMITED08 dic 199708 dic 1997
    POWER TOWER LIMITED06 jul 199006 jul 1990
    HASTESPOT LIMITED21 may 199021 may 1990

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de NSIP (ETS) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2018

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para NSIP (ETS) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    1 páginasDS01

    Cambio de datos del director Mr Thomas Jack Robert Luypaert el 08 jun 2020

    2 páginasCH01

    Declaración de confirmación presentada el 01 jun 2020 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cambio de datos del director Mr Thomas Jack Robert Luypaert el 30 ene 2020

    2 páginasCH01

    Modification des détails de Kellas North Sea 2 Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 30 ene 2020

    2 páginasPSC05

    Cambio de datos del director Mr Andrew David Hessell el 30 ene 2020

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Guy Robert Maurice Appleton el 30 ene 2020

    2 páginasCH01

    Domicilio social registrado cambiado de 14 st. George Street London W1S 1FE United Kingdom a Suite 1, 3rd Floor 11-12 st James's Square London SW1Y 4LB el 04 feb 2020

    1 páginasAD01

    Nombramiento de Mr Thomas Jack Robert Luypaert como director el 30 ene 2020

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Guillaume Jacques Robert Friedel como director el 30 ene 2020

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Stephane Julien Ifker como director el 30 ene 2020

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Mark John Crosbie como director el 30 ene 2020

    1 páginasTM01

    Cambio de datos del director Mr Guillaume Jacques Robert Friedel el 01 ago 2019

    2 páginasCH01

    Modification des détails de Antin North Sea 2 Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 16 sept 2019

    2 páginasPSC05

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2018

    24 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 01 jun 2019 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cancelación total de la carga 025041730011

    4 páginasMR04

    Segunda presentación para el nombramiento de Mr Mark John Crosbie como director

    6 páginasRP04AP01

    Cambio de datos del director Mr Guillaume Jacques Robert Friedel el 20 jun 2018

    2 páginasCH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2017

    25 páginasAA

    Domicilio social registrado cambiado de 14 st George Street London London W1S 1FE a 14 st. George Street London W1S 1FE el 05 jul 2018

    1 páginasAD01

    Declaración de confirmación presentada el 01 jun 2018 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Modification des détails de Antin North Sea 2 Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 15 feb 2018

    2 páginasPSC05

    ¿Quiénes son los directivos de NSIP (ETS) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    APPLETON, Guy Robert Maurice
    7th Floor, The Silver Fin Building
    455 Union Street
    AB11 6DB Aberdeen
    Kellas Midstream Limited
    United Kingdom
    Director
    7th Floor, The Silver Fin Building
    455 Union Street
    AB11 6DB Aberdeen
    Kellas Midstream Limited
    United Kingdom
    United KingdomBritish156848840001
    HESSELL, Andrew David
    7th Floor, The Silver Fin Building
    455 Union Street
    AB11 6DB Aberdeen
    Kellas Midstream Limited
    United Kingdom
    Director
    7th Floor, The Silver Fin Building
    455 Union Street
    AB11 6DB Aberdeen
    Kellas Midstream Limited
    United Kingdom
    United KingdomBritish221140270001
    LUYPAERT, Thomas Jack Robert
    Throgmorton Avenue
    EC2N 2DL London
    12
    United Kingdom
    Director
    Throgmorton Avenue
    EC2N 2DL London
    12
    United Kingdom
    United KingdomFrench264133230002
    GILES, Gail Valerie
    North Sundaysight
    Bellingham
    NE48 2JE Hexham
    Northumberland
    Secretario
    North Sundaysight
    Bellingham
    NE48 2JE Hexham
    Northumberland
    British108926390001
    HOBDEN, Brian
    40 Woodburn Crescent
    AB15 8JX Aberdeen
    Secretario
    40 Woodburn Crescent
    AB15 8JX Aberdeen
    British81368370001
    KIRK, Philip Andrew
    5 Old Deer Park Gardens
    TW9 2TN Richmond
    Surrey
    Secretario
    5 Old Deer Park Gardens
    TW9 2TN Richmond
    Surrey
    British84103730001
    MISTRY, Bhavna
    37 Warren Road
    Whitton
    TW2 7DH Twickenham
    Middlesex
    Secretario
    37 Warren Road
    Whitton
    TW2 7DH Twickenham
    Middlesex
    British87625170001
    SPARKES, Michael Jack
    The Pantiles Main Street
    Thorney
    NG23 7BS Newark
    Nottinghamshire
    Secretario
    The Pantiles Main Street
    Thorney
    NG23 7BS Newark
    Nottinghamshire
    British43902400001
    WAITE, Simon Nicholas
    2 Chestnut Lane
    AB31 5PH Banchory
    Aberdeenshire
    Secretario
    2 Chestnut Lane
    AB31 5PH Banchory
    Aberdeenshire
    British117008750002
    CENTRICA SECRETARIES LIMITED
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Millstream
    Berkshire
    Secretario corporativo
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Millstream
    Berkshire
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro4049225
    146095800001
    WEIL, GOTSHAL & MANGES (LONDON) LLP
    Fetter Lane
    EC4A 1AY London
    110
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    Fetter Lane
    EC4A 1AY London
    110
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registroOC400678
    199087250001
    ABEL, Gregory Edward
    4710 George Mills Parkway 402
    50265 West Des Moines
    Iowa
    United States
    Director
    4710 George Mills Parkway 402
    50265 West Des Moines
    Iowa
    United States
    UsaCanadian52806480009
    BEGBIE, Roderick Mcintosh
    11 Kepplestone Gardens
    AB15 4DH Aberdeen
    Aberdeenshire
    Director
    11 Kepplestone Gardens
    AB15 4DH Aberdeen
    Aberdeenshire
    British115205850001
    BRICKNELL, Bruce David Neil
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Millstream
    Berkshire
    United Kingdom
    Director
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Millstream
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish184345640001
    CLAYTON, Marie-Louise
    309 North Deeside Road
    AB13 0DL Aberdeen
    Director
    309 North Deeside Road
    AB13 0DL Aberdeen
    British103782580001
    CONNOR, Phillip Eric
    Billy Hill House
    Stanley
    DL15 9QS Crook
    County Durham
    Director
    Billy Hill House
    Stanley
    DL15 9QS Crook
    County Durham
    EnglandEnglish72946860001
    CROSBIE, Mark John
    St. George Street
    W1S 1FE London
    14
    United Kingdom
    Director
    St. George Street
    W1S 1FE London
    14
    United Kingdom
    United KingdomBritish211079810001
    DAVIES, John George
    Cotchet Barn Blackdown
    GU27 3BS Haslemere
    Surrey
    Director
    Cotchet Barn Blackdown
    GU27 3BS Haslemere
    Surrey
    British54724650001
    DIXON, Ronald
    1 Berkley Avenue
    NE21 5NN Blaydon
    Tyne & Wear
    Director
    1 Berkley Avenue
    NE21 5NN Blaydon
    Tyne & Wear
    EnglandBritish2318270001
    FRIEDEL, Guillaume Jacques Robert
    St. George Street
    W1S 1FE London
    14
    United Kingdom
    Director
    St. George Street
    W1S 1FE London
    14
    United Kingdom
    United StatesFrench189459340023
    GILES, Gail Valerie
    North Sundaysight
    Bellingham
    NE48 2JE Hexham
    Northumberland
    Director
    North Sundaysight
    Bellingham
    NE48 2JE Hexham
    Northumberland
    EnglandBritish108926390001
    GROVES, Alan
    37 Avondale Road
    Ponteland
    NE20 9NA Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Director
    37 Avondale Road
    Ponteland
    NE20 9NA Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British2318230001
    GUGEN, Francis Robert
    Down Street
    W1J 7AJ London
    7
    Director
    Down Street
    W1J 7AJ London
    7
    United KingdomBritish388450006
    HANAFIN, Vincent Mark
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Millstream
    Berkshire
    Director
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Millstream
    Berkshire
    United KingdomBritish131999620002
    IFKER, Stephane Julien
    St. George Street
    W1S 1FE London
    14
    United Kingdom
    Director
    St. George Street
    W1S 1FE London
    14
    United Kingdom
    FranceFrench229631470001
    KIRK, Philip Andrew
    5 Old Deer Park Gardens
    TW9 2TN Richmond
    Surrey
    Director
    5 Old Deer Park Gardens
    TW9 2TN Richmond
    Surrey
    British84103730001
    LE POIDEVIN, Andrew Daryl
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Millstream
    Berkshire
    Director
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Millstream
    Berkshire
    EnglandBritish4958800007
    LINGE, Kenneth
    Drystones Heugh House Lane
    NE47 6ND Haydon Bridge
    Northumberland
    Director
    Drystones Heugh House Lane
    NE47 6ND Haydon Bridge
    Northumberland
    EnglandBritish52698930001
    LUMSDEN, Roy Andrew
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Millstream
    Berkshire
    Director
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Millstream
    Berkshire
    United KingdomBritish199053700001
    MORRIS, David Richard
    Churchfield 1 Top Street
    Wing
    LE15 8SE Oakham
    Leicestershire
    Director
    Churchfield 1 Top Street
    Wing
    LE15 8SE Oakham
    Leicestershire
    United KingdomBritish36692700001
    MURPHY, Jonathan David
    74 Beaconsfield Place
    AB15 4AJ Aberdeen
    Aberdeenshire
    Director
    74 Beaconsfield Place
    AB15 4AJ Aberdeen
    Aberdeenshire
    British115205970001
    OZSANLAV, Richard
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Millstream
    Berkshire
    United Kingdom
    Director
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Millstream
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish147826530002
    PICOTTE, Christopher
    200 Clarendon Street 55th Floor
    MA 02117 Boston
    Arclight Capital Partners Llc
    Usa
    Director
    200 Clarendon Street 55th Floor
    MA 02117 Boston
    Arclight Capital Partners Llc
    Usa
    American116230600001
    ROGER, Jonathan Leslie
    AB15
    Director
    AB15
    United KingdomBritish124423900001
    ROGER, Jonathan Leslie
    AB15
    Director
    AB15
    United KingdomBritish124423900001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de NSIP (ETS) LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    11-12 St James's Square
    SW1Y 4LB London
    Suite 1, 3rd Floor
    United Kingdom
    21 dic 2017
    11-12 St James's Square
    SW1Y 4LB London
    Suite 1, 3rd Floor
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalUnited Kingdom
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro10778448
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Millstream
    Berkshire
    United Kingdom
    06 abr 2016
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Millstream
    Berkshire
    United Kingdom
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalUnited Kingdom
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro3186121
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene NSIP (ETS) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 26 mar 2018
    Entregado el 26 mar 2018
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    N/A.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Rbc Europe Limited
    Transacciones
    • 26 mar 2018Registro de una carga (MR01)
    • 02 abr 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 24 ene 2007
    Entregado el 31 ene 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company or any obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All of the chargor's rights to and title and interest from time to time in the whole of its property,assets,rights and revenues,whatsoever and wheresoever,present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The "Security Trustee")
    Transacciones
    • 31 ene 2007Registro de un cargo (395)
    • 13 ago 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Bond and floating charge
    Creado el 22 ene 2007
    Entregado el 31 ene 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company or any obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Floating charge over the assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The "Security Trustee")
    Transacciones
    • 31 ene 2007Registro de un cargo (395)
    • 07 sept 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 21 jul 2006
    Entregado el 28 jul 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company or any obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All the company's rights to and title and interest from time to time in the relevant project accounts, all account proceeds, by way of first floating charge all the company's rights to and title and interest from time to time in the whole of its property, assets, rights and revenues. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Abn Amro Bank N.V. (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 28 jul 2006Registro de un cargo (395)
    • 07 sept 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Third supplemental deed of amendment to a note purchase agreement dated 23 december 2003 and
    Creado el 27 ene 2006
    Entregado el 09 feb 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any group company to the senior finance parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    If any borrower or the issuer makes any payment in cash or in kind on account of, or for the purchase or other acquisition of all or any part of the junior liabilities or the subordianted liabilies or the junior lender or any subordianted lender recieves all or any amount in cash, the junior lender will hold any amount so received on trust for the collateral agent,. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Deutsche Bank Ag (The Collateral Agent)
    Transacciones
    • 09 feb 2006Registro de un cargo (395)
    • 28 jul 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    First supplemental deed of amendment to a guarantee and debenture dated 23 december 2003 and
    Creado el 27 ene 2006
    Entregado el 09 feb 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company or CH4 energy limited to the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Deutsche Bank Ag (The Collateral Agent)
    Transacciones
    • 09 feb 2006Registro de un cargo (395)
    • 28 jul 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Second supplemental deed of amendment dated 23 december 2005
    Creado el 23 dic 2005
    Entregado el 10 ene 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the parent or the company to the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Deutsche Bank Ag (The Collateral Agent)
    Transacciones
    • 10 ene 2006Registro de un cargo (395)
    • 28 jul 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creado el 23 dic 2003
    Entregado el 13 ene 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the parent or the company to the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Deutsche Bank Ag
    Transacciones
    • 13 ene 2004Registro de un cargo (395)
    • 28 jul 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 21 ago 2003
    Entregado el 04 sept 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • 3I Group PLC
    Transacciones
    • 04 sept 2003Registro de un cargo (395)
    • 18 may 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Supplemental debenture
    Creado el 01 jul 1999
    Entregado el 14 jul 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each borrower (as defined) to any finance party (as defined) under each finance document to which such borrower is a party
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 14 jul 1999Registro de un cargo (395)
    • 18 abr 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 05 jun 1998
    Entregado el 22 jun 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All present and future obligations and liabilities of each borrower (as defined) to the chargee as agent and trustee for each finance party (as defined) under each finance document (as defined)
    Breve descripción
    By way of first fixed charge all its respective present and future right and title to and interest in the charged assets by way of first floating charge all its assets and undertaking whatsoever and wheresoever both present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 22 jun 1998Registro de un cargo (395)
    • 18 abr 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0