LENDLEASE REAL ESTATE INVESTMENT SERVICES LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | LENDLEASE REAL ESTATE INVESTMENT SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02504487 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de LENDLEASE REAL ESTATE INVESTMENT SERVICES LIMITED?
- Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción
¿Dónde se encuentra LENDLEASE REAL ESTATE INVESTMENT SERVICES LIMITED?
| Dirección de la sede social | Level 7, 1 Eversholt Street NW1 2DN London United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de LENDLEASE REAL ESTATE INVESTMENT SERVICES LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| LEND LEASE REAL ESTATE INVESTMENT SERVICES LIMITED | 30 nov 2001 | 30 nov 2001 |
| LEND LEASE EUROPE ASSET MANAGEMENT LIMITED | 20 oct 1998 | 20 oct 1998 |
| THE YARMOUTH GROUP (U.K.), LIMITED | 05 jul 1994 | 05 jul 1994 |
| LEND LEASE INTERNATIONAL LIMITED | 09 ene 1991 | 09 ene 1991 |
| WESTDEAN INVESTMENTS PLC | 22 may 1990 | 22 may 1990 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de LENDLEASE REAL ESTATE INVESTMENT SERVICES LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 30 jun 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 jun 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 jun 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para LENDLEASE REAL ESTATE INVESTMENT SERVICES LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 17 nov 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 01 dic 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 17 nov 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para LENDLEASE REAL ESTATE INVESTMENT SERVICES LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Nombramiento de Mr Guy Gordon Thomas como director el 10 dic 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de David Michael Welford como director el 10 dic 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de Level 7 1 Eversholt Street London NW1 2DN United Kingdom a Level 7, 1 Eversholt Street London NW1 2DN el 20 nov 2025 | 1 páginas | AD01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 17 nov 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Jae Hee Park como director el 10 nov 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr James Andras Lovatt como director el 10 nov 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Modification des détails de Lendlease Europe Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 03 nov 2025 | 2 páginas | PSC05 | ||
Nombramiento de Mr David Michael Welford como director el 03 nov 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Monique Marise Goldman como director el 03 nov 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de C/O Pinsent Masons Llp 30 Crown Place London EC2A 4ES United Kingdom a Level 7 1 Eversholt Street London NW1 2DN el 03 nov 2025 | 1 páginas | AD01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2024 | 26 páginas | AA | ||
Nombramiento de Monique Marise Goldman como director el 03 abr 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Mohammed Shahraz Khan como director el 03 abr 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Stephanie Barbabosa como director el 03 abr 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de 5 Merchant Square Level 9 London W2 1BQ England a C/O Pinsent Masons Llp 30 Crown Place London EC2A 4ES el 08 ene 2025 | 1 páginas | AD01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 05 dic 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Jae Hee Park como director el 22 nov 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Maleeha Ali Faruqui como director el 22 nov 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2023 | 26 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 05 dic 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 05 dic 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2022 | 25 páginas | AA | ||
Domicilio social registrado cambiado de 20 Triton Street Regent's Place London NW1 3BF a 5 Merchant Square Level 9 London W2 1BQ el 12 sept 2022 | 1 páginas | AD01 | ||
Cese del nombramiento de Deborah Mclauchlan como director el 29 abr 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 05 dic 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
¿Quiénes son los directivos de LENDLEASE REAL ESTATE INVESTMENT SERVICES LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOVATT, James Andras | Director | Eversholt Street NW1 2DN London Level 7, 1 United Kingdom | England | British | 297602520001 | |||||||||
| THOMAS, Guy Gordon | Director | Eversholt Street NW1 2DN London Level 7, 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 189513200001 | |||||||||
| BURROWS, Roger Leonard | Secretario | 51 Leyborne Park Kew TW9 3BH Richmond Surrey | Australian | 47271870002 | ||||||||||
| DAVIDSON, Patricia Margaret | Secretario | 39 Saunderton Vale Saunderton HP14 4LJ High Wycombe Buckinghamshire | British | 38824170008 | ||||||||||
| DRAPER, Jennifer | Secretario | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 20 | 204805060001 | |||||||||||
| GOUGH, Alison Louise | Secretario | Flat 1 15 Southwood Avenue N6 5RY London | British | 62074540002 | ||||||||||
| GOUGH, Alison Louise | Secretario | 12 Redcliffe Mews SW10 9JU London | Australian | 62074540001 | ||||||||||
| JANANDRAN, Thanalakshmi | Secretario | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 20 England | 150573790001 | |||||||||||
| JORDAN, Jacqueline | Secretario | 18 Coalbrook Mansions Bedford Hill Balham SW12 9RJ London | British | 88247150001 | ||||||||||
| JORDAN, Jacqueline | Secretario | 18 Coalbrook Mansions Bedford Hill Balham SW12 9RJ London | British | 88247150001 | ||||||||||
| MARTIN, Neil Christopher | Secretario | 36 Vicarage Road RG9 1HW Henley On Thames Oxfordshire | British | 92464400001 | ||||||||||
| MCEWEN, Sarah | Secretario | 81 Swaby Road SW18 3PH London | British | 107481330001 | ||||||||||
| PLUMBRIDGE, Christopher Francis | Secretario | 19 The Murreys KT21 2LU Ashtead Surrey | British | 31460130001 | ||||||||||
| SUTTON, Penelope Ruth | Secretario | 32 Saxon Road BR1 3RP Bromley Kent | British | 38586070002 | ||||||||||
| TOOMBES, Alan | Secretario | Rosemount 11 Beechwood Grove Long Ditton KT6 6QE Surbiton Surrey | British | 42204170001 | ||||||||||
| WALLWORK, Amelia Joy | Secretario | Northolt Road HA2 0EE Harrow 142 Middlesex England | Australian | 137697660001 | ||||||||||
| WALSH, Paul Bernard | Secretario | 999 Pine Tree Lane 60093 Winnetka Illinois America | British | 39792820001 | ||||||||||
| CAPITA COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | Dukes Place EC3A 7NH London 40 England |
| 102944500001 | ||||||||||
| ALLWOOD, Peter John | Director | Flat 9 264 Waterloo Road SE1 8RP London | Australian | 93182880001 | ||||||||||
| AMIN, Biren | Director | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 20 England | England | British | 173092100001 | |||||||||
| ANDERSON, Keith Michael | Director | 20a Arterberry Road Wimbledon SW20 8AJ London | England | British | 77161820002 | |||||||||
| ARCHER, Peter Monahan | Director | Red Lion House Red Lion Hill, The Lee HP16 9NF Great Missenden Buckinghamshire | United Kingdom | British | 65693680001 | |||||||||
| ARTHUR, Derryn Sue | Director | 21 Elsham Road W14 8HA London | New Zealander | 57726590002 | ||||||||||
| BARBABOSA, Stephanie | Director | 30 Crown Place EC2A 4ES London C/O Pinsent Masons Llp United Kingdom | England | American | 242242280001 | |||||||||
| BOOR, Mark | Director | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 20 England | United Kingdom | British | 134752850001 | |||||||||
| BUDDEN, Christopher David | Director | The Eldorado 300 Central Park West Apart 20/C/D NY10024 New York Usa | British | 41343330002 | ||||||||||
| BURROWS, Roger Leonard | Director | 51 Leyborne Park Kew TW9 3BH Richmond Surrey | Australian | 47271870002 | ||||||||||
| CAVEN, Robin Graham | Director | 74 St Johns Road TN13 3NB Sevenoaks Kent | United Kingdom | British | 76216840002 | |||||||||
| COCKBURN, George Ian Macloy | Director | 9 High Meadow Close RH4 2LG Dorking Surrey | England | British | 58892420002 | |||||||||
| FARUQUI, Maleeha | Director | Merchant Square Level 9 W2 1BQ London 5 England | United Kingdom | British | 267099490001 | |||||||||
| FOSTER TAYLOR, Charles Michael | Director | Flat 4 60 Redcliffe Gardens SW10 9HD London | British | 78063540001 | ||||||||||
| GOLDMAN, Monique Marise | Director | 1 Eversholt Street NW1 2DN London Level 7 United Kingdom | England | Australian | 332493750001 | |||||||||
| GOUGH, Alison Louise | Director | Flat 1 15 Southwood Avenue N6 5RY London | British | 62074540002 | ||||||||||
| GRIST, Stephen Kenneth | Director | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 20 England | England | Australian | 157560950001 | |||||||||
| HEYES, Thomas | Director | 19 Birch Close Send GU23 7BZ Woking Surrey | British | 35705710001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de LENDLEASE REAL ESTATE INVESTMENT SERVICES LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lendlease Europe Holdings Limited | 06 abr 2016 | Eversholt Street NW1 2DN London Level 7, 1 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0