WOWS 6 LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaWOWS 6 LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02507527
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de WOWS 6 LIMITED?

    • Actividades auxiliares a la intermediación financiera n.c.o.p. (66190) / Actividades financieras y de seguros

    ¿Dónde se encuentra WOWS 6 LIMITED?

    Dirección de la sede social
    47 Homefield Road
    W4 2LW London
    Uk
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de WOWS 6 LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    TRIO HOLDINGS LIMITED17 jun 200517 jun 2005
    TRIO INVESTMENT TRUST PLC16 nov 199016 nov 1990
    TRINITY INVESTMENT TRUST PLC13 nov 199013 nov 1990
    BIDYIELD PUBLIC LIMITED COMPANY 01 jun 199001 jun 1990

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de WOWS 6 LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 sept 2013

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para WOWS 6 LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para WOWS 6 LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ2

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Domicilio social registrado cambiado de Cannon Bridge 25 Dowgate Hill London EC4R 2BB a 47 Homefield Road London W4 2LW el 19 may 2015

    2 páginasAD01
    A476QWEH

    Certificado de cambio de nombre

    Company name changed trio holdings LIMITED\certificate issued on 29/12/14
    3 páginasCERTNM
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 12 dic 2014

    RES15
    A3N3Q8BV

    Aviso de cambio de nombre

    2 páginasCONNOT
    A3N3Q8C3

    Misceláneos

    Aud res section 519 CA2006
    3 páginasMISC
    A3MO29Q1

    Cese del nombramiento de Eamonn William Bradley como secretario el 03 dic 2014

    1 páginasTM02
    X3MFJXH5

    Cese del nombramiento de Eamonn William Bradley como director el 03 dic 2014

    1 páginasTM01
    X3MFJ6LT

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2013

    16 páginasAA
    A3DRL2SP

    Déclaration annuelle établie au 31 mar 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital07 may 2014

    Estado de capital el 07 may 2014

    • Capital: GBP 4,174,216.25
    SH01
    X37F5DGB

    Registro de la carga 025075270008

    29 páginasMR01
    X37CF1D7

    Registro de la carga 025075270007

    20 páginasMR01
    X37CENGP

    Cuentas preparadas hasta el 30 sept 2012

    14 páginasAA
    A2GUT6OA

    Cese del nombramiento de Alan Farnan como director

    1 páginasTM01
    X2CHHSD5

    Cese del nombramiento de David Caplin como director

    1 páginasTM01
    X2CHHQRL

    Nombramiento de Mr Stephen Welch como director

    2 páginasAP01
    X2BEM8H2

    Déclaration annuelle établie au 31 mar 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    X27B4XVT

    Cambio de datos del director Mr Alan Martin Farnan el 08 ago 2012

    2 páginasCH01
    X27B4XVL

    Nombramiento de Mr Eamonn William Bradley como director

    2 páginasAP01
    X2531HY9

    Nombramiento de Mr Eamonn William Bradley como secretario

    1 páginasAP03
    X250GT7O

    Cese del nombramiento de Jeremy Kraft como director

    1 páginasTM01
    X250GO5L

    Cese del nombramiento de Jeremy Kraft como secretario

    1 páginasTM02
    X250GO1E

    Déclaration annuelle établie au 31 mar 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    X183B0MW

    Cambio de datos del director Mr Alan Martin Farnan el 30 mar 2012

    2 páginasCH01
    X183B0MO

    Cuentas preparadas hasta el 30 sept 2011

    13 páginasAA
    A13T0WOZ

    ¿Quiénes son los directivos de WOWS 6 LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    WELCH, Stephen
    Homefield Road
    W4 2LW London
    47
    Uk
    Director
    Homefield Road
    W4 2LW London
    47
    Uk
    EnglandAustralianAccountant179384770001
    BRADLEY, Eamonn William
    Cannon Bridge
    25 Dowgate Hill
    EC4R 2BB London
    Secretario
    Cannon Bridge
    25 Dowgate Hill
    EC4R 2BB London
    177013150001
    KRAFT, Jeremy David
    27 Avenue Gardens
    TW11 0BH Teddington
    Middlesex
    Secretario
    27 Avenue Gardens
    TW11 0BH Teddington
    Middlesex
    BritishDirector71360190003
    MOORE, Peter David
    Glen House
    Deepdene Wood
    RH5 4BQ Dorking
    Surrey
    Secretario
    Glen House
    Deepdene Wood
    RH5 4BQ Dorking
    Surrey
    British1644210001
    THOMSON, John Stewart
    9 Upper Lattimore Road
    AL1 3UD St Albans
    Hertfordshire
    Secretario
    9 Upper Lattimore Road
    AL1 3UD St Albans
    Hertfordshire
    British1644180002
    JUPITER ASSET MANAGEMENT LIMITED
    1 Grosvenor Place
    SW1X 7JJ London
    Secretario corporativo
    1 Grosvenor Place
    SW1X 7JJ London
    46510320002
    BRADLEY, Eamonn William
    Cannon Bridge
    25 Dowgate Hill
    EC4R 2BB London
    Director
    Cannon Bridge
    25 Dowgate Hill
    EC4R 2BB London
    United KingdomBritishCertified Chartered Accountant177008470001
    CAPLIN, David Simon Montfort
    519 Ben Johnson House
    Barbican
    EC2Q 8DL London
    Director
    519 Ben Johnson House
    Barbican
    EC2Q 8DL London
    EnglandBritishDirector104626850001
    CHEUNG, Denis Shiu Shing
    10c Swiss Tower
    113 Tai Hang Road
    FOREIGN Hong Kong
    Hong Kong
    Director
    10c Swiss Tower
    113 Tai Hang Road
    FOREIGN Hong Kong
    Hong Kong
    BritishMoney Broker81365570001
    CLARKE, Matthew James Stanhope
    22 Hazlitt Road
    W14 0JY London
    Director
    22 Hazlitt Road
    W14 0JY London
    EnglandBritishChartered Accountant52586600001
    ENDRES, Peter Michael
    Kissingerstrasse 4
    4100 Duisburg 25
    Germany
    Director
    Kissingerstrasse 4
    4100 Duisburg 25
    Germany
    GermanCompany Director18515010001
    FARNAN, Alan Martin
    Alderton Hill
    IG10 3JB Loughton
    54
    Essex
    England
    Director
    Alderton Hill
    IG10 3JB Loughton
    54
    Essex
    England
    EnglandIrishDirector88410720008
    GLOSSOP, Peter George
    Penlan Hall
    Fordham
    CO6 3LP Colchester
    Essex
    Director
    Penlan Hall
    Fordham
    CO6 3LP Colchester
    Essex
    BritishCompany Director4302060001
    HAGAN, David Lloyd
    Eastwoods
    Pitmore Lane
    SO41 6BW Sway
    Hampshire
    Director
    Eastwoods
    Pitmore Lane
    SO41 6BW Sway
    Hampshire
    United KingdomBritishChartered Accountant50541510001
    KRAFT, Jeremy David
    27 Avenue Gardens
    TW11 0BH Teddington
    Middlesex
    Director
    27 Avenue Gardens
    TW11 0BH Teddington
    Middlesex
    United KingdomBritishDirector71360190003
    MELLON, James, Sir
    32 Royal Terrace
    EH7 5AH Edinburgh
    Director
    32 Royal Terrace
    EH7 5AH Edinburgh
    ScotlandBritishChairman35900310001
    MELLON, James
    Flat 1 Eva Court
    36 Macdonnel Road
    FOREIGN Hong Kong
    Director
    Flat 1 Eva Court
    36 Macdonnel Road
    FOREIGN Hong Kong
    BritishCompany Director68376540004
    MOORE, Christopher Hodgson
    8 Hammersmith Terrace
    W6 9TS London
    Director
    8 Hammersmith Terrace
    W6 9TS London
    EnglandEnglishCompany Director5345930001
    MOORE, Peter David
    Glen House
    Deepdene Wood
    RH5 4BQ Dorking
    Surrey
    Director
    Glen House
    Deepdene Wood
    RH5 4BQ Dorking
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director1644210001
    SPENCE, Christopher John
    Chieveley Manor Church Lane
    Chieveley
    RG20 8UT Newbury
    Berkshire
    Director
    Chieveley Manor Church Lane
    Chieveley
    RG20 8UT Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritishCompany Director3558990001
    STRADMOOR, Tony
    3-31-7 Fukuzawa Setagaya-Ku
    101 Ris Fukuzawa
    FOREIGN Tokyo
    Japan
    Director
    3-31-7 Fukuzawa Setagaya-Ku
    101 Ris Fukuzawa
    FOREIGN Tokyo
    Japan
    BritishMoney Broker39282950001
    STRADMOOR, Tony
    3-31-7 Fukuzawa Setagaya-Ku
    101 Ris Fukuzawa
    FOREIGN Tokyo
    Japan
    Director
    3-31-7 Fukuzawa Setagaya-Ku
    101 Ris Fukuzawa
    FOREIGN Tokyo
    Japan
    BritishMoney Broker39282950001
    SUTCLIFFE, Jayne Allison
    6 Heathfield Gardens
    SW18 2PJ London
    Director
    6 Heathfield Gardens
    SW18 2PJ London
    EnglandBritishDirector56443990003
    THOMSON, John Stewart
    9 Upper Lattimore Road
    AL1 3UD St Albans
    Hertfordshire
    Director
    9 Upper Lattimore Road
    AL1 3UD St Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritishChartered Accountant1644180002
    WATANABE, Hiroshi
    3-3-12 Azabudai
    Minato Ku
    FOREIGN Tokyo
    Japan
    Director
    3-3-12 Azabudai
    Minato Ku
    FOREIGN Tokyo
    Japan
    JapaneseCompany Director61570360001

    ¿Tiene WOWS 6 LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 29 abr 2014
    Entregado el 06 may 2014
    Pendiente
    Breve descripción
    1. all registered or unregistered estates and interests in freehold and leasehold properties now or in the future owned by the obligors (as defined in the charge document) or in which the obligors have an interest from time to time; and. 2. any present or future interests (whether legal or equitable, and including the benefit of all licences) relating to any registered or unregistered trade marks, patents, copyrights, design rights, domain names, business names, confidential information, know-how and other intellectual property rights together with the rights to use any of the foregoing.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Sns Portfolio Limited
    Transacciones
    • 06 may 2014Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 29 abr 2014
    Entregado el 06 may 2014
    Pendiente
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Sns Portfolio Limited
    Transacciones
    • 06 may 2014Registro de una carga (MR01)
    Composite guarantee and debentures
    Creado el 17 mar 2008
    Entregado el 25 mar 2008
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 25 mar 2008Registro de un cargo (395)
    Accession agreement to the debenture
    Creado el 27 jun 2005
    Entregado el 07 jul 2005
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the principals (or any of them) to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Gresham LLP (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 07 jul 2005Registro de un cargo (395)
    Accession agreement relating to composite guarantee and debenture dated 11 march 2005
    Creado el 27 jun 2005
    Entregado el 02 jul 2005
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due by the principals or any of them to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The "Security Trustee")
    Transacciones
    • 02 jul 2005Registro de un cargo (395)
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 10 jun 2005
    Entregado el 16 jun 2005
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due by the principals (or any of them) to the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee (For the Secured Parties)
    Transacciones
    • 16 jun 2005Registro de un cargo (395)
    Security assignment
    Creado el 18 dic 1992
    Entregado el 08 ene 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the sale and purchase agreement of even date
    Breve descripción
    All the right to all moneys whatsoever payable to or on account of the company under clause 8 of the placing and underwriting agreement (see form 395 form full details).
    Personas con derecho
    • Rp Martin (Investments) PLC
    Transacciones
    • 08 ene 1993Registro de un cargo (395)
    • 22 mar 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge of account
    Creado el 18 dic 1992
    Entregado el 08 ene 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the sale and purchase agreement of even date
    Breve descripción
    All thr right title and interest of the company in and to the deposit deposited in the account and all othe sums standing to the credit of the account no:61370715 with midland bank PLC (see form 395 for full details).
    Personas con derecho
    • Rp Martin (Investments)PLC
    Transacciones
    • 08 ene 1993Registro de un cargo (395)
    • 18 nov 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0