INTERBUSINESS GROUP LIMITED

INTERBUSINESS GROUP LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaINTERBUSINESS GROUP LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social, exención del uso de 'Limited'
    Número de empresa 02508309
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de INTERBUSINESS GROUP LIMITED?

    • Otras actividades de apoyo a los negocios n.c.p. (82990) / Actividades administrativas y de apoyo

    ¿Dónde se encuentra INTERBUSINESS GROUP LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Hart House Business Centre
    Kimpton Road
    LU2 0LB Luton
    Bedfordshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de INTERBUSINESS GROUP LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    THE BEDFORDSHIRE AND LUTON CHAMBER OF COMMERCE TRAINING AND ENTERPRISE LIMITED20 jul 199820 jul 1998
    BEDFORDSHIRE TRAINING AND ENTERPRISE COUNCIL04 jun 199004 jun 1990

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de INTERBUSINESS GROUP LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2014

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para INTERBUSINESS GROUP LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para INTERBUSINESS GROUP LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cese del nombramiento de Judy Oliver como director el 18 mar 2015

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Mark West como director el 18 mar 2015

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Keren Wilkins como director el 18 mar 2015

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Richard Lewis Cooper como director el 18 mar 2015

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Rodney John Calvert como director el 18 mar 2015

    1 páginasTM01

    Cancelación total de la carga 2

    1 páginasMR04

    Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 mar 2014

    20 páginasAA

    Cese del nombramiento de Andrew Robert Gilson como director el 02 oct 2014

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Elliot Paul Renton como director el 02 oct 2014

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 03 jun 2014, aucune liste de membres fournie

    7 páginasAR01

    Domicilio social registrado cambiado de * the Business Competitiveness Centre Kimpton Road Luton Bedfordshire LU2 0SX* el 30 jun 2014

    1 páginasAD01

    Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 mar 2013

    21 páginasAA

    Nombramiento de Mrs Judy Oliver como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Pauline Stewart como director

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 03 jun 2013, aucune liste de membres fournie

    8 páginasAR01

    Cese del nombramiento de David Eales como director

    1 páginasTM01

    Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 mar 2012

    21 páginasAA

    Nombramiento de Mrs Keren Wilkins como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Richard Lewis Cooper como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Andrew Robert Gilson como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Mark West como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Judith Oliver como director

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de INTERBUSINESS GROUP LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    RICHARDSON, Justin Roger
    9 Brook View
    Grange Park
    NN4 5DR Northampton
    Northamptonshire
    Secretario
    9 Brook View
    Grange Park
    NN4 5DR Northampton
    Northamptonshire
    British101016920001
    BROCKIS, Jeremy Neil
    Kimpton Road
    LU2 0LB Luton
    Hart House Business Centre
    Bedfordshire
    England
    Director
    Kimpton Road
    LU2 0LB Luton
    Hart House Business Centre
    Bedfordshire
    England
    EnglandBritish142191560001
    ELLINOR, David Robert
    Hanworth Close
    LU2 7ED Luton
    6
    England
    Director
    Hanworth Close
    LU2 7ED Luton
    6
    England
    United KingdomBritish54832450001
    FLACK, Ivan Raymond
    Gobion House
    Godfrey Lane
    MK44 1PS Sharnbrook
    Bedfordshire
    Secretario
    Gobion House
    Godfrey Lane
    MK44 1PS Sharnbrook
    Bedfordshire
    British76058380001
    SMYTHE, Joanne
    1 Mill Cottage
    Bridge Street
    MK43 8ER Turvey
    Bedfordshire
    Secretario
    1 Mill Cottage
    Bridge Street
    MK43 8ER Turvey
    Bedfordshire
    British80512510002
    WEE, Stephen
    17 Tibbett Close
    LU6 3TT Dunstable
    Bedfordshire
    Secretario
    17 Tibbett Close
    LU6 3TT Dunstable
    Bedfordshire
    British73684580001
    WHITE, Nicholas John
    8 High Street
    Souldrop
    MK44 1EY Bedford
    Bedfordshire
    Secretario
    8 High Street
    Souldrop
    MK44 1EY Bedford
    Bedfordshire
    British65139630001
    ABRUZESSE, Maria
    Flat 4 De Parys Lodge
    De Parys Avenue
    MK40 2TZ Bedford
    Bedfordshire
    Director
    Flat 4 De Parys Lodge
    De Parys Avenue
    MK40 2TZ Bedford
    Bedfordshire
    Italian47263720001
    ARNOLD, Thomas Edward
    April Rise
    11 Rotten Row
    MK44 1EJ Riseley
    Bedfordshire
    Director
    April Rise
    11 Rotten Row
    MK44 1EJ Riseley
    Bedfordshire
    British67992960001
    ASHDOWN, Nigel Stanley
    303 Norton Way South
    SG6 1SU Letchworth
    Hertfordshire
    Director
    303 Norton Way South
    SG6 1SU Letchworth
    Hertfordshire
    United KingdomBritish2554530001
    BAGGOTT, David Richard
    4 Chantry Close
    Woburn Sands
    MK17 8UB Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Director
    4 Chantry Close
    Woburn Sands
    MK17 8UB Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British61564350002
    BARBER, John Christopher
    46 The Bury
    Pavenham
    MK43 7PY Bedford
    Director
    46 The Bury
    Pavenham
    MK43 7PY Bedford
    British25870870003
    BARRINGTON, Phillip
    3 Grovesbrook
    Bow Brickhill
    MK17 9JF Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Director
    3 Grovesbrook
    Bow Brickhill
    MK17 9JF Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British28514120001
    BISCHOF, Robert Alfons Teja
    10 Carrwood Avenue
    Bramhall
    SK7 2PX Stockport
    Cheshire
    Director
    10 Carrwood Avenue
    Bramhall
    SK7 2PX Stockport
    Cheshire
    United KingdomGerman/British30373650001
    BURGESS, Keith
    27 High Street
    Wilden
    MK44 2PB Bedford
    Director
    27 High Street
    Wilden
    MK44 2PB Bedford
    United KingdomBritish42601150001
    BURNIP, Anthony Roger
    Lilac Cottage 63 Newport Road
    Woburn Sands
    MK17 8UQ Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Director
    Lilac Cottage 63 Newport Road
    Woburn Sands
    MK17 8UQ Milton Keynes
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish18783570001
    CALVERT, Rodney John
    Kimpton Road
    LU2 0LB Luton
    Hart House Business Centre
    Bedfordshire
    England
    Director
    Kimpton Road
    LU2 0LB Luton
    Hart House Business Centre
    Bedfordshire
    England
    EnglandBritish65812620001
    CALVERT, Rodney John
    Sails Cottage 7 Windmill Hill
    Biddenham
    MK40 4AG Bedford
    Bedfordshire
    Director
    Sails Cottage 7 Windmill Hill
    Biddenham
    MK40 4AG Bedford
    Bedfordshire
    EnglandBritish65812620001
    CLARK, Stephen Robert
    114 Hillesden Avenue
    Elstow
    MK42 9AJ Bedford
    Bedfordshire
    Director
    114 Hillesden Avenue
    Elstow
    MK42 9AJ Bedford
    Bedfordshire
    British60851690002
    CLEGGETT, Denis
    Rivendell
    West End
    NN6 7AY West Haddon
    Northamptonshire
    Director
    Rivendell
    West End
    NN6 7AY West Haddon
    Northamptonshire
    British36687060001
    COATES, Stephen William
    Duck End
    Silver Road
    MK43 7QW Stevington
    Bedfordshire
    Director
    Duck End
    Silver Road
    MK43 7QW Stevington
    Bedfordshire
    EnglandBritish18043650003
    COMBES, Richard George
    The Grange Church Road
    Westoning
    MK45 5JW Bedford
    Director
    The Grange Church Road
    Westoning
    MK45 5JW Bedford
    United KingdomBritish39280640001
    COOPER, Richard Lewis
    Kimpton Road
    LU2 0LB Luton
    Hart House Business Centre
    Bedfordshire
    England
    Director
    Kimpton Road
    LU2 0LB Luton
    Hart House Business Centre
    Bedfordshire
    England
    EnglandBritish154035330001
    CUMMING, Graham Jackson
    Tudor House 19 Ashpole Furlong
    Loughton
    MK5 8EA Milton Keynes
    Director
    Tudor House 19 Ashpole Furlong
    Loughton
    MK5 8EA Milton Keynes
    British22410440002
    DAVIES, Lawrence Frederick
    29 Derwent Road
    AL5 3PA Harpenden
    Hertfordshire
    Director
    29 Derwent Road
    AL5 3PA Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritish73002440001
    DE LA SALLE, Brian John
    5 Beech Ridge Kinsbourne Green Lane
    AL5 3NS Harpenden
    Hertfordshire
    Director
    5 Beech Ridge Kinsbourne Green Lane
    AL5 3NS Harpenden
    Hertfordshire
    British28514140002
    EALES, David Murray
    5 Rothsay Gardens
    MK40 3QA Bedford
    Bedfordshire
    Director
    5 Rothsay Gardens
    MK40 3QA Bedford
    Bedfordshire
    EnglandBritish124941810001
    EARLEY, Stuart Douglas
    Woodedge
    Dalefords Lane
    CW8 2BN Whitegate
    Cheshire
    Director
    Woodedge
    Dalefords Lane
    CW8 2BN Whitegate
    Cheshire
    British121358110001
    FELLOWS, John William
    Blackberry House Berghers Hill
    Wooburn Green
    HP10 0JP High Wycombe
    Buckinghamshire
    Director
    Blackberry House Berghers Hill
    Wooburn Green
    HP10 0JP High Wycombe
    Buckinghamshire
    EnglandBritish20018280001
    FOUNTAIN, Eric Dudley
    41 Church Road
    Westoning
    MK45 5LP Bedford
    Bedfordshire
    Director
    41 Church Road
    Westoning
    MK45 5LP Bedford
    Bedfordshire
    British11809990001
    FRASER, Peter
    34 Blakeney Drive
    LU2 7AL Luton
    Bedfordshire
    Director
    34 Blakeney Drive
    LU2 7AL Luton
    Bedfordshire
    British48133930002
    GILDEA, John Francis
    St Julian's Place
    Haynes West End
    MK45 3QU Bedford
    Bedfordshire
    Director
    St Julian's Place
    Haynes West End
    MK45 3QU Bedford
    Bedfordshire
    Irish58592680001
    GILSON, Andrew Robert
    Kimpton Road
    LU2 0LB Luton
    Hart House Business Centre
    Bedfordshire
    England
    Director
    Kimpton Road
    LU2 0LB Luton
    Hart House Business Centre
    Bedfordshire
    England
    EnglandBritish153325350001
    GOOSE, Margaret Elizabeth
    24 Upper Shelton Road
    MK43 0LT Marston Moretaine
    Bedfordshire
    Director
    24 Upper Shelton Road
    MK43 0LT Marston Moretaine
    Bedfordshire
    United KingdomBritish118321370001
    HALHEAD, Robert
    Red Roke
    Roke
    OX10 6JD Wallingford
    Oxfordshire
    Director
    Red Roke
    Roke
    OX10 6JD Wallingford
    Oxfordshire
    British67071180002

    ¿Tiene INTERBUSINESS GROUP LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 20 oct 2011
    Entregado el 22 oct 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 22 oct 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 14 ene 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 16 abr 1991
    Entregado el 20 abr 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge and/or the facility letters
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Secretary of State for Employment Training Enterprise and Education Directstate
    Transacciones
    • 20 abr 1991Registro de una carga
    • 23 dic 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0