ANTON PRIVATE CAPITAL LIMITED

ANTON PRIVATE CAPITAL LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaANTON PRIVATE CAPITAL LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02508326
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de ANTON PRIVATE CAPITAL LIMITED?

    • (6603) /

    ¿Dónde se encuentra ANTON PRIVATE CAPITAL LIMITED?

    Dirección de la sede social
    1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ANTON PRIVATE CAPITAL LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    KILN COTESWORTH STEWART LIMITED 18 mar 199718 mar 1997
    KILN COTESWORTH MEMBERS AGENCY LIMITED06 ene 199406 ene 1994
    KILN MEMBERS AGENCY LIMITED29 jun 199029 jun 1990
    FLOWFACTOR LIMITED04 jun 199004 jun 1990

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de ANTON PRIVATE CAPITAL LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2008

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para ANTON PRIVATE CAPITAL LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    6 páginas4.71

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 28 jul 2012

    7 páginas4.68

    Domicilio social registrado cambiado de Fountain House C/O Argenta Private Capital Limited, 130 Fenchurch Street London EC3M 5DJ el 05 sept 2011

    2 páginasAD01

    Declaración de solvencia

    5 páginas4.70

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 29 jul 2011

    LRESSP

    Cese del nombramiento de Ian Taylor como director

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 21 ene 2011 avec liste complète des actionnaires

    14 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital24 ene 2011

    Estado de capital el 24 ene 2011

    • Capital: GBP 500,200
    SH01

    Déclaration annuelle établie au 21 ene 2010 avec liste complète des actionnaires

    10 páginasAR01

    Cambio de datos del director Fiona Ann Blood el 21 ene 2010

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director William David Robson el 21 ene 2010

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director John Robert Robson el 21 ene 2010

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Antony John Smithson el 21 ene 2010

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Ian Auburn Cowing Taylor el 21 ene 2010

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Milka Jacoby el 21 ene 2010

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Andrew Michael Colcomb el 21 ene 2010

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Christopher John Rupert Fairs el 21 ene 2010

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Robert Paul Flach el 21 ene 2010

    2 páginasCH01

    Exercice comptable en cours prolongé du 31 dic 2009 au 30 jun 2010

    1 páginasAA01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2008

    17 páginasAA

    legacy

    7 páginas363a

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2007

    15 páginasAA

    legacy

    7 páginas363a

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2006

    16 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de ANTON PRIVATE CAPITAL LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    COLCOMB, Andrew Michael
    128 High Street
    Hadleigh
    IP7 5EL Ipswich
    Suffolk
    Secretario
    128 High Street
    Hadleigh
    IP7 5EL Ipswich
    Suffolk
    British81668440001
    BLOOD, Fiona Ann
    32 Vale Road
    KT10 0NJ Claygate
    Surrey
    Director
    32 Vale Road
    KT10 0NJ Claygate
    Surrey
    EnglandBritish75768690001
    BRAY, Jeremy Mark
    The High Beeches
    Handcross
    RH17 6QH West Sussex
    Director
    The High Beeches
    Handcross
    RH17 6QH West Sussex
    EnglandBritish23885670002
    COLCOMB, Andrew Michael
    128 High Street
    Hadleigh
    IP7 5EL Ipswich
    Suffolk
    Director
    128 High Street
    Hadleigh
    IP7 5EL Ipswich
    Suffolk
    United KingdomBritish81668440001
    FAIRS, Christopher John Rupert
    6 Tufa Close
    Walderslade Woods
    ME5 9LU Chatham
    Kent
    Director
    6 Tufa Close
    Walderslade Woods
    ME5 9LU Chatham
    Kent
    United KingdomBritish63723860002
    FLACH, Robert Paul
    4 Old Hatch Manor
    HA4 8QG Ruislip
    Middlesex
    Director
    4 Old Hatch Manor
    HA4 8QG Ruislip
    Middlesex
    EnglandBritish253187050001
    JACOBY, Milka
    14 Park Way
    Shenfield
    CM15 8LH Brentwood
    Essex
    Director
    14 Park Way
    Shenfield
    CM15 8LH Brentwood
    Essex
    United KingdomBritish29062500001
    ROBSON, John Robert
    Melbourne Stud
    Ayton Green
    AL6 9BB Welwyn
    Hertfordshire
    Director
    Melbourne Stud
    Ayton Green
    AL6 9BB Welwyn
    Hertfordshire
    EnglandBritish24465330001
    ROBSON, William David
    The Woods
    Hatfield Broadoak
    CM22 7BU Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Director
    The Woods
    Hatfield Broadoak
    CM22 7BU Bishops Stortford
    Hertfordshire
    United KingdomBritish7309190001
    SMITHSON, Antony John
    1 Cardwell Crescent
    Sunninghill
    SL5 9AW Ascot
    Berkshire
    Director
    1 Cardwell Crescent
    Sunninghill
    SL5 9AW Ascot
    Berkshire
    United KingdomBritish16035440001
    BUTLER, Roy Joseph
    Heydour,24 Glebe Road
    Purley On Thames
    RG8 8DP Reading
    Berkshire
    England
    Secretario
    Heydour,24 Glebe Road
    Purley On Thames
    RG8 8DP Reading
    Berkshire
    England
    British39597150001
    KAUNTZE, Ralph Anthony Charles
    Hansford House
    EX37 9ES Umberleigh
    North Devon
    Secretario
    Hansford House
    EX37 9ES Umberleigh
    North Devon
    British14338500002
    TAYLOR, Ian Auburn Cowing
    Cherry Cottage Sandpit Hall Road
    Chobham
    GU24 8HA Woking
    Surrey
    Secretario
    Cherry Cottage Sandpit Hall Road
    Chobham
    GU24 8HA Woking
    Surrey
    British4866920001
    AITCHISON, Peter John
    Upper Weston House
    Cot Lane, Chidham
    PO18 8SU Chichester
    West Sussex
    Director
    Upper Weston House
    Cot Lane, Chidham
    PO18 8SU Chichester
    West Sussex
    British3693350002
    BONNER, Alan James
    Widdington Hall Church Lane
    Widdington
    CB11 3SF Saffron Walden
    Essex
    Director
    Widdington Hall Church Lane
    Widdington
    CB11 3SF Saffron Walden
    Essex
    British36779200001
    BUTLER, Roy Joseph
    Heydour,24 Glebe Road
    Purley On Thames
    RG8 8DP Reading
    Berkshire
    England
    Director
    Heydour,24 Glebe Road
    Purley On Thames
    RG8 8DP Reading
    Berkshire
    England
    British39597150001
    COMBE, Kenneth Christian
    Ashlands Court
    SN16 9SR Malmesbury
    Wiltshire
    Director
    Ashlands Court
    SN16 9SR Malmesbury
    Wiltshire
    British3787020003
    DANN, David Linton
    Cuppes House Bells Lane
    Hoo
    ME3 9HT Rochester
    Kent
    Director
    Cuppes House Bells Lane
    Hoo
    ME3 9HT Rochester
    Kent
    British8646650001
    DUNKLEY, Christopher Leslie
    Knowle Hill House
    Ulcombe
    ME17 1ES Maidstone
    Kent
    Director
    Knowle Hill House
    Ulcombe
    ME17 1ES Maidstone
    Kent
    EnglandBritish7932240001
    FLEMING-WILLIAMS, Robert Andrew
    13 Woodborough Road
    SW15 6DY London
    Director
    13 Woodborough Road
    SW15 6DY London
    United KingdomBritish173325840001
    GABB, Anthony Hugh Samuel
    Updown House
    Hook Heath Road
    GU22 0QF Woking
    Surrey
    Director
    Updown House
    Hook Heath Road
    GU22 0QF Woking
    Surrey
    United KingdomBritish72717340002
    GILBART SMITH, Brian Martin
    The Coach House Twyford Road
    Waltham St Lawrence
    RG10 0HE Reading
    Berkshire
    Director
    The Coach House Twyford Road
    Waltham St Lawrence
    RG10 0HE Reading
    Berkshire
    EnglandBritish46668550001
    GRAVES, Adrian George
    The Old Vicarage
    Matching
    CM17 0QZ Harlow
    Essex
    Director
    The Old Vicarage
    Matching
    CM17 0QZ Harlow
    Essex
    EnglandUnited Kingdom36906810001
    GREEN, Jonathan Napier
    7 Earls Court Gardens
    SW5 0TD London
    Director
    7 Earls Court Gardens
    SW5 0TD London
    United KingdomBritish60228850001
    HARPER, Robert John
    Little Puxted
    Brenchley
    Tonbridge
    Kent
    Director
    Little Puxted
    Brenchley
    Tonbridge
    Kent
    British23885690001
    JUDD, Christopher
    Tendrings Farm
    Thaxted Road, Debden
    CB11 3LT Saffron Walden
    Essex
    Director
    Tendrings Farm
    Thaxted Road, Debden
    CB11 3LT Saffron Walden
    Essex
    British63845020002
    KAUNTZE, Ralph Anthony Charles
    Hansford House
    EX37 9ES Umberleigh
    North Devon
    Director
    Hansford House
    EX37 9ES Umberleigh
    North Devon
    British14338500002
    MARSHALL, Denis Alfred, Sir
    Redways
    Warfleet Road
    TQ6 9BZ Dartmouth
    Devon
    Director
    Redways
    Warfleet Road
    TQ6 9BZ Dartmouth
    Devon
    British105410001
    SHARP, Anthony Arthur Vivian
    Rookhurst House Colwell Lane
    RH17 7SR Haywards Heath
    West Sussex
    Director
    Rookhurst House Colwell Lane
    RH17 7SR Haywards Heath
    West Sussex
    British40355820001
    SHIPTON, John Keith
    Little Beadles
    Kings Avenue, Sandwich Bay
    CT13 9PG Sandwich
    Kent
    Director
    Little Beadles
    Kings Avenue, Sandwich Bay
    CT13 9PG Sandwich
    Kent
    EnglandBritish65780490001
    SOUTH, Anthony Ian Godfrey Charles
    Reightons, Houghton Green Lane
    Playden
    TN31 7PJ Rye
    East Sussex
    Director
    Reightons, Houghton Green Lane
    Playden
    TN31 7PJ Rye
    East Sussex
    British32778400003
    TAYLOR, Ian Auburn Cowing
    Cherry Cottage Sandpit Hall Road
    Chobham
    GU24 8HA Woking
    Surrey
    Director
    Cherry Cottage Sandpit Hall Road
    Chobham
    GU24 8HA Woking
    Surrey
    United KingdomBritish4866920001
    TAYLOR, Ian Auburn Cowing
    Cherry Cottage Sandpit Hall Road
    Chobham
    GU24 8HA Woking
    Surrey
    Director
    Cherry Cottage Sandpit Hall Road
    Chobham
    GU24 8HA Woking
    Surrey
    United KingdomBritish4866920001
    TAYLOR, John Joseph
    14 The Grove
    DA6 8HF Bexleyheath
    Kent
    Director
    14 The Grove
    DA6 8HF Bexleyheath
    Kent
    British3787030001
    WHITEHURST, David
    31 Sawyers Grove
    CM15 9BD Brentwood
    Essex
    Director
    31 Sawyers Grove
    CM15 9BD Brentwood
    Essex
    United KingdomBritish3693340001

    ¿Tiene ANTON PRIVATE CAPITAL LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Deposit agreement to secure own liabilities
    Creado el 04 ago 1998
    Entregado el 07 ago 1998
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The deposit and all such rights to the repayment thereof as the company may at any time have under the terms upon which the deposit was made and the provisions contained in the agreement premier interest account 7024118.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 07 ago 1998Registro de un cargo (395)
    Deed of charge ("the deed") and made between the names and trustees (each defined therein) constituting the syndicate 33 1998 sterling borrowing group as chargors, hiscox syndicates limited and credit suisse first boston (the "bank") as chargee
    Creado el 22 ene 1998
    Entregado el 03 feb 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    A revolving loan facility in an aggregate amount of £100,000,000 or its equivalent from time to time in us dollars
    Breve descripción
    The trustees charge, by way of first floating charge, if and to the extent that such assets are or are liable in the future to become comprised in that part of the trust fund of the name in relation to which the managing agent has power to give directions all those particulars as detailed on form M395.
    Personas con derecho
    • Credit Suisse First Boston
    Transacciones
    • 03 feb 1998Registro de un cargo (395)
    • 01 jun 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of charge ("the deed") and made between the names and trustees (each defined therein) constituting the syndicate 33 1998 dollar borrowing group as chargors, hiscox syndicates limited and credit suisse first boston (the "bank") as chargee
    Creado el 22 ene 1998
    Entregado el 03 feb 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    A revolving loan facility in an aggregate amount £100,000,000 or it's equivalent from time to time in us dollars
    Breve descripción
    The trustees charge, by way of first floating charge if and to the extent that such assets are or liable in the future to become comprised in that part of the trust fund of the name in relation to which the managing agent has power to give directions all those particulars as detailed on form M395.
    Personas con derecho
    • Credit Suisse First Boston
    Transacciones
    • 03 feb 1998Registro de un cargo (395)
    • 01 jun 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene ANTON PRIVATE CAPITAL LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    29 jul 2011Inicio de la liquidación
    08 ene 2014Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Sean Kenneth Croston
    1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire
    Profesional
    1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0