CLEAN DRAINS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCLEAN DRAINS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02510595
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de CLEAN DRAINS LIMITED?

    • Alcantarillado (37000) / Captación, depuración y distribución de agua; gestión de residuos; actividades de descontaminación y recuperación

    ¿Dónde se encuentra CLEAN DRAINS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Private Road 1 Colwick Industrial Estate
    Colwick
    NG4 2AN Nottingham
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CLEAN DRAINS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    L GRAY & CO LTD.11 jun 199011 jun 1990

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de CLEAN DRAINS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 jul 2013

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para CLEAN DRAINS LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para CLEAN DRAINS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Cese del nombramiento de Karen Linda Pay como director el 20 nov 2015

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Stephane Rousselot como director el 28 sept 2015

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Robert Grund como director el 11 sept 2015

    1 páginasTM01

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Déclaration annuelle établie au 11 jun 2015 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital08 jul 2015

    Estado de capital el 08 jul 2015

    • Capital: GBP 61
    SH01

    Cese del nombramiento de Melanie Linda Sowter como director el 31 mar 2015

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Melanie Linda Sowter como secretario el 31 mar 2015

    1 páginasTM02

    Exercice comptable précédent raccourci du 31 jul 2014 au 30 jul 2014

    1 páginasAA01

    Nombramiento de Mr Robert Grund como director el 27 nov 2014

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mrs Karen Linda Pay como director el 27 nov 2014

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Peter John Lewington como director el 27 nov 2014

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 11 jun 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital18 jun 2014

    Estado de capital el 18 jun 2014

    • Capital: GBP 61
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 jul 2013

    11 páginasAA

    Exercice comptable précédent prolongé du 30 abr 2013 au 31 jul 2013

    1 páginasAA01

    Déclaration annuelle établie au 11 jun 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cese del nombramiento de Charles White como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Michael Bell como secretario

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Michael Bell como director

    1 páginasTM01

    Domicilio social registrado cambiado de * Unit 1 106 Hawley Lane Farnborough Hampshire GU14 8JE* el 29 ago 2013

    1 páginasAD01

    Cese del nombramiento de Michael Bell como secretario

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Mrs Melanie Linda Sowter como secretario

    1 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Michael Bell como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Peter John Lewington como director

    2 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de CLEAN DRAINS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    ROUSSELOT, Stephane
    Colwick Industrial Estate
    Colwick
    NG4 2AN Nottingham
    Private Road 1
    Director
    Colwick Industrial Estate
    Colwick
    NG4 2AN Nottingham
    Private Road 1
    EnglandFrenchFinance Director202797810001
    BELL, Michael Hugh
    4 Hugh De Port Lane
    GU51 1HT Fleet
    Hampshire
    Secretario
    4 Hugh De Port Lane
    GU51 1HT Fleet
    Hampshire
    BritishDirector90062470004
    MORLEY, Peta
    C/O L Gray & Co Ltd
    The Workshop Fryers Lane
    HP12 3AN High Wycombe
    Buckinghamshire
    Secretario
    C/O L Gray & Co Ltd
    The Workshop Fryers Lane
    HP12 3AN High Wycombe
    Buckinghamshire
    BritishAdmin Manager71290990002
    SOWTER, Melanie Linda
    Colwick Industrial Estate
    Colwick
    NG4 2AN Nottingham
    Private Road 1
    England
    Secretario
    Colwick Industrial Estate
    Colwick
    NG4 2AN Nottingham
    Private Road 1
    England
    179710830001
    WALLIS, Jane
    Dawes East House
    28 High Street
    SL1 1JH Burnham
    Secretario
    Dawes East House
    28 High Street
    SL1 1JH Burnham
    British40339290001
    WILLIAMS, Sheralyn Jane
    231 Uxbridge Road
    WD3 8DP Rickmansworth
    Herts
    Secretario
    231 Uxbridge Road
    WD3 8DP Rickmansworth
    Herts
    British114111550001
    COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Admirals Quarters Portsmouth Road
    KT7 0XA Thames Ditton
    Surrey
    Secretario corporativo
    Admirals Quarters Portsmouth Road
    KT7 0XA Thames Ditton
    Surrey
    1955640003
    BELL, Michael Hugh
    4 Hugh De Port Lane
    GU51 1HT Fleet
    Hampshire
    Director
    4 Hugh De Port Lane
    GU51 1HT Fleet
    Hampshire
    EnglandBritishDirector90062470004
    COLE, Peter Christopher
    14 Carlyle Court
    Chelsea Harbour
    SW10 0UQ London
    Director
    14 Carlyle Court
    Chelsea Harbour
    SW10 0UQ London
    BritishInsurance Assessor49353790001
    GRUND, Robert
    Colwick Industrial Estate
    Colwick
    NG4 2AN Nottingham
    Private Road 1
    Director
    Colwick Industrial Estate
    Colwick
    NG4 2AN Nottingham
    Private Road 1
    EnglandAustrianFinance Director182385330001
    HOWARD, Michael George
    Dawes East House
    28 High Street
    SL1 7JH Burnham
    Buckinghamshire
    Director
    Dawes East House
    28 High Street
    SL1 7JH Burnham
    Buckinghamshire
    BritishRetired19282030003
    JOHN, Iain Martyn
    106 Hawley Lane
    GU14 8JE Farnborough
    Unit 1
    Hampshire
    Director
    106 Hawley Lane
    GU14 8JE Farnborough
    Unit 1
    Hampshire
    EnglandBritishFinance Director98630830002
    LEWINGTON, Peter John
    Colwick Industrial Estate
    Colwick
    NG4 2AN Nottingham
    Private Road 1
    England
    Director
    Colwick Industrial Estate
    Colwick
    NG4 2AN Nottingham
    Private Road 1
    England
    EnglandBritishManaging Director137420410001
    MANTLE, Adrian Ralph Pierson
    13 Whiteoak Drive
    BR3 6QE Beckenham
    Kent
    Director
    13 Whiteoak Drive
    BR3 6QE Beckenham
    Kent
    EnglandBritishInsurance Assessor100821120001
    PAY, Karen Linda
    Colwick Industrial Estate
    Colwick
    NG4 2AN Nottingham
    Private Road 1
    Director
    Colwick Industrial Estate
    Colwick
    NG4 2AN Nottingham
    Private Road 1
    EnglandBritishHr Director176337440001
    SOWTER, Melanie Linda
    Colwick Industrial Estate
    Colwick
    NG4 2AN Nottingham
    Private Road 1
    England
    Director
    Colwick Industrial Estate
    Colwick
    NG4 2AN Nottingham
    Private Road 1
    England
    EnglandBritishFinancial Director113352030002
    WALLIS, Jane
    28 High Street
    Burnham
    SL1 7JH Slough
    Director
    28 High Street
    Burnham
    SL1 7JH Slough
    EnglandBritishManaging Director110695980001
    WHITE, Charles Liddell
    Avon Castle Drive
    BH24 2BE Ringwood
    53
    Hampshire
    Director
    Avon Castle Drive
    BH24 2BE Ringwood
    53
    Hampshire
    EnglandBritishDirector54824060002
    WILLIAMS, Keith Douglas
    231 Uxbridge Road
    WD3 8DP Rickmansworth
    Herts
    Director
    231 Uxbridge Road
    WD3 8DP Rickmansworth
    Herts
    EnglandBritishCompany Director28541730003
    WILLIAMS, Thomas
    9 Montgomery Road
    Huyton
    L36 7UY Liverpool
    Merseyside
    Director
    9 Montgomery Road
    Huyton
    L36 7UY Liverpool
    Merseyside
    BritishWaste Manager57587590001

    ¿Tiene CLEAN DRAINS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A guarantee and security agreement
    Creado el 07 abr 2009
    Entregado el 17 abr 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the issuer and/or the company to the security trustee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All its right title and interest in the mortgaged property together with allbuildings and fixtures thereon the proceeds of sale by way of floating charge all its undertaking and assets see image for full details.
    Personas con derecho
    • Inflexion Private Equity Partners LLP
    Transacciones
    • 17 abr 2009Registro de un cargo (395)
    • 09 feb 2013Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    An accession deed
    Creado el 07 abr 2009
    Entregado el 16 abr 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the security trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All its right title and interest in the mortgaged property all buildings and fixtures thereon the proceeds of sale by way of floating charge all its undertaking and assets see image for full details.
    Personas con derecho
    • Inflexion Private Equity Partners LLP
    Transacciones
    • 16 abr 2009Registro de un cargo (395)
    • 09 feb 2013Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 07 abr 2009
    Entregado el 11 abr 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 11 abr 2009Registro de un cargo (395)
    • 20 abr 2009
    • 09 feb 2013Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 04 oct 2000
    Entregado el 13 oct 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 13 oct 2000Registro de un cargo (395)
    • 09 feb 2013Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0