BLAF (NO. 9) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaBLAF (NO. 9) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02512601
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de BLAF (NO. 9) LIMITED?

    • Arrendamiento financiero (64910) / Actividades financieras y de seguros

    ¿Dónde se encuentra BLAF (NO. 9) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Hill House 1
    Little New Street
    EC4A 3TR London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de BLAF (NO. 9) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2012

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para BLAF (NO. 9) LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para BLAF (NO. 9) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Resolución de insolvencia

    Resolution insolvency:resolution re. Statement of account
    1 páginasLIQ MISC RES

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    4 páginas4.71

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado de 1 Churchill Place London E14 5HP

    2 páginasAD02

    Domicilio social registrado cambiado de * Churchill Plaza Churchill Way Basingstoke Hampshire RG21 7GP* el 08 ago 2013

    2 páginasAD01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    2 páginas600

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación

    LRESSP

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2012

    25 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 01 jun 2013 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital13 jun 2013

    Estado de capital el 13 jun 2013

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Exercice comptable précédent raccourci du 09 may 2013 au 31 dic 2012

    1 páginasAA01

    Cuentas completas preparadas hasta el 09 may 2012

    27 páginasAA

    Exercice comptable précédent raccourci du 31 dic 2012 au 09 may 2012

    1 páginasAA01

    Déclaration annuelle établie au 01 jun 2012 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2011

    26 páginasAA

    Cese del nombramiento de Thomas Geoffrey Ridout como director

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 01 jun 2011 avec liste complète des actionnaires

    8 páginasAR01

    Nombramiento de Mr Jeremy Marchant como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Darren Hare como director

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2010

    25 páginasAA

    Nombramiento de Thomas Geoffrey Ridout como director

    2 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de BLAF (NO. 9) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BARCOSEC LIMITED
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Secretario corporativo
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    49004930002
    LEATHER, Jonathan Terence
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Director
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    EnglandBritish69140360004
    ROWBERRY, Duncan John
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Director
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    EnglandBritish49237880004
    WATSON, Hazel Anne Marie
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Director
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    EnglandIrish122291210001
    MCMILLAN, Richard John
    17 Hawthorn Close
    Colden Common
    SO21 1UX Winchester
    Hampshire
    Secretario
    17 Hawthorn Close
    Colden Common
    SO21 1UX Winchester
    Hampshire
    British68601920001
    SHOOLBRED, Charles Frederick
    Timbers
    Dean Oak Lane
    RH2 8PZ Leigh
    Surrey
    Secretario
    Timbers
    Dean Oak Lane
    RH2 8PZ Leigh
    Surrey
    British540290002
    ABLITT, Denis Raymond
    Woodcocks
    38 Park Avenue, Old Basing
    RG24 7HT Basingstoke
    Hampshire
    Director
    Woodcocks
    38 Park Avenue, Old Basing
    RG24 7HT Basingstoke
    Hampshire
    British71782000001
    BOOBYER, Christopher Leslie Richard
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    Director
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    British92233050001
    BOX, Sarah
    Court Lodge Lower Road
    West Farleigh
    ME15 0PD Maidstone
    Kent
    Director
    Court Lodge Lower Road
    West Farleigh
    ME15 0PD Maidstone
    Kent
    British47381630004
    CALLENDER, John Dalrymple
    Fairway Heights
    GU15 1NJ Camberley
    14
    Surrey
    Director
    Fairway Heights
    GU15 1NJ Camberley
    14
    Surrey
    United KingdomBritish2444200001
    CLARK, Thomas Martin
    Hatch Hill Hatch Lane
    Kingsley Green
    GU27 3LJ Haslemere
    Surrey
    Director
    Hatch Hill Hatch Lane
    Kingsley Green
    GU27 3LJ Haslemere
    Surrey
    British5529800001
    DOWDING, Eric Robert
    23 Waldorf Heights
    Blackwater Howley Hill
    GU17 9JH Camberley
    Surrey
    Director
    23 Waldorf Heights
    Blackwater Howley Hill
    GU17 9JH Camberley
    Surrey
    British46728970001
    ELLIS, David James
    Batts Row Cottage
    Laverstoke Lane, Laverstoke
    RG28 7PA Whitchurch
    Hampshire
    Director
    Batts Row Cottage
    Laverstoke Lane, Laverstoke
    RG28 7PA Whitchurch
    Hampshire
    EnglandBritish113760650001
    EVANS, Christopher Hewitt
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Director
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    British121774150001
    HARE, Darren Mark
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Director
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    United KingdomBritish127470250001
    HASSELL, Brian Charles
    10 Blenheim Close
    CM21 0BE Sawbridgeworth
    Hertfordshire
    Director
    10 Blenheim Close
    CM21 0BE Sawbridgeworth
    Hertfordshire
    Great BritainBritish45384250002
    HILLS, Richard Allan
    11 Countess Gardens
    Littledown
    BH7 7RR Bournemouth
    Dorset
    Director
    11 Countess Gardens
    Littledown
    BH7 7RR Bournemouth
    Dorset
    United KingdomBritish71778800001
    MACINTOSH, Gordon Paterson
    7 Paddock Field
    Chilbolton
    SO20 6AU Stockbridge
    Hampshire
    Director
    7 Paddock Field
    Chilbolton
    SO20 6AU Stockbridge
    Hampshire
    British25737780001
    MARCHANT, Jeremy
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Director
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    EnglandBritish154144600001
    MCMILLAN, Richard John
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Director
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    British68601920003
    MILES, Martin Graham
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Director
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    United KingdomBritish108439150001
    RIDOUT, Thomas Geoffrey
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Director
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    EnglandBritish155056490001
    ROSE, Stephen George
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Director
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    British143870380001
    ROWAN, Charles Paul
    32 Queens Park West Drive
    Queens Park
    BH8 9DD Bournemouth
    Dorset
    Director
    32 Queens Park West Drive
    Queens Park
    BH8 9DD Bournemouth
    Dorset
    British49237910001
    SILCOCK, Frank Avis
    Charleston 74 Wellhouse Road
    Beech
    GU34 4AG Alton
    Hampshire
    Director
    Charleston 74 Wellhouse Road
    Beech
    GU34 4AG Alton
    Hampshire
    British32895910001
    WEAL, Barry
    Orchard Gate
    Mill Lane Bramley
    GU5 0HW Guildford
    Surrey
    Director
    Orchard Gate
    Mill Lane Bramley
    GU5 0HW Guildford
    Surrey
    British40203100001
    WEAVING, John Martin
    57 Bridle Way
    Colehill
    BH21 2UP Wimborne
    Dorset
    Director
    57 Bridle Way
    Colehill
    BH21 2UP Wimborne
    Dorset
    British58523120001
    BARCOSEC LIMITED
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    Director corporativo
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    49004930001
    BAROMETERS LIMITED
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    Director corporativo
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    57357300002

    ¿Tiene BLAF (NO. 9) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A first priority norwegian mortgage
    Creado el 01 abr 2004
    Entregado el 20 abr 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies up to usd 50,000,000 from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The norwegian registered vessel M.V. jo acer (ex hull no.351 At kitanihon shipbuilding co, LTD) and in her equipment and appurtenances.
    Personas con derecho
    • Hsbc Intermediate (UK) Limited
    Transacciones
    • 20 abr 2004Registro de un cargo (395)
    • 25 may 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    An assignment of builder's warranties
    Creado el 01 abr 2004
    Entregado el 15 abr 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All rights title interest in the warranies,as defined. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Hsbc Intermediate Leasing (UK) Limited
    Transacciones
    • 15 abr 2004Registro de un cargo (395)
    • 25 may 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    A deed of covenant
    Creado el 01 abr 2004
    Entregado el 14 abr 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All the companys right title benefit and interest present and future in and to the companys insurance of M.V. 'jo acer'. All sums of money or other compensation from time to time payable in respect of the compulsory acquisition or requisition of the vessel. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Hsbc Intermediate Leasing (UK) Limited
    Transacciones
    • 14 abr 2004Registro de un cargo (395)
    • 25 may 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    A lessor proceeds account assignment
    Creado el 09 jul 2003
    Entregado el 16 jul 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All the company's rights, title and interest, present and future, in and to: (a) the interest bearing dollar account (as defined) (b) the interest bearing sterling account (as defined) (c) all moneys from time to time credited to, and for the time being standing to the credit of, the accounts, and (d) all interest and other amounts from time to time payable in respect of, or accruing to, the accounts.
    Personas con derecho
    • Hsbc Intermediate Leasing (UK) Limited
    Transacciones
    • 16 jul 2003Registro de un cargo (395)
    • 25 may 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Subleassee security agreement
    Creado el 30 dic 1992
    Entregado el 14 ene 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    For securing the performance of certain covenants due or to become due from the company yo the chargee under the terms of the sublease dated 24/11/92 and from the company under the terms of the head lease dated 24/11/92
    Breve descripción
    By way of assignment all the grantor's interest in to and under the head lease, the head security agreement etc. (see form 395 for full details).
    Personas con derecho
    • Triborough Bridge and Tunnel Authority
    Transacciones
    • 14 ene 1993Registro de un cargo (395)
    • 15 sept 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Secondary lease security assignment
    Creado el 30 dic 1992
    Entregado el 13 ene 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from i/s elmeskud and/or niels peter nielsen to barclays bank PLC under the terms of the loan agreement dated 30/12/92
    Breve descripción
    By way of assignment to the bank all the lessee's right title and interest in and to the assigned payments and all sums paid or payable in respect thereof whether payable to triborough bridge and tunnel authority or any person makeing any such payment on behalf of or instead of the secondary lessee (see form 395 for full details).
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 13 ene 1993Registro de un cargo (395)
    • 15 sept 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene BLAF (NO. 9) LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    30 jul 2013Inicio de la liquidación
    01 jul 2014Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Christopher Richard Frederick Day
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Profesional
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Stephen Roland Browne
    Athene Place
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Profesional
    Athene Place
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0