02516074 LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | 02516074 LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 02516074 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | Sí |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de 02516074 LIMITED?
- (1824) /
- (9999) /
¿Dónde se encuentra 02516074 LIMITED?
Dirección de la sede social | C/O Pricewaterhousecoopers Llp 12 Plumtree Court EC4A 4HT London |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de 02516074 LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
BROOMCO (387) LIMITED | 27 jun 1990 | 27 jun 1990 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de 02516074 LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2003 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para 02516074 LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación obligatoria | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria | páginas | GAZ1 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Graham Robert Adams como director el 07 nov 2005 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Restauración por orden judicial | 5 páginas | AC92 | ||||||||||
Certificado de cambio de nombre Company name changed s r gent (uk)\certificate issued on 17/12/15 | páginas | CERTNM | ||||||||||
Boletín oficial final disuelto por cancelación obligatoria | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria | 1 páginas | GAZ1 | ||||||||||
Resumen de ingresos y gastos del administrador concursal hasta 28 jul 2011 | 3 páginas | 3.6 | ||||||||||
legacy | 2 páginas | LQ02 | ||||||||||
Resumen de ingresos y gastos del administrador concursal hasta 31 ago 2010 | 3 páginas | 3.6 | ||||||||||
Resumen de ingresos y gastos del administrador concursal hasta 31 ago 2009 | 3 páginas | 3.6 | ||||||||||
Resumen de ingresos y gastos del administrador concursal hasta 31 ago 2008 | 3 páginas | 3.6 | ||||||||||
Resumen de ingresos y gastos del administrador concursal | 3 páginas | 3.6 | ||||||||||
Informe del receptor administrativo | 7 páginas | 3.10 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | 287 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | 405(1) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria | 1 páginas | GAZ1 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | 288b | ||||||||||
legacy | 1 páginas | 288b | ||||||||||
legacy | 2 páginas | 288a | ||||||||||
legacy | 7 páginas | 363s | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 2 páginas | 288a | ||||||||||
legacy | 3 páginas | 288a | ||||||||||
legacy | 1 páginas | 288b | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2003 | 7 páginas | AA |
¿Quiénes son los directivos de 02516074 LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESAI, Naren | Secretario | 65 Balcombe Road RH16 1PE Haywards Heath West Sussex | British | Chartered Accountant | 102054630001 | |||||
DESAI, Naren | Director | 65 Balcombe Road RH16 1PE Haywards Heath West Sussex | England | British | Chartered Accountant | 102054630001 | ||||
ADLER, Bernard | Secretario | Rushfield Arkenley Lane Almondbury HD4 6SQ Huddersfield West Yorkshire | British | 66063970001 | ||||||
CROUTHERS, Thomas Arthur | Secretario | Chestnut Close 4 Smithies Lane S75 1BH Barnsley South Yorkshire | British | Director | 29175970001 | |||||
ADAMS, Graham Robert | Director | Sunnyside 11 Sparken Hill S80 1AX Worksop Nottinghamshire | England | British | Finance Director | 98107180001 | ||||
ADLER, Bernard | Director | Rushfield Arkenley Lane Almondbury HD4 6SQ Huddersfield West Yorkshire | British | Director And Company Secretary | 66063970001 | |||||
BALL, Brian Vincent | Director | The Old Vicarage Church Hill Sherburn In Elmet LS25 6AX Leeds | England | British | Director | 42904960001 | ||||
BOOTH, Leslie Paul | Director | 4 Dobcroft Close S11 9LL Sheffield South Yorkshire | British | Director | 3257150002 | |||||
CROUTHERS, Thomas Arthur | Director | Chestnut Close 4 Smithies Lane S75 1BH Barnsley South Yorkshire | British | Director | 29175970001 | |||||
FRANKS, Richard Steven | Director | Lindley House Oxhey Drive South HA6 3ET Northwood Middlesex | British | Director | 100476030001 | |||||
FRANKS, Richard Steven | Director | Lindley House Oxhey Drive South HA6 3ET Northwood Middlesex | British | Director | 100476030001 | |||||
FROST, Brian Joseph | Director | 4 Newlands Gate Warley HX2 7SU Halifax West Yorkshire | British | Company Director | 35934120001 | |||||
HOLMES, David, Mr. | Director | Highfield House Carleton Road Darrington WF8 3AG Pontefract West Yorkshire | England | British | Director | 16062100001 | ||||
KAHN, David Carl | Director | White Lodge 36 Wolsey Road HA6 2EN Northwood Middlesex | British | Director | 66901400001 | |||||
MORGAN, Wynford Vaughan | Director | 3 North Farm Court Aston S31 0EU Sheffield South Yorkshire | British | Company Director | 50048080001 | |||||
PLAUT, David Laurence | Director | 9 Wentworth Terrace WF1 3QW Wakefield West Yorkshire | British | Director | 16062040001 | |||||
RENSHAW, Alan George | Director | 1 Pinchwell View Wickersley S66 1FP Rotherham South Yorkshire | England | British | Director | 69838110002 | ||||
RENSHAW, Alan George | Director | 1 Pinchwell View Wickersley S66 1FP Rotherham South Yorkshire | England | British | Director | 69838110002 | ||||
SCADDAN, John Philip | Director | Sunshine House Chenies Road, Chorleywood WD3 5LU Rickmansworth Hertfordshire | British | Director | 69838190001 | |||||
SCADDAN, John Philip | Director | Sunshine House Chenies Road, Chorleywood WD3 5LU Rickmansworth Hertfordshire | British | Director | 69838190001 | |||||
WETZEL, Peter | Director | Eldon House 96 Watergate Street CH1 2LF Chester | United Kingdom | British | Director | 73888990002 | ||||
WHEELER, David Julian Weightman | Director | Haddon Farm South Lane Cawthorne S75 4EQ Barnsley South Yorkshire | British | Director | 24120990001 | |||||
WHITMORE, John Henry | Director | 4 Alderson Drive Tickhill DN11 9HR Doncaster South Yorkshire | British | Director | 16061800001 | |||||
WOLFF, Michael Fielding | Director | 6 Cary Walk WD7 7DA Radlett Hertfordshire | British | Director | 50067270001 |
¿Tiene 02516074 LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Guarantee and debenture | Creado el 09 dic 1997 Entregado el 19 dic 1997 | Pendiente | Cantidad garantizada All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor (as defined) to the chargee as agent and trustee for itself and each of the lenders (as defined) or any of them under or in connection with each or any of the designated finance documents (as defined) | |
Breve descripción .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| ||||
Supplemental guarantee and debenture | Creado el 28 ene 1997 Entregado el 18 feb 1997 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All present and future obligations and liabilities in any capacity whatsoever of each obligor (as defined) to the chargee as agent and trustee for itself and each of the lenders and to the lenders (as defined) or any of them under the facilities agreement (as defined) and under clause 3 of the supplemental guarantee and debenture | |
Breve descripción .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Guarantee and debenture | Creado el 06 dic 1996 Entregado el 16 dic 1996 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under each or any of the designated finance documents (as defined) or under the standstill agreement (as defined) | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
¿Tiene 02516074 LIMITED algún caso de insolvencia?
Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Administrador judicial nombrado |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0