WAX COMMUNICATIONS LIMITED

WAX COMMUNICATIONS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaWAX COMMUNICATIONS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02516291
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de WAX COMMUNICATIONS LIMITED?

    • Agencias de publicidad (73110) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra WAX COMMUNICATIONS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    c/o MSQ PARTNERS LIMITED
    90 Tottenham Court Road
    W1T 4TJ London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de WAX COMMUNICATIONS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    DYNAMO MARKETING LIMITED06 sept 199006 sept 1990
    CHOICEHURST LIMITED27 jun 199027 jun 1990

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de WAX COMMUNICATIONS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta28 feb 2015

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para WAX COMMUNICATIONS LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para WAX COMMUNICATIONS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 28 feb 2015

    15 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 27 jun 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital16 jul 2015

    Estado de capital el 16 jul 2015

    • Capital: GBP 23,571.5
    SH01

    Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada C/O Browne Jacobson Llp 15th Floor 6 Bevis Marks London EC3A 7BA

    1 páginasAD03

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado a C/O Browne Jacobson Llp 15th Floor 6 Bevis Marks London EC3A 7BA

    1 páginasAD02

    Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 28 feb 2014

    17 páginasAA

    legacy

    29 páginasPARENT_ACC

    legacy

    1 páginasAGREEMENT2

    legacy

    3 páginasGUARANTEE2

    Memorándum y Estatutos

    32 páginasMA

    Resoluciones

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de modificación de los Artículos de Asociación

    RES01
    capital

    Resoluciones

    Various agreements as listed 16/07/2014
    RES13

    Cancelación total de la carga 5

    5 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 4

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 6

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 025162910007

    4 páginasMR04

    Domicilio social registrado cambiado de C/O Msq Partners Ltd 6 York Street London W1U 6PL a C/O Msq Partners Limited 90 Tottenham Court Road London W1T 4TJ el 13 ago 2014

    1 páginasAD01

    Registro de la carga 025162910009, creada el 16 jul 2014

    59 páginasMR01

    Registro de la carga 025162910008, creada el 16 jul 2014

    55 páginasMR01

    Déclaration annuelle établie au 27 jun 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital27 jun 2014

    Estado de capital el 27 jun 2014

    • Capital: GBP 23,570.7
    SH01

    Cese del nombramiento de Matthew Tabb como director

    1 páginasTM01

    Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 28 feb 2013

    17 páginasAA

    legacy

    3 páginasGUARANTEE2

    legacy

    27 páginasPARENT_ACC

    ¿Quiénes son los directivos de WAX COMMUNICATIONS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    SHAH, Ashish
    c/o Msq Partners Limited
    Tottenham Court Road
    W1T 4TJ London
    90
    England
    Secretario
    c/o Msq Partners Limited
    Tottenham Court Road
    W1T 4TJ London
    90
    England
    164823930001
    REID, Peter David
    c/o Msq Partners Limited
    Tottenham Court Road
    W1T 4TJ London
    90
    England
    Director
    c/o Msq Partners Limited
    Tottenham Court Road
    W1T 4TJ London
    90
    England
    EnglandBritishGroup Chief Executive147274580002
    YARDLEY, Daniel John
    c/o Msq Partners Limited
    Tottenham Court Road
    W1T 4TJ London
    90
    England
    Director
    c/o Msq Partners Limited
    Tottenham Court Road
    W1T 4TJ London
    90
    England
    EnglandBritishChief Financial Officer180507300001
    BRIGDEN, Colin John
    c/o Media Square Plc
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    United Kingdom
    Secretario
    c/o Media Square Plc
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    United Kingdom
    147348480001
    BUTTERWORTH, Michael Guy
    The Woodman,
    Howe Street, Great Waltham
    CM3 1BA Chelmsford
    Secretario
    The Woodman,
    Howe Street, Great Waltham
    CM3 1BA Chelmsford
    British76600500002
    CLARKE, Martin John
    105 Congleton Road
    SK11 7XD Macclesfield
    Cheshire
    Secretario
    105 Congleton Road
    SK11 7XD Macclesfield
    Cheshire
    British53461320002
    LEES, Jennifer Kathryn
    15-17 Huntsworth Mews
    NW1 6DD London
    Secretario
    15-17 Huntsworth Mews
    NW1 6DD London
    British24587010002
    NICHOLS, Richard Stephen
    3a Devonshire Road
    AL5 4TJ Harpenden
    Hertfordshire
    Secretario
    3a Devonshire Road
    AL5 4TJ Harpenden
    Hertfordshire
    BritishGroup Finance Director54128690001
    TOWNEND, Michael Jonathan
    4 The Fairway
    KT3 4SP New Malden
    Surrey
    Secretario
    4 The Fairway
    KT3 4SP New Malden
    Surrey
    BritishCompany Director36300310004
    VENUS, David Anthony
    86 Park Road
    KT2 5JZ Kingston Upon Thames
    Surrey
    Secretario designado
    86 Park Road
    KT2 5JZ Kingston Upon Thames
    Surrey
    British900007290001
    WINFIELD, Bruce Malcolm
    22 Hillhouse Close
    RH10 4YY Turners Hill
    West Sussex
    Secretario
    22 Hillhouse Close
    RH10 4YY Turners Hill
    West Sussex
    British147948820001
    BURNS, Graeme Ian, Mr.
    29 Moody Street
    CW12 4AN Congleton
    Cheshire
    Director
    29 Moody Street
    CW12 4AN Congleton
    Cheshire
    United KingdomBritishCompany Director75720570001
    BUSHBY, Robert Rodney
    The Coppice Coppice Lane
    RH2 9JF Reigate
    Surrey
    Director
    The Coppice Coppice Lane
    RH2 9JF Reigate
    Surrey
    BritishPhotographer27887480001
    CUNNINGHAM, Nicholas Alexander Clunie
    61 Brackenbury Road
    W6 0BG London
    Director
    61 Brackenbury Road
    W6 0BG London
    United KingdomBritishCompany Director46357340004
    DE WESSELOW, Peter Ronald
    20 Mimosa Street
    SW6 4DT London
    Director
    20 Mimosa Street
    SW6 4DT London
    BritishCompany Director43229610002
    DUNN, Benjamin Paul
    c/o Msq Partners Ltd
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    England
    Director
    c/o Msq Partners Ltd
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    England
    EnglandBritishChartered Accountant255794290001
    DUNN, Benjamin Paul
    Wayside Avenue
    WD23 4SQ Bushey
    36
    Hertfordshire
    Director
    Wayside Avenue
    WD23 4SQ Bushey
    36
    Hertfordshire
    EnglandBritishAccountant255794290001
    FARNELL, Jane
    17 Dryden Road
    Wimbledon
    SW19 8SQ London
    Director
    17 Dryden Road
    Wimbledon
    SW19 8SQ London
    BritishCo. Director33786320001
    MARCHBANKS, James Edgar Torrance
    La Falaise Jerbourg Point
    St Martin
    GY4 6BN Guernsey
    Director
    La Falaise Jerbourg Point
    St Martin
    GY4 6BN Guernsey
    BritishCompany Director62587310001
    NICHOLS, Richard Stephen
    15a Rothamsted Avenue
    AL5 2DD Harpenden
    Hertfordshire
    Director
    15a Rothamsted Avenue
    AL5 2DD Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritishCompany Director54128690003
    PRITCHARD, Neale St John
    2 Booth Drive
    Finchampstead
    RG40 4HL Wokingham
    Berkshire
    Director
    2 Booth Drive
    Finchampstead
    RG40 4HL Wokingham
    Berkshire
    BritishAssistant Managing Director61588700001
    PRITCHARD, Simon David
    Augusta
    16 Priory Lane
    RG42 2JT Warfield
    Berkshire
    Director
    Augusta
    16 Priory Lane
    RG42 2JT Warfield
    Berkshire
    BritishCompany Director32405520008
    REID, Peter David
    c/o Media Square Plc
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    United Kingdom
    Director
    c/o Media Square Plc
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector147274580002
    SANDERSON, Ian Roderick
    7 Chancellors Wharf
    Crisp Road
    W6 9RT London
    Director
    7 Chancellors Wharf
    Crisp Road
    W6 9RT London
    BritishCompany Director64022480001
    TABB, Matthew Peter Charles
    c/o Msq Partners Ltd
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    England
    Director
    c/o Msq Partners Ltd
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    England
    EnglandBritishManaging Director164212520001
    TOWNEND, Michael
    2 Braemar Avenue
    Wimbledon Park
    SW19 8AZ London
    Director
    2 Braemar Avenue
    Wimbledon Park
    SW19 8AZ London
    BritishCompany Director36300310003
    VIVIAN, Susan Dominique
    45 Cambridge Road
    Barnes
    SW13 0PG London
    Director
    45 Cambridge Road
    Barnes
    SW13 0PG London
    BritishDirector Marketing Services51863660002
    WINFIELD, Bruce Malcolm
    22 Hillhouse Close
    RH10 4YY Turners Hill
    West Sussex
    Director
    22 Hillhouse Close
    RH10 4YY Turners Hill
    West Sussex
    United KingdomBritishAccountant147948820001
    WRIGHT, Dean Anthony
    c/o Media Square Plc
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    United Kingdom
    Director
    c/o Media Square Plc
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector159138180001

    ¿Tiene WAX COMMUNICATIONS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 16 jul 2014
    Entregado el 21 jul 2014
    Pendiente
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Nvm Private Equity Limited
    Transacciones
    • 21 jul 2014Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 16 jul 2014
    Entregado el 18 jul 2014
    Pendiente
    Breve descripción
    Description of all registered intellectual property rights subject to this security can be found in schedule 5 of the debenture.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC Acting as Agent for National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 18 jul 2014Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 27 sept 2013
    Entregado el 04 oct 2013
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC as Security Trustee
    Transacciones
    • 04 oct 2013Registro de una carga (MR01)
    • 02 sept 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Supplemental debenture
    Creado el 06 feb 2012
    Entregado el 23 feb 2012
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 23 feb 2012Registro de un cargo (MG01)
    • 02 sept 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Creado el 08 dic 2011
    Entregado el 29 dic 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the companies to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Any sum standing to the credit of an account whether in sterling or any other currency or currency unit and the debt from time to time owing by the bank represented by that sum see image for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 29 dic 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 02 sept 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 08 dic 2011
    Entregado el 20 dic 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 20 dic 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 02 sept 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Accession deed
    Creado el 04 nov 2005
    Entregado el 17 nov 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the obligors to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 17 nov 2005Registro de un cargo (395)
    • 22 dic 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 18TH october 2004 and
    Creado el 12 ago 2005
    Entregado el 26 ago 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 26 ago 2005Registro de un cargo (395)
    • 22 dic 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Mortgage debenture
    Creado el 19 abr 1991
    Entregado el 24 abr 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 24 abr 1991Registro de una carga
    • 14 oct 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0