TRIBAL SECTA LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaTRIBAL SECTA LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02521785
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de TRIBAL SECTA LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra TRIBAL SECTA LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Kings Orchard Queen Street
    St. Philips
    BS2 0HQ Bristol
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de TRIBAL SECTA LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    SECTA GROUP LIMITED13 jul 199013 jul 1990

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de TRIBAL SECTA LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2014

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para TRIBAL SECTA LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para TRIBAL SECTA LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Estado de capital el 28 ene 2016

    • Capital: GBP 1
    4 páginasSH19

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Resoluciones

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06
    capital

    Resoluciones

    Share premium & merger reserve be reduced 18/12/2015
    RES13

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Déclaration annuelle établie au 13 jul 2015 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital01 oct 2015

    Estado de capital el 01 oct 2015

    • Capital: GBP 8,369
    SH01

    Nombramiento de Mr Robert Charles Garner como director el 01 jul 2015

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Keith Martin Evans como director el 30 jun 2015

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014

    5 páginasAA

    Domicilio social registrado cambiado de 1-4 Portland Square Bristol BS2 8RR a Kings Orchard Queen Street St. Philips Bristol BS2 0HQ el 04 ago 2014

    1 páginasAD01

    Cambio de datos del director Mr Stephen Derrick Breach el 05 jun 2014

    2 páginasCH01

    Déclaration annuelle établie au 13 jul 2014 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital18 jul 2014

    Estado de capital el 18 jul 2014

    • Capital: GBP 8,369
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2013

    5 páginasAA

    Cancelación total de la carga 3

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 4

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 6

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 2

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 5

    4 páginasMR04

    Renuncia del auditor

    1 páginasAUD

    Déclaration annuelle établie au 13 jul 2013 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital24 jul 2013

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 24 jul 2013

    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2012

    7 páginasAA

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2011

    11 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 13 jul 2012 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01

    ¿Quiénes son los directivos de TRIBAL SECTA LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BREACH, Stephen Derrick
    Queen Street
    St. Philips
    BS2 0HQ Bristol
    Kings Orchard
    England
    Director
    Queen Street
    St. Philips
    BS2 0HQ Bristol
    Kings Orchard
    England
    EnglandBritish174695940001
    GARNER, Robert Charles
    Queen Street
    St. Philips
    BS2 0HQ Bristol
    Kings Orchard
    England
    Director
    Queen Street
    St. Philips
    BS2 0HQ Bristol
    Kings Orchard
    England
    United KingdomBritish53391420003
    COLLINS, Richard Hawke
    87-91 Newman Street
    London
    W1T 3EY
    Secretario
    87-91 Newman Street
    London
    W1T 3EY
    British53398040001
    DAVIS, Lorraine Anne
    87-91 Newman Street
    London
    W1T 3EY
    Secretario
    87-91 Newman Street
    London
    W1T 3EY
    150940090001
    LAWTON, Simon Marcus
    Long Ash
    Woodbridge Lane Withington
    GL54 4BP Cheltenham
    Gloucestershire
    Secretario
    Long Ash
    Woodbridge Lane Withington
    GL54 4BP Cheltenham
    Gloucestershire
    British68807890004
    STAFFORD, Paul Claude
    Hunters Moon
    Haccups Lane
    SO51 ONP Michelmersh
    Hampshire
    Secretario
    Hunters Moon
    Haccups Lane
    SO51 ONP Michelmersh
    Hampshire
    British17749140002
    STOUT, Keith Andrew
    318 Titchfield Road
    Stubbington
    PO14 3EU Fareham
    Hampshire
    Secretario
    318 Titchfield Road
    Stubbington
    PO14 3EU Fareham
    Hampshire
    British11046430001
    BISHOP, Andrew
    8 The Arboretum
    Gibbet Hill
    CV4 7HX Coventry
    Warwickshire
    Director
    8 The Arboretum
    Gibbet Hill
    CV4 7HX Coventry
    Warwickshire
    United KingdomBritish75930610002
    BROOK, Martin Alan
    Field House 77 Common End Lane
    Lepton
    HD8 0AL Huddersfield
    Director
    Field House 77 Common End Lane
    Lepton
    HD8 0AL Huddersfield
    EnglandBritish57318180003
    CHEVINS, David Geoffrey
    The Stables Tamhorn Park Farm
    Fisherwick Road
    WS14 9JJ Whittington
    Staffordshire
    Director
    The Stables Tamhorn Park Farm
    Fisherwick Road
    WS14 9JJ Whittington
    Staffordshire
    British29027400002
    DOHERTY, Trevor Anthony
    2 Park View
    Holmfirth
    HD7 1BT Huddersfield
    West Yorkshire
    Director
    2 Park View
    Holmfirth
    HD7 1BT Huddersfield
    West Yorkshire
    EnglandEnglish152777440001
    DRAPER, Nigel Francis
    Albury House
    Albury
    OX9 2LP Thame
    Oxfordshire
    Director
    Albury House
    Albury
    OX9 2LP Thame
    Oxfordshire
    EnglandBritish71920810003
    EVANS, Keith Martin, Dr
    Queen Street
    St. Philips
    BS2 0HQ Bristol
    Kings Orchard
    England
    Director
    Queen Street
    St. Philips
    BS2 0HQ Bristol
    Kings Orchard
    England
    EnglandBritish83582830002
    FARENDEN, John Alexander
    Wenlock
    Walton Head Lane, Kirkby Overblow
    HG3 1HG Harrogate
    North Yorkshire
    Director
    Wenlock
    Walton Head Lane, Kirkby Overblow
    HG3 1HG Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritish42909080004
    KEENAN, Timothy John
    The Barn House Wood Street
    Skelmanthorpe
    HD8 9BN Huddersfield
    West Yorkshire
    Director
    The Barn House Wood Street
    Skelmanthorpe
    HD8 9BN Huddersfield
    West Yorkshire
    United KingdomBritish34523830002
    LAWTON, Simon Marcus
    87-91 Newman Street
    London
    W1T 3EY
    Director
    87-91 Newman Street
    London
    W1T 3EY
    EnglandBritish68807890004
    MARTIN, Peter John
    87-91 Newman Street
    London
    W1T 3EY
    Director
    87-91 Newman Street
    London
    W1T 3EY
    EnglandBritish176044430001
    MORGAN, Peter Huw Owen
    63a Forton Road
    TF10 8BU Newport
    Salop
    Director
    63a Forton Road
    TF10 8BU Newport
    Salop
    British64673050001
    PEARSON, Jonathan Rupert Mark
    33 Pereira Road
    Harborne
    B17 9JB Birmingham
    West Midlands
    Director
    33 Pereira Road
    Harborne
    B17 9JB Birmingham
    West Midlands
    EnglandBritish97751190001
    PITMAN, Henry John
    Pinbury Park
    Duntisbourne Rouse
    GL7 7LG Cirencester
    Gloucestershire
    Director
    Pinbury Park
    Duntisbourne Rouse
    GL7 7LG Cirencester
    Gloucestershire
    United KingdomBritish55231490005
    SMURTHWAITE, Stephen John
    11 Westbourne Avenue
    Wrea Green
    PR4 2PL Preston
    Lancashire
    Director
    11 Westbourne Avenue
    Wrea Green
    PR4 2PL Preston
    Lancashire
    British97750980001
    STAFFORD, Paul Claude
    Hunters Moon
    Haccups Lane
    SO51 ONP Michelmersh
    Hampshire
    Director
    Hunters Moon
    Haccups Lane
    SO51 ONP Michelmersh
    Hampshire
    United KingdomBritish17749140002
    STOUT, Keith Andrew
    318 Titchfield Road
    Stubbington
    PO14 3EU Fareham
    Hampshire
    Director
    318 Titchfield Road
    Stubbington
    PO14 3EU Fareham
    Hampshire
    United KingdomBritish11046430001
    STOUT, Keith Andrew
    318 Titchfield Road
    Stubbington
    PO14 3EU Fareham
    Hampshire
    Director
    318 Titchfield Road
    Stubbington
    PO14 3EU Fareham
    Hampshire
    United KingdomBritish11046430001

    ¿Tiene TRIBAL SECTA LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Guarantee & debenture
    Creado el 14 jun 2007
    Entregado el 21 jun 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each group company to the chargee and the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 21 jun 2007Registro de un cargo (395)
    • 04 mar 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Guarantee and debenture made between certain subsidiaries of tribal group PLC and the governor and company of the bank of scotland
    Creado el 13 dic 2002
    Entregado el 24 dic 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All present and future obligations and liabilities of each group company to the security trustee and the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland Acting as Security Trustee for Itself and Thefinance Parties
    Transacciones
    • 24 dic 2002Registro de un cargo (395)
    • 04 mar 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Guarantee and debenture
    Creado el 17 oct 2002
    Entregado el 23 oct 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 23 oct 2002Registro de un cargo (395)
    • 04 mar 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 24 abr 2002
    Entregado el 30 abr 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each company to the chargee and the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for Each of the Financeparties (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 30 abr 2002Registro de un cargo (395)
    • 04 mar 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 28 feb 2002
    Entregado el 05 mar 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 05 mar 2002Registro de un cargo (395)
    • 04 mar 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Mortgage debenture
    Creado el 20 mar 1993
    Entregado el 01 abr 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 01 abr 1993Registro de un cargo (395)
    • 23 ene 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0