CODA 2GO LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCODA 2GO LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02534602
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de CODA 2GO LIMITED?

    • (7222) /

    ¿Dónde se encuentra CODA 2GO LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Methuen Park
    Chippenham
    SN14 0GB Wiltshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CODA 2GO LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    CODA RESOURCES LTD.28 dic 200628 dic 2006
    CODA (RESOURCES) LIMITED17 jul 200617 jul 2006
    CODASCISYS (RESOURCES) LIMITED15 ago 200215 ago 2002
    SCIENCE SYSTEMS (RESOURCES) LIMITED22 sept 199722 sept 1997
    SCIENCE SYSTEMS (HOLDINGS) LIMITED21 dic 199021 dic 1990
    QUAYSHELFCO 336 LIMITED24 ago 199024 ago 1990

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de CODA 2GO LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2009

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para CODA 2GO LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2009

    2 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 24 ago 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital07 sept 2010

    Estado de capital el 07 sept 2010

    • Capital: GBP .01
    SH01

    Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada

    1 páginasAD03

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado

    1 páginasAD02

    Estado de capital el 16 ago 2010

    • Capital: GBP 0.01
    4 páginasSH19

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    páginasGAZ1(A)

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Canc share prem and cap red reserve 30/06/2010
    RES13
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cese del nombramiento de John Crooks como director

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2008

    2 páginasAA

    legacy

    4 páginas363a

    Certificado de cambio de nombre

    Company name changed coda resources LTD.\certificate issued on 06/04/09
    2 páginasCERTNM

    legacy

    4 páginas363a

    legacy

    1 páginas288a

    legacy

    1 páginas288a

    legacy

    1 páginas288a

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2007

    10 páginasAA

    legacy

    1 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas225

    ¿Quiénes son los directivos de CODA 2GO LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MARLOW, Angela Louise
    .
    Henley
    TA10 9BH Langport
    Pear Tree Farm
    Somerset
    United Kingdom
    Secretario
    .
    Henley
    TA10 9BH Langport
    Pear Tree Farm
    Somerset
    United Kingdom
    British129154040001
    ROCHE, Jeremy Byron
    The Orchard House
    Abingdon Road, Tubney
    OX13 5QQ Abingdon
    Oxfordshire
    Director
    The Orchard House
    Abingdon Road, Tubney
    OX13 5QQ Abingdon
    Oxfordshire
    EnglandBritishDirector39969820003
    VAN MARION, Arie
    Straatweg 234
    3054 AM Rotterdam
    Netherlands
    Director
    Straatweg 234
    3054 AM Rotterdam
    Netherlands
    NetherlandsDutchDirector93618260001
    BELMONT, David Gresford
    4 Glenview Close
    Nab Wood
    BD18 4AZ Shipley
    West Yorkshire
    Secretario
    4 Glenview Close
    Nab Wood
    BD18 4AZ Shipley
    West Yorkshire
    British99897870001
    HUCKER, Bryan Herbert
    Crestfield House
    Tetbury Road Sherston
    SN16 0LU Malmesbury
    Wiltshire
    Secretario
    Crestfield House
    Tetbury Road Sherston
    SN16 0LU Malmesbury
    Wiltshire
    British7560560003
    MCRITCHIE, Ruth Elizabeth
    9 Churchfarm Close
    BS37 5BZ Yate
    South Gloucestershire
    Secretario
    9 Churchfarm Close
    BS37 5BZ Yate
    South Gloucestershire
    British101309030001
    CROOKS, John
    Orchard Batch
    Blackford Road Mark
    TA9 4NR Highbridge
    Somerset
    Director
    Orchard Batch
    Blackford Road Mark
    TA9 4NR Highbridge
    Somerset
    United KingdomBritishDirector89194860001
    HAYNES, John Balfour, Dr
    Steep Oakridge Lane
    Winscombe
    BS25 1LZ Somerset
    Avon
    Director
    Steep Oakridge Lane
    Winscombe
    BS25 1LZ Somerset
    Avon
    EnglandBritishManaging Director200888890001
    HUCKER, Bryan Herbert
    Northlew
    Lansdowne Road
    BA1 5TD Bath
    Bnes
    Director
    Northlew
    Lansdowne Road
    BA1 5TD Bath
    Bnes
    EnglandBritishDirector7560560005
    LOVE, Michael David, Dr
    Denver House Old Ditch
    Westbury Sub Mendip
    BA5 1HN Wells
    Somerset
    Director
    Denver House Old Ditch
    Westbury Sub Mendip
    BA5 1HN Wells
    Somerset
    United KingdomEnglishManaging Director7560570001
    MCRITCHIE, Ruth Elizabeth
    9 Churchfarm Close
    BS37 5BZ Yate
    South Gloucestershire
    Director
    9 Churchfarm Close
    BS37 5BZ Yate
    South Gloucestershire
    United KingdomBritishFinancial Director101309030001
    NORTHMORE, Bernard
    Cottage Farm Brinscombe
    Weare
    BS26 2LH Axbridge
    Somerset
    Director
    Cottage Farm Brinscombe
    Weare
    BS26 2LH Axbridge
    Somerset
    EnglandBritishDirector62089610001
    PREDDY, Clifford Stanley Frank
    18 Croham Park Avenue
    CR2 7HH South Croydon
    Surrey
    Director
    18 Croham Park Avenue
    CR2 7HH South Croydon
    Surrey
    BritishCompany Director11201910001
    STEINSBERG, Graham Lawrence
    Bakers Close
    104 Lower Radley
    OX14 3BA Abingdon
    Oxfordshire
    Director
    Bakers Close
    104 Lower Radley
    OX14 3BA Abingdon
    Oxfordshire
    EnglandBritishManaging Director34515710002

    ¿Tiene CODA 2GO LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Legal charge
    Creado el 17 ene 2003
    Entregado el 24 ene 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Methuen park chippenham wiltshire title number WT161177. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 24 ene 2003Registro de un cargo (395)
    • 23 abr 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 13 oct 1998
    Entregado el 16 oct 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The property known as 2.4 acres at methuen park development chippenham wiltshire title number WT161177. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 16 oct 1998Registro de un cargo (395)
    • 16 nov 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 22 sept 1998
    Entregado el 12 oct 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 12 oct 1998Registro de un cargo (395)
    • 16 nov 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 05 mar 1992
    Entregado el 13 mar 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    23 clothier road, brislington, bristol, avon - title no. AV120410.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 13 mar 1992Registro de un cargo (395)
    • 16 nov 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 20 nov 1991
    Entregado el 09 dic 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Unit 9 edison village, highfield science park, nottingham, nottinghamshire title no. NT266842.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 09 dic 1991Registro de un cargo (395)
    • 16 nov 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0