SSR (2012) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaSSR (2012) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02539944
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de SSR (2012) LIMITED?

    • Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. (74909) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra SSR (2012) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    172 Obelisk Rise
    NN2 8TX Northampton
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SSR (2012) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    SMITH, STUART & REYNOLDS LIMITED17 sept 199017 sept 1990

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de SSR (2012) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta29 feb 2012

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para SSR (2012) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 29 feb 2012

    7 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 17 sept 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital12 oct 2012

    Estado de capital el 12 oct 2012

    • Capital: GBP 999
    SH01

    Domicilio social registrado cambiado de 172 Obelisk Rise Northampton NN2 8TX United Kingdom el 12 oct 2012

    1 páginasAD01

    Domicilio social registrado cambiado de Cottage Farm Sywell Northampton Northamptonshire NN6 0BJ el 12 oct 2012

    1 páginasAD01

    Resoluciones

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 08 ago 2012

    RES15

    Aviso de cambio de nombre

    2 páginasCONNOT

    legacy

    3 páginasMG02

    Exercice comptable précédent prolongé du 31 ago 2011 au 29 feb 2012

    1 páginasAA01

    Cese del nombramiento de Simon James Smith como director el 17 feb 2012

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 17 sept 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cambio de datos del secretario Carolyn Mary Wheeler el 17 sept 2011

    1 páginasCH03

    Cese del nombramiento de Felicity Jane Gardner como director el 16 sept 2011

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mrs Nicola Ann Beers como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr William Matthew Tongue como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Lennox Edmond Thomson como director

    2 páginasAP01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 ago 2010

    8 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 17 sept 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cambio de datos del director Simon James Smith el 17 sept 2010

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Felicity Jane Gardner el 17 sept 2010

    2 páginasCH01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 ago 2009

    8 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 17 sept 2009 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 ago 2008

    8 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de SSR (2012) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    WHEELER, Carolyn Mary
    Obelisk Rise
    NN2 8TX Northampton
    172
    United Kingdom
    Secretario
    Obelisk Rise
    NN2 8TX Northampton
    172
    United Kingdom
    BritishOffice Manager75715650001
    BEERS, Nicola Ann
    Obelisk Rise
    NN2 8TX Northampton
    172
    United Kingdom
    Director
    Obelisk Rise
    NN2 8TX Northampton
    172
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Surveyor162022420001
    THOMSON, Lennox Edmond
    Obelisk Rise
    NN2 8TX Northampton
    172
    United Kingdom
    Director
    Obelisk Rise
    NN2 8TX Northampton
    172
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Surveyor61688110001
    TONGUE, William Matthew
    Obelisk Rise
    NN2 8TX Northampton
    172
    United Kingdom
    Director
    Obelisk Rise
    NN2 8TX Northampton
    172
    United Kingdom
    EnglandBritishFarm Business Consultant116053840001
    SMITH, Charles David
    The Horseblock
    The Green Staverton
    NN11 6JB Daventry
    Northamptonshire
    Secretario
    The Horseblock
    The Green Staverton
    NN11 6JB Daventry
    Northamptonshire
    British19065850005
    ALDERSON, David Alan
    12 Trinity Avenue
    NN2 6JJ Northampton
    Northamptonshire
    Director
    12 Trinity Avenue
    NN2 6JJ Northampton
    Northamptonshire
    BritishTown Planner117386170001
    BARNEY, Henry Francis
    54 High Street
    Brigstock
    NN14 3HA Kettering
    Northamptonshire
    Director
    54 High Street
    Brigstock
    NN14 3HA Kettering
    Northamptonshire
    BritishChartered Surveyor70674480001
    GARDNER, Felicity Jane
    Cottage Farm
    Sywell
    NN6 0BJ Northampton
    Northamptonshire
    Director
    Cottage Farm
    Sywell
    NN6 0BJ Northampton
    Northamptonshire
    EnglandBritishTown Planner47098360001
    HAIGH, Pamela Anne
    The Horseblock
    The Green Staverton
    NN11 6JB Daventry
    Northamptonshire
    Director
    The Horseblock
    The Green Staverton
    NN11 6JB Daventry
    Northamptonshire
    BritishTown Planner56057730003
    PASKE, Norman Charles
    Longbrook Farm
    Thurning
    PE8 5RG Peterborough
    Director
    Longbrook Farm
    Thurning
    PE8 5RG Peterborough
    United KingdomBritishChartered Surveyor25273770003
    REYNOLDS, Robert
    Wash Hill Cottage Wash Hill
    Wooburn Green
    HP10 0JA High Wycombe
    Buckinghamshire
    Director
    Wash Hill Cottage Wash Hill
    Wooburn Green
    HP10 0JA High Wycombe
    Buckinghamshire
    BritishPlanning And Development Consu10206910002
    ROBERTS, Pamela Mary
    14 The Ridgeway
    LE16 7HQ Market Harborough
    Leicestershire
    Director
    14 The Ridgeway
    LE16 7HQ Market Harborough
    Leicestershire
    BritishTown Planner75715470001
    SMITH, Charles David
    The Horseblock
    The Green Staverton
    NN11 6JB Daventry
    Northamptonshire
    Director
    The Horseblock
    The Green Staverton
    NN11 6JB Daventry
    Northamptonshire
    BritishPlanning And Development Consu19065850005
    SMITH, Simon James
    Cottage Farm
    Sywell
    NN6 0BJ Northampton
    Northamptonshire
    Director
    Cottage Farm
    Sywell
    NN6 0BJ Northampton
    Northamptonshire
    EnglandBritishTown Planning102203990001
    STUART, Robert Ian
    Treetops
    Seven Leaze Lane, Edge
    GL6 6NJ Stroud
    Gloucestershire
    Director
    Treetops
    Seven Leaze Lane, Edge
    GL6 6NJ Stroud
    Gloucestershire
    United KingdomBritishPlanning And Development Consu73193480001
    THOMSON, Lennox Edmond
    172 Obelisk Rise
    NN2 8TX Northampton
    Director
    172 Obelisk Rise
    NN2 8TX Northampton
    EnglandBritishChartered Surveyor61688110001
    WHITMORE, Marcus Paul
    8 Grasmere Road
    Longlevens
    GL2 0NQ Gloucester
    Gloucestershire
    Director
    8 Grasmere Road
    Longlevens
    GL2 0NQ Gloucester
    Gloucestershire
    BritishTown Planner56057750001

    ¿Tiene SSR (2012) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 07 nov 2001
    Entregado el 17 nov 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 17 nov 2001Registro de un cargo (395)
    • 09 ago 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 01 mar 1995
    Entregado el 14 mar 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee s
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Charles David Smith
    • Robert Ian Stuart
    • Robert Edward Reynolds
    Transacciones
    • 14 mar 1995Registro de un cargo (395)
    • 01 may 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Single debenture
    Creado el 06 abr 1994
    Entregado el 15 abr 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 15 abr 1994Registro de un cargo (395)
    • 22 dic 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 25 abr 1991
    Entregado el 07 may 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC.
    Transacciones
    • 07 may 1991Registro de una carga
    • 09 ago 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0