THYSSENKRUPP ENCASA LIMITED

THYSSENKRUPP ENCASA LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaTHYSSENKRUPP ENCASA LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02541007
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de THYSSENKRUPP ENCASA LIMITED?

    • Reparación de otros equipos (33190) / Industrias manufactureras

    ¿Dónde se encuentra THYSSENKRUPP ENCASA LIMITED?

    Dirección de la sede social
    6, The Quadrangle Cranmore Avenue
    Shirley
    B90 4LE Solihull
    West Midlands
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de THYSSENKRUPP ENCASA LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    LIFT ABLE LIMITED24 jul 199524 jul 1995
    LIFTABILITY LIMITED30 ene 199130 ene 1991
    LISTABILITY LIMITED21 ene 199121 ene 1991
    TROPICAL CHOICES LIMITED19 sept 199019 sept 1990

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de THYSSENKRUPP ENCASA LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 sept 2013

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para THYSSENKRUPP ENCASA LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para THYSSENKRUPP ENCASA LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida

    1 páginasSOAS(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Déclaration annuelle établie au 14 sept 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital27 oct 2014

    Estado de capital el 27 oct 2014

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Domicilio social registrado cambiado de 2 Easter Park Earlsway Teesside Industrial Est Stockton on Tees Cleveland TS17 9NT a 6, the Quadrangle Cranmore Avenue Shirley Solihull West Midlands B90 4LE el 27 oct 2014

    1 páginasAD01

    Nombramiento de Mr Malcolm Whetton como director el 01 sept 2014

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Paul William Robert Scott como director el 01 sept 2014

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Diane Ingham como secretario el 01 sept 2014

    1 páginasTM02

    Estado de capital el 09 sept 2014

    • Capital: GBP 1
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    2 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    4 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2013

    24 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 14 sept 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Renuncia del auditor

    2 páginasAUD

    Misceláneos

    Section 519 ca 2006
    1 páginasMISC

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2012

    23 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 14 sept 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Certificado de cambio de nombre

    Company name changed lift able LIMITED\certificate issued on 26/04/12
    3 páginasCERTNM
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name26 abr 2012

    Cambio de nombre por resolución

    NM01
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 25 abr 2012

    RES15

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2011

    20 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 14 sept 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2010

    20 páginasAA

    Nombramiento de Mr Paul William Robert Scott como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Andre Schaefer como director

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de THYSSENKRUPP ENCASA LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    CARNEIRO, Mauro Augusto
    557 Yarm Road
    TS16 9BJ Eaglescliffe
    Cleveland
    Director
    557 Yarm Road
    TS16 9BJ Eaglescliffe
    Cleveland
    United KingdomBritish86053150002
    WHETTON, Malcolm
    Cranmore Avenue
    Shirley
    B90 4LE Solihull
    6, The Quadrangle
    West Midlands
    England
    Director
    Cranmore Avenue
    Shirley
    B90 4LE Solihull
    6, The Quadrangle
    West Midlands
    England
    EnglandEnglish86762920001
    FORSTER, Michael
    Baltimore Court
    Concord
    NE37 2HU Washington
    13
    Tyne And Wear
    United Kingdom
    Secretario
    Baltimore Court
    Concord
    NE37 2HU Washington
    13
    Tyne And Wear
    United Kingdom
    British141103160001
    HILL, Nichola
    2 Easter Park
    Earlsway Teesside Industrial Est
    TS17 9NT Stockton On Tees
    Cleveland
    Secretario
    2 Easter Park
    Earlsway Teesside Industrial Est
    TS17 9NT Stockton On Tees
    Cleveland
    153407710001
    INGHAM, Diane
    2 Easter Park
    Earlsway Teesside Industrial Est
    TS17 9NT Stockton On Tees
    Cleveland
    Secretario
    2 Easter Park
    Earlsway Teesside Industrial Est
    TS17 9NT Stockton On Tees
    Cleveland
    155541130001
    MUIR, Alfred Thomas
    Keithley Cottage
    Old Battersby
    TS9 6LU Middlesbrough
    Cleveland
    Secretario
    Keithley Cottage
    Old Battersby
    TS9 6LU Middlesbrough
    Cleveland
    British16212650002
    RICHARDS, Andrew Trenholm
    Talisker Gardens
    Highcliffe View
    TS10 2TG Redcar
    35
    North Yorkshire
    Secretario
    Talisker Gardens
    Highcliffe View
    TS10 2TG Redcar
    35
    North Yorkshire
    British128951050001
    SIMMONDS, James Douglas
    Glen Garth
    Stanghow
    TS12 3JU Saltburn By The Sea
    Cleveland
    Secretario
    Glen Garth
    Stanghow
    TS12 3JU Saltburn By The Sea
    Cleveland
    British90753690001
    MUIR, Alfred Thomas
    Keithley Cottage
    Old Battersby
    TS9 6LU Middlesbrough
    Cleveland
    Director
    Keithley Cottage
    Old Battersby
    TS9 6LU Middlesbrough
    Cleveland
    British16212650002
    MUIR, Ruth Phyllis
    Keithley Cottage
    Old Battersby
    TS9 6LU Middlesbrough
    Cleveland
    Director
    Keithley Cottage
    Old Battersby
    TS9 6LU Middlesbrough
    Cleveland
    British87632880001
    SCHAEFER, Andre
    Yarm Road
    Eaglescliffe
    TS16 0DF Stockton-On-Tees
    586
    Cleveland
    United Kingdom
    Director
    Yarm Road
    Eaglescliffe
    TS16 0DF Stockton-On-Tees
    586
    Cleveland
    United Kingdom
    United KingdomBelgian128951690002
    SCOTT, Paul William Robert
    Copt Hewick
    H64 5BY Ripon
    Hill Villa
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Director
    Copt Hewick
    H64 5BY Ripon
    Hill Villa
    North Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandEnglish158085410001
    SIMMONDS, James Douglas
    Glengarth
    Stanghow
    TS12 3JU Saltburn By The Sea
    Cleveland
    Director
    Glengarth
    Stanghow
    TS12 3JU Saltburn By The Sea
    Cleveland
    United KingdomBritish94016330001
    SIMMONDS, Jean
    Glengarth
    Stanghow
    TS12 3JU Lingdale
    Saltburn By The Sea
    Director
    Glengarth
    Stanghow
    TS12 3JU Lingdale
    Saltburn By The Sea
    British87632790001
    WHYMAN, Christopher
    Greenhedges Stanghow
    Lingdale
    TS12 3JU Saltburn By The Sea
    Cleveland
    Director
    Greenhedges Stanghow
    Lingdale
    TS12 3JU Saltburn By The Sea
    Cleveland
    United KingdomBritish55682750001
    WHYMAN, Mandy
    Greenhedges
    Stanghow
    TS12 3JU Lingdale
    Saltburn By The Sea
    Director
    Greenhedges
    Stanghow
    TS12 3JU Lingdale
    Saltburn By The Sea
    British87632730001

    ¿Tiene THYSSENKRUPP ENCASA LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Charge over a deposit held by yorkshire bank (own account)
    Creado el 22 jun 1999
    Entregado el 23 jun 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The balance of the following account: yorkshire bank PLC branch address: 7 linthorpe road middlesbrough type of account : 3 months premium a/c account name : lift able limited account number: 516392. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Yorkshire Bank PLC
    Transacciones
    • 23 jun 1999Registro de un cargo (395)
    • 22 mar 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge over a deposit (own account)
    Creado el 21 may 1998
    Entregado el 27 may 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed charge over the balance standing to the credit of account no.516392. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Yorkshire Bank PLC
    Transacciones
    • 27 may 1998Registro de un cargo (395)
    • 22 mar 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge over deposit
    Creado el 21 may 1997
    Entregado el 04 jun 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The balance from time to time standing to the credit of account number 516392 in the name of lift able limited 3 month premium account.
    Personas con derecho
    • Yorkshire Bank PLC
    Transacciones
    • 04 jun 1997Registro de un cargo (395)
    • 22 mar 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 03 ene 1992
    Entregado el 09 ene 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Yorkshire Bank PLC
    Transacciones
    • 09 ene 1992Registro de un cargo (395)
    • 03 ago 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0