I.E. GROUP LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaI.E. GROUP LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02542977
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de I.E. GROUP LIMITED?

    • Otro alquiler y explotación de bienes inmobiliarios propios o arrendados (68209) / Actividades inmobiliarias

    ¿Dónde se encuentra I.E. GROUP LIMITED?

    Dirección de la sede social
    48 Broadway
    PE1 1YW Peterborough
    Cambridgeshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de I.E. GROUP LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    SEC GROUP PLC29 mar 199929 mar 1999
    SECURITISED ENDOWMENT CONTRACTS PLC22 nov 199022 nov 1990
    REALBOND PLC25 sept 199025 sept 1990

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de I.E. GROUP LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2014

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para I.E. GROUP LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para I.E. GROUP LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 mar 2014

    6 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 25 sept 2014 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital09 oct 2014

    Estado de capital el 09 oct 2014

    • Capital: GBP 2,264,402
    SH01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 mar 2013

    6 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 25 sept 2013 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital18 oct 2013

    Estado de capital el 18 oct 2013

    • Capital: GBP 2,264,402
    SH01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 mar 2012

    5 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 25 sept 2012 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01

    Exercice comptable précédent prolongé du 31 dic 2011 au 31 mar 2012

    1 páginasAA01

    Déclaration annuelle établie au 25 sept 2011 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2010

    15 páginasAA

    Cambio de datos del director Mr. Michael Alastair Couzens el 05 jun 2011

    2 páginasCH01

    Cese del nombramiento de Paul Hooper como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Michael Couzens como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Ms Marie Fiona Fisher como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Diana Monger como secretario

    1 páginasTM02

    Domicilio social registrado cambiado de * Pixham End Dorking Surrey RH4 1QA* el 20 may 2011

    2 páginasAD01

    Renuncia del auditor

    1 páginasAUD

    Déclaration annuelle établie au 25 sept 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Misceláneos

    Section 519
    4 páginasMISC

    Cese del nombramiento de Mark Wadelin como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Paul Hooper como director

    2 páginasAP01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2009

    13 páginasAA

    Nombramiento de Mrs Diana Monger como secretario

    1 páginasAP03

    ¿Quiénes son los directivos de I.E. GROUP LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    FISHER, Marie Fiona
    Broadway
    PE1 1YW Peterborough
    48
    Cambridgeshire
    Director
    Broadway
    PE1 1YW Peterborough
    48
    Cambridgeshire
    United KingdomBritish157495860001
    DRAIN, Antony Peter
    10 Eglington Road
    E4 7AN London
    Secretario
    10 Eglington Road
    E4 7AN London
    British60698090001
    ELLIS, Robert Gordon
    Severals
    Oakwood
    PO18 9AL Chichester
    West Sussex
    Secretario
    Severals
    Oakwood
    PO18 9AL Chichester
    West Sussex
    British33165610001
    GRAY, Elizabeth Andrea
    16 Broad Street
    CV34 4LT Warwick
    Warwickshire
    Secretario
    16 Broad Street
    CV34 4LT Warwick
    Warwickshire
    British98035800001
    HAM, Richard Laurence
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    Secretario
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    British136433670001
    MONGER, Diana
    Verdley Place
    Fernhurst
    GU27 3ER Haslemere
    Oefield House
    Surrey
    Secretario
    Verdley Place
    Fernhurst
    GU27 3ER Haslemere
    Oefield House
    Surrey
    148091340001
    PINNICK, Jeffrey
    34 Barnet Gate Lane
    EN5 2AB Barnet
    Hertfordshire
    Secretario
    34 Barnet Gate Lane
    EN5 2AB Barnet
    Hertfordshire
    British8659220002
    RENNIE, Kim Michelle
    58 Oxhey Avenue
    WD1 4HA Watford
    Hertfordshire
    Secretario
    58 Oxhey Avenue
    WD1 4HA Watford
    Hertfordshire
    British65899240002
    TRUEMAN, Paul Roland
    71 Park Road
    CM14 4TU Brentwood
    Essex
    Secretario
    71 Park Road
    CM14 4TU Brentwood
    Essex
    British9145660001
    WATERS, Paul Christopher
    The Old Vicarage
    High Street
    B50 4BQ Bidford On Avon
    Warwickshire
    Secretario
    The Old Vicarage
    High Street
    B50 4BQ Bidford On Avon
    Warwickshire
    British67435560001
    WILKINSON, Alan Steven
    11 Copthall Drive
    NW7 2ND London
    Secretario
    11 Copthall Drive
    NW7 2ND London
    British61982590001
    S F (FINANCIAL AND MANAGEMENT) SERVICES LIMITED
    23-25 Eastcastle Street
    W1N 8AE London
    Secretario corporativo
    23-25 Eastcastle Street
    W1N 8AE London
    16340140001
    ANSELL, Nicholas Paul
    Hetlee Farm Leigh Road
    SK9 6DS Wilmslow
    Cheshire
    Director
    Hetlee Farm Leigh Road
    SK9 6DS Wilmslow
    Cheshire
    EnglandBritish48033090001
    ATTWOOD, Thomas Roger
    Manor House
    Gills Green
    TN18 5AE Cranbrook Hawkshurst
    Kent
    Director
    Manor House
    Gills Green
    TN18 5AE Cranbrook Hawkshurst
    Kent
    United KingdomBritish50051050001
    BARNARD, Nigel Parry
    19 Roehampton Court
    Queens Ride Barnes
    SW13 0HU London
    Director
    19 Roehampton Court
    Queens Ride Barnes
    SW13 0HU London
    DenmarkBritish48030310001
    COLLINS, Adrian John Reginald
    4 Campden Hill Square
    W8 7LB London
    Director
    4 Campden Hill Square
    W8 7LB London
    EnglandBritish465730003
    COUZENS, Michael Alastair
    Nell Hill
    Hannington
    SN6 7RU Wilstshire
    Nell House
    England
    England
    Director
    Nell Hill
    Hannington
    SN6 7RU Wilstshire
    Nell House
    England
    England
    United KingdomBritish75553130006
    DRAIN, Antony Peter
    10 Eglington Road
    E4 7AN London
    Director
    10 Eglington Road
    E4 7AN London
    United KingdomBritish60698090001
    GRAHAM, Ross King
    Stourton Farm House
    Stourton
    CV36 5HG Shipston On Stour
    Warwickshire
    Director
    Stourton Farm House
    Stourton
    CV36 5HG Shipston On Stour
    Warwickshire
    United KingdomBritish61733920001
    GREENWOOD, Timothy Sandiford
    Herons Brook
    Chelford Road Prestbury
    SK10 4AW Macclesfield
    Cheshire
    Director
    Herons Brook
    Chelford Road Prestbury
    SK10 4AW Macclesfield
    Cheshire
    United KingdomBritish101284380001
    HOOPER, Paul
    London Road
    Charlton Kings
    GL52 6UY Cheltenham
    Little Shipton
    Gloucester
    United Kingdom
    Director
    London Road
    Charlton Kings
    GL52 6UY Cheltenham
    Little Shipton
    Gloucester
    United Kingdom
    United KingdomBritish152500600001
    KALISH, Geoffrey
    780 Third Avenue Ninth Floor
    Newyork
    Usa
    Director
    780 Third Avenue Ninth Floor
    Newyork
    Usa
    American64379780001
    KLUG, Bernard Philip
    57 Sheldon Avenue
    N6 4NH London
    Director
    57 Sheldon Avenue
    N6 4NH London
    British15387060001
    MARTIN, Ivan
    90 Ranelagh Road
    Ealing
    W5 5RP London
    Director
    90 Ranelagh Road
    Ealing
    W5 5RP London
    EnglandBritish123233030001
    PINNICK, Jeffrey
    34 Barnet Gate Lane
    EN5 2AB Barnet
    Hertfordshire
    Director
    34 Barnet Gate Lane
    EN5 2AB Barnet
    Hertfordshire
    EnglandBritish8659220002
    RADCLIFFE, Mark Hugh Joseph
    The Malt House
    Upton, Nr Andover
    SP11 0JS Andover
    Hampshire
    Director
    The Malt House
    Upton, Nr Andover
    SP11 0JS Andover
    Hampshire
    British33402910003
    ROBSON, Rupert Hugo Wynne
    2 Carlyle Mansions
    Cheyne Walk
    SW3 5LS London
    Director
    2 Carlyle Mansions
    Cheyne Walk
    SW3 5LS London
    British9727390002
    ROSENZWEIG, Max
    7 Williams Way
    WD7 7EZ Radlett
    Hertfordshire
    Director
    7 Williams Way
    WD7 7EZ Radlett
    Hertfordshire
    British74961040001
    TRUEMAN, Paul Roland
    71 Park Road
    CM14 4TU Brentwood
    Essex
    Director
    71 Park Road
    CM14 4TU Brentwood
    Essex
    United KingdomBritish9145660001
    WADELIN, Mark Thomas
    26 Kings Coughton Lane
    Kings Coughton
    B49 5QE Alcester
    Warwickshire
    Director
    26 Kings Coughton Lane
    Kings Coughton
    B49 5QE Alcester
    Warwickshire
    EnglandBritish70575020005
    WADELIN, Mark Thomas
    26 Kings Coughton Lane
    Kings Coughton
    B49 5QE Alcester
    Warwickshire
    Director
    26 Kings Coughton Lane
    Kings Coughton
    B49 5QE Alcester
    Warwickshire
    EnglandBritish70575020005
    WEBSTER, John Dudley
    10 Merrydown Way
    BR7 5RS Chislehurst
    Kent
    Director
    10 Merrydown Way
    BR7 5RS Chislehurst
    Kent
    British457110001
    WILKINSON, Alan Steven
    11 Copthall Drive
    NW7 2ND London
    Director
    11 Copthall Drive
    NW7 2ND London
    British61982590001
    MISYS CORPORATE DIRECTOR LIMITED
    Burleigh House
    Chapel Oak Salford Priors
    WR11 8SP Evesham
    Director corporativo
    Burleigh House
    Chapel Oak Salford Priors
    WR11 8SP Evesham
    82547250002

    ¿Tiene I.E. GROUP LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off (olso) dated 3RD july 1995
    Creado el 19 dic 2006
    Entregado el 29 dic 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 29 dic 2006Registro de un cargo (395)
    • 09 jun 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    A deed of admission to an omnibus letter of set off dated 3RD july 1995
    Creado el 17 sept 2003
    Entregado el 01 oct 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 01 oct 2003Registro de un cargo (395)
    • 09 jun 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3 july 1995
    Creado el 11 sept 2003
    Entregado el 24 sept 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 24 sept 2003Registro de un cargo (395)
    • 09 jun 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Creado el 31 dic 1997
    Entregado el 19 ene 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed charge over all "deposits" in and to the charged account with barclays bank PLC re;-sec group PLC business premium account no;-00928852. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 19 ene 1998Registro de un cargo (395)
    • 21 jun 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 31 dic 1997
    Entregado el 15 ene 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 15 ene 1998Registro de un cargo (395)
    • 21 jun 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 06 abr 1997
    Entregado el 18 abr 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the counter-indemnity of even date
    Breve descripción
    First fixed charge all its right title and interest in respect of:- the account held by the company with the bank at 38 mosley street manchester designated "the royal bank of scotland PLC - cash deposit be sec group PLC to support guarantee liability" under account number 20122924 (or such other replacement (account(s) in which the new deposit is held (the "new account")) and amount from time to time standing to the credit of the account and all rights accruing in respect of the new account. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 18 abr 1997Registro de un cargo (395)
    • 23 abr 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge over cash deposit
    Creado el 20 may 1996
    Entregado el 03 jun 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a counter-indemnity of even date
    Breve descripción
    All its right, title and interest in:- the account held by the company with the bank designated "rbs : re- sec group PLC" under account number:20078186 (the "account"). See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 03 jun 1996Registro de un cargo (395)
    • 23 abr 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage and assignment
    Creado el 28 nov 1991
    Entregado el 11 dic 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All policies of insurance and all moneys payable thereunder please see doc M200C for details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 11 dic 1991Registro de un cargo (395)
    • 06 ago 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 13 sept 1991
    Entregado el 20 sept 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    (For further details see doc 396 tc ref M339C). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 20 sept 1991Registro de una carga
    • 21 jun 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0