OLWEN DIRECT MARKETING SERVICES (CROYDON) LIMITED

OLWEN DIRECT MARKETING SERVICES (CROYDON) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaOLWEN DIRECT MARKETING SERVICES (CROYDON) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02545971
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de OLWEN DIRECT MARKETING SERVICES (CROYDON) LIMITED?

    • (2222) /

    ¿Dónde se encuentra OLWEN DIRECT MARKETING SERVICES (CROYDON) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    2 Mountview Court
    310 Friern Barnet Lane
    N20 0YZ London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de OLWEN DIRECT MARKETING SERVICES (CROYDON) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    VERTIS DIRECT MARKETING SERVICES (CROYDON) LIMITED28 dic 200028 dic 2000
    OLWEN DIRECT MAIL LIMITED13 nov 199013 nov 1990
    DRAMBURY LIMITED04 oct 199004 oct 1990

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de OLWEN DIRECT MARKETING SERVICES (CROYDON) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2004

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para OLWEN DIRECT MARKETING SERVICES (CROYDON) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 29 may 2013

    5 páginas4.68

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de acreedores

    4 páginas4.72

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 17 mar 2013

    5 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 17 sept 2012

    5 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 17 mar 2012

    5 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 17 sept 2011

    5 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 17 mar 2011

    5 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 17 sept 2010

    5 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 17 mar 2010

    5 páginas4.68

    Aviso de constitución del Comité de Liquidación

    2 páginas4.48

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 17 sept 2009

    5 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 17 mar 2009

    5 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador

    5 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 17 sept 2008

    5 páginas4.68

    legacy

    1 páginas287

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 17 sept 2008

    5 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador

    7 páginas4.68

    Aviso de constitución del Comité de Liquidación

    2 páginas4.48

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Informe de progreso del administrador

    8 páginas2.24B

    Aviso de cambio de la administración a la liquidación voluntaria de acreedores

    8 páginas2.34B

    Resultado de la reunión de acreedores

    35 páginas2.23B

    Certificado enmendado de constitución del comité de acreedores

    1 páginas2.26B

    Declaración de asuntos

    11 páginas2.16B

    ¿Quiénes son los directivos de OLWEN DIRECT MARKETING SERVICES (CROYDON) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    TAYLOR, Richard Scott
    The Stables Church Lane
    Dingley
    LE16 8PG Market Harborough
    Leicestershire
    Secretario
    The Stables Church Lane
    Dingley
    LE16 8PG Market Harborough
    Leicestershire
    British35333200002
    DIXON, Nicolas William
    3 Forster Road
    Holly Mount
    GU2 9AE Guildford
    Surrey
    Director
    3 Forster Road
    Holly Mount
    GU2 9AE Guildford
    Surrey
    United KingdomBritish24161370007
    TAYLOR, Richard Scott
    The Stables Church Lane
    Dingley
    LE16 8PG Market Harborough
    Leicestershire
    Director
    The Stables Church Lane
    Dingley
    LE16 8PG Market Harborough
    Leicestershire
    United KingdomBritish35333200002
    ANGELSON, Mark Alan
    876 Park Avenue
    Penthouse North
    10021 New York
    Usa
    Secretario
    876 Park Avenue
    Penthouse North
    10021 New York
    Usa
    Usa54679960003
    DRAKE, Ian Alexander
    1 Palace Green
    Addington
    CR0 9AJ Croydon
    Surrey
    Secretario
    1 Palace Green
    Addington
    CR0 9AJ Croydon
    Surrey
    British7119890002
    FISHER, Angus William Murray
    Coledown House
    Vicarage Lane, Curdridge
    S032 2DP Southampton
    Hants
    Secretario
    Coledown House
    Vicarage Lane, Curdridge
    S032 2DP Southampton
    Hants
    British122903010001
    FOOKES, Richard
    3 Hereford Drive
    Kings Ore
    CM7 9FX Braintree
    Essex
    Secretario
    3 Hereford Drive
    Kings Ore
    CM7 9FX Braintree
    Essex
    British81522540001
    HOWARD, John
    714 Avila Drive
    Davidsonville
    Maryland 21035
    America
    Secretario
    714 Avila Drive
    Davidsonville
    Maryland 21035
    America
    American107278560001
    STEEL, Angus Kennedy
    Brewery Cottage
    Brockhampton
    GL54 5XQ Cheltenham
    Gloucestershire
    Secretario
    Brewery Cottage
    Brockhampton
    GL54 5XQ Cheltenham
    Gloucestershire
    British62259790003
    ANGELSON, Mark Alan
    876 Park Avenue
    Penthouse North
    10021 New York
    Usa
    Director
    876 Park Avenue
    Penthouse North
    10021 New York
    Usa
    Usa54679960003
    BULL, Dianne
    37 Copthorne Road
    KT22 7ED Leatherhead
    Surrey
    Director
    37 Copthorne Road
    KT22 7ED Leatherhead
    Surrey
    British25261110001
    COLLINS, John Patrick
    6 Gorse Cottages
    Hammer Lane Bramshott Chase
    GU26 6DD Hindhead
    Surrey
    Director
    6 Gorse Cottages
    Hammer Lane Bramshott Chase
    GU26 6DD Hindhead
    Surrey
    United KingdomBritish26864100001
    CROFT, Peter
    2 Edgewood Green
    Shirley
    CR0 7PT Croydon
    Director
    2 Edgewood Green
    Shirley
    CR0 7PT Croydon
    United KingdomBritish36010140002
    DRAKE, Ian Alexander
    1 Palace Green
    Addington
    CR0 9AJ Croydon
    Surrey
    Director
    1 Palace Green
    Addington
    CR0 9AJ Croydon
    Surrey
    British7119890002
    DURBIN, Dean
    19001 Windsor Forest Road
    Mount Airy
    Maryland 21771
    Usa
    Director
    19001 Windsor Forest Road
    Mount Airy
    Maryland 21771
    Usa
    American81110710001
    EPPS, Gillian Margaret
    1a Hill Road
    CR4 2HS Mitcham
    Surrey
    Director
    1a Hill Road
    CR4 2HS Mitcham
    Surrey
    British23569370001
    FISHER, Angus William Murray
    Coledown House
    Vicarage Lane, Curdridge
    S032 2DP Southampton
    Hants
    Director
    Coledown House
    Vicarage Lane, Curdridge
    S032 2DP Southampton
    Hants
    United KingdomBritish122903010001
    FLANNERY, Christopher James
    2809 Boston Street
    Appartment 409
    IRISH Baltimore
    Usa
    Director
    2809 Boston Street
    Appartment 409
    IRISH Baltimore
    Usa
    British30670590004
    FOOKES, Richard
    3 Hereford Drive
    Kings Ore
    CM7 9FX Braintree
    Essex
    Director
    3 Hereford Drive
    Kings Ore
    CM7 9FX Braintree
    Essex
    British81522540001
    GAMBER, Mark Francis
    Erskine Cottage
    Garden Close Givons Grove
    KT22 8LU Leatherhead
    10
    Surrey
    Director
    Erskine Cottage
    Garden Close Givons Grove
    KT22 8LU Leatherhead
    10
    Surrey
    British51105690002
    HEALY, Scott
    7 Mount Pleasant
    MK17 9EX Stoke Hammond
    Buckinghamshire
    Director
    7 Mount Pleasant
    MK17 9EX Stoke Hammond
    Buckinghamshire
    British79690160001
    HINDLEY, Martyn John
    Upper Wield
    SO24 9RT Arlesford
    The Barn
    Hampshire
    Director
    Upper Wield
    SO24 9RT Arlesford
    The Barn
    Hampshire
    EnglandBritish134332760001
    HOLMES, Matthew Willis
    Flat 2 19 Cleveland Road
    Barnes
    SW13 0AA London
    Director
    Flat 2 19 Cleveland Road
    Barnes
    SW13 0AA London
    British43176290001
    LAYBOURNE, David Andrew
    9 Regency Mews
    BR3 2FG Beckenham
    Kent
    Director
    9 Regency Mews
    BR3 2FG Beckenham
    Kent
    British30670600001
    MARTINDALE, Peter
    Exeter Mansions
    106 Shaftesbury Avenue
    W1D 5EQ London
    Director
    Exeter Mansions
    106 Shaftesbury Avenue
    W1D 5EQ London
    British109116080001
    PONCIA, Kevin Peter
    23 Gibraltar Rise
    TN21 8HL Heathfield
    East Sussex
    Director
    23 Gibraltar Rise
    TN21 8HL Heathfield
    East Sussex
    British39046370001
    REILLY, Edward Thomas
    62 North Sylvan Road
    06880 Westport
    Connecticut
    Usa
    Director
    62 North Sylvan Road
    06880 Westport
    Connecticut
    Usa
    Usa62916050001
    RIVETT, Peter Christopher
    Motte Place Walton Manor
    Walton Street
    KT20 7SA Walton On The Hill
    Surrey
    Director
    Motte Place Walton Manor
    Walton Street
    KT20 7SA Walton On The Hill
    Surrey
    United KingdomBritish105827610001
    ROLAND, Donald Edward
    4 Norwood Road
    Annapolis
    Maryland 21401
    Usa
    Director
    4 Norwood Road
    Annapolis
    Maryland 21401
    Usa
    American71621920001
    ROOSEN, Adriaan Henri Dominique Marie
    Stationsweg 26
    Oosterbeek
    6861 Eh
    Netherlands
    Director
    Stationsweg 26
    Oosterbeek
    6861 Eh
    Netherlands
    Dutch74228750001
    RUDDLE, Andrew Daniel
    The Barn Sunt Farm
    Caterfield Lane Staffhurst Wood
    RH9 ORR Oxted
    Surrey
    Director
    The Barn Sunt Farm
    Caterfield Lane Staffhurst Wood
    RH9 ORR Oxted
    Surrey
    British20560270002
    SHERWIN, Theodore Daniel
    338 The Great Road
    Princeton
    FOREIGN Usa Nj 08540
    Director
    338 The Great Road
    Princeton
    FOREIGN Usa Nj 08540
    Usa62915610001
    STEEL, Angus Kennedy
    Brewery Cottage
    Brockhampton
    GL54 5XQ Cheltenham
    Gloucestershire
    Director
    Brewery Cottage
    Brockhampton
    GL54 5XQ Cheltenham
    Gloucestershire
    British62259790003

    ¿Tiene OLWEN DIRECT MARKETING SERVICES (CROYDON) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Mortgage debenture
    Creado el 25 oct 2005
    Entregado el 26 oct 2005
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All property assets business undertaking and rights fixed or floating including mortgaged property plant and machinery property rights debts trusts accounts securities intellectual property goodwill contracts insolvency act realisations vat recoveries cash and stock-in-trade.
    Personas con derecho
    • Enterprise Finance Europe (UK) Limited
    Transacciones
    • 26 oct 2005Registro de un cargo (395)
    • 07 jun 2006Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 07 jun 2006Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    Debenture
    Creado el 22 dic 2004
    Entregado el 11 ene 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company or any other credit party to the chargee or any lender under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All of its right, title and interest in and to each of the following assets; th properties and all related rights; the debts; the equipment; the intellectual property; all present and future goodwill and all rights in relation to the uncalled capital of the company; the investments; floating charge. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • General Electric Capital Corporation (For Itself and as Agent for the Lenders) (the Agent)
    Transacciones
    • 11 ene 2005Registro de un cargo (395)
    • 12 oct 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 31 ene 2000
    Entregado el 18 feb 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys and liabilities due or to become due from any chargor to the chargees under or in connection with a). The credit agreement b). Any other credit document to which the chargor is party from time to time and c). The debenture
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Chase Manhattan Bank (The "Collateral Agent")
    Transacciones
    • 18 feb 2000Registro de un cargo (395)
    • 24 dic 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 19 nov 1996
    Entregado el 03 dic 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 03 dic 1996Registro de un cargo (395)
    • 20 abr 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 24 may 1995
    Entregado el 27 may 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • 3I Group PLC
    Transacciones
    • 27 may 1995Registro de un cargo (395)
    • 20 abr 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 10 may 1991
    Entregado el 17 may 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 17 may 1991Registro de una carga
    • 26 may 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene OLWEN DIRECT MARKETING SERVICES (CROYDON) LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    26 may 2006Inicio de la administración
    18 sept 2006Fin de la administración
    En administración
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Barry David Lewis
    Harris Lipman
    2 Mountview Court
    N20 0YZ 310 Friern Barnet Lane
    Whetstone London
    Profesional
    Harris Lipman
    2 Mountview Court
    N20 0YZ 310 Friern Barnet Lane
    Whetstone London
    Freddy Khalastchi
    Harris Lipman Llp 2 Mountview Court
    310 Friern Barnet Lane, Whetstone
    N20 0YZ London
    Profesional
    Harris Lipman Llp 2 Mountview Court
    310 Friern Barnet Lane, Whetstone
    N20 0YZ London
    2
    FechaTipo
    18 sept 2006Inicio de la liquidación
    12 sept 2013Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de acreedores
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Freddy Khalastchi
    Harris Lipman Llp 2 Mountview Court
    310 Friern Barnet Lane, Whetstone
    N20 0YZ London
    Profesional
    Harris Lipman Llp 2 Mountview Court
    310 Friern Barnet Lane, Whetstone
    N20 0YZ London
    Freddy Khalastchi
    Harris Lipman Llp 2 Mountview Court
    310 Friern Barnet Lane, Whetstone
    N20 0YZ London
    Profesional
    Harris Lipman Llp 2 Mountview Court
    310 Friern Barnet Lane, Whetstone
    N20 0YZ London
    Barry David Lewis
    Harris Lipman
    2 Mountview Court
    N20 0YZ 310 Friern Barnet Lane
    Whetstone London
    Profesional
    Harris Lipman
    2 Mountview Court
    N20 0YZ 310 Friern Barnet Lane
    Whetstone London
    Barry David Lewis
    Harris Lipman
    2 Mountview Court
    N20 0YZ 310 Friern Barnet Lane
    Whetstone London
    Profesional
    Harris Lipman
    2 Mountview Court
    N20 0YZ 310 Friern Barnet Lane
    Whetstone London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0