RUGBY ESTATES LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | RUGBY ESTATES LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 02548935 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de RUGBY ESTATES LIMITED?
- Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción
- Compraventa de bienes inmobiliarios propios (68100) / Actividades inmobiliarias
¿Dónde se encuentra RUGBY ESTATES LIMITED?
Dirección de la sede social | The Island House Midsomer Norton Radstock BA3 2DZ Bath England |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de RUGBY ESTATES LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
DREAMRENT LIMITED | 16 oct 1990 | 16 oct 1990 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de RUGBY ESTATES LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 jul 2019 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para RUGBY ESTATES LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 jul 2019 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Cambio de datos del director Hugh Bernard Hepker el 15 nov 2019 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Adrian Brian Hepker el 15 nov 2019 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 16 oct 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 jul 2018 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Michael Zane Hepker el 22 mar 2019 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Bath Lodge Castle Nr Norton St. Philip Bath Somerset BA2 7NH a The Island House Midsomer Norton Radstock Bath BA3 2DZ el 04 abr 2019 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 16 oct 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Karen Lesley Hepker como director el 31 jul 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 jul 2017 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 16 oct 2017 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado de 34 Beckenham Road Beckenham BR3 4TU a Bath Lodge Castle Norton St. Philip Bath BA2 7NH | 1 páginas | AD02 | ||||||||||
Notification d'une déclaration relative à une personne disposant d'un contrôle significatif | 2 páginas | PSC08 | ||||||||||
Cessation de Michael Zane Hepker en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 17 oct 2016 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||
Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 jul 2016 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 16 oct 2016 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 jul 2015 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 16 oct 2015 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 jul 2014 | 23 páginas | AA | ||||||||||
Misceláneos Section 519 | 1 páginas | MISC | ||||||||||
Exercice comptable précédent raccourci du 31 jul 2014 au 30 jul 2014 | 3 páginas | AA01 | ||||||||||
Nombramiento de Adrian Brian Hepker como director el 29 oct 2014 | 3 páginas | AP01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de RUGBY ESTATES LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEPKER, Adrian Brian | Director | Midsomer Norton BA3 2DZ Radstock The Island House Bath England | South Africa | South African | Computer Consultant | 192805320001 | ||||
HEPKER, Hugh Bernard | Director | Midsomer Norton Radstock BA3 2DZ Bath The Island House England | South Africa | South African | Businessman | 192806450001 | ||||
HEPKER, Michael Zane | Director | Malden Road NW5 3HH London 26 England | England | British | Legal Advisor | 175974250002 | ||||
JONES, Stephen Douglas | Secretario | Watts Lane BR7 5PJ Chislehurst Oak Lodge Kent | British | 135144660001 | ||||||
JONES, Stephen Douglas | Secretario | Oak Lodge Watts Lane BR7 5PJ Chislehurst Kent | British | 8695620002 | ||||||
WHITE, Timothy Scott | Secretario | Cornwall Road AL1 1SQ St Albans 37 Hertfordshire | British | 94700490001 | ||||||
BUCHANAN, Keith Michael | Director | The Seedlings Bridge Road PE12 9EQ Long Sutton Lincolnshire | British | Company Director | 6017680002 | |||||
DENNIS, Gerald Lambert | Director | 1 Prince Arthur Road Hampstead NW3 6AX London | British | Director | 27050760001 | |||||
HEPKER, Karen Lesley | Director | Nr Norton St. Philip BA2 7NH Bath Bath Lodge Castle Somerset United Kingdom | United Kingdom | British | Hotelier | 175973980001 | ||||
JACKSON, John Andrew | Director | 7 Hill Court 34 Highgate West Hill Highgate N6 6NU London | United Kingdom | British | Director | 6810690002 | ||||
JONES, Stephen Douglas | Director | Oak Lodge Watts Lane BR7 5PJ Chislehurst Kent | United Kingdom | British | Company Director | 8695620002 | ||||
LINDOP, David John | Director | 4 Farm Street London W1J 5RD | United Kingdom | British | Director | 157056280001 | ||||
MACKIE, Raymond John | Director | The Rosary Mile Path GU22 0DY Woking Surrey | England | British | Chartered Accountant | 58192040001 | ||||
MARISCOTTI, Michael Gordon | Director | Redcraft Spencers Green HP23 6LA Tring Hertfordshire | British | Company Director | 17449850001 | |||||
MARTIN, Benjamin John | Director | Roughetts Eggpie Lane Hildenborough TN11 8PE Tonbridge Kent | United Kingdom | British | Director | 38321400001 | ||||
TAYLOR, Neal Anthony | Director | Weybridge Park KT13 8SJ Weybridge 9 Surrey | England | English | Director | 65914360002 | ||||
TEACHER, Michael John | Director | 18 Valencia Road HA7 4JH Stanmore Middlesex | United Kingdom | British | Director | 25420830001 | ||||
TWEEDDALE-TYE, David Michael Francis | Director | Ovington Street SW3 2JB London 34 United Kingdom | England | British | Company Director | 111888220002 | ||||
TYRIE, Andrew Guy, The Rt Hon. The Lord Tyrie Of Chichester, | Director | 9 Burton House Durniton GU28 0QU Petworth West Sussex | England | British | Mp | 84237830001 | ||||
WILDMAN, Alexander James Franklin | Director | Chesson Road W14 9QU London 102 | United Kingdom | British | Director | 44059520002 | ||||
WILSON, Andrew Luis | Director | Alassio 243 Thorpe Hall Avenue SS1 3SG Thorpe Bay Southend Essex | United Kingdom | British | Company Director | 31101960006 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de RUGBY ESTATES LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado |
---|---|---|---|
Mr Michael Zane Hepker | 16 oct 2016 | Norton St. Philip BA2 7NH Bath Bath Lodge Castle England | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: United Kingdom | |||
Naturaleza del control
|
¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para RUGBY ESTATES LIMITED?
Notificado el | Cesado el | Declaración |
---|---|---|
17 oct 2016 | La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa. |
¿Tiene RUGBY ESTATES LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Share charge | Creado el 07 sept 2006 Entregado el 27 sept 2006 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed charge the investments including all rights of enforcement. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Mortgage of shares | Creado el 02 feb 1995 Entregado el 07 feb 1995 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All moneys due or to become due from the company and each borrower (as defined) to the chargee on any account whatsoever under each finance document (as defined) | |
Breve descripción The shares all dividends payable on all of the shares all stocks shares securities rights moneys or property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0