RUGBY ESTATES LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Declaraciones de personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaRUGBY ESTATES LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02548935
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de RUGBY ESTATES LIMITED?

    • Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción
    • Compraventa de bienes inmobiliarios propios (68100) / Actividades inmobiliarias

    ¿Dónde se encuentra RUGBY ESTATES LIMITED?

    Dirección de la sede social
    The Island House Midsomer Norton
    Radstock
    BA3 2DZ Bath
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de RUGBY ESTATES LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    DREAMRENT LIMITED16 oct 199016 oct 1990

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de RUGBY ESTATES LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 jul 2019

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para RUGBY ESTATES LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 jul 2019

    4 páginasAA

    Cambio de datos del director Hugh Bernard Hepker el 15 nov 2019

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Adrian Brian Hepker el 15 nov 2019

    2 páginasCH01

    Declaración de confirmación presentada el 16 oct 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 jul 2018

    4 páginasAA

    Cambio de datos del director Mr Michael Zane Hepker el 22 mar 2019

    2 páginasCH01

    Domicilio social registrado cambiado de Bath Lodge Castle Nr Norton St. Philip Bath Somerset BA2 7NH a The Island House Midsomer Norton Radstock Bath BA3 2DZ el 04 abr 2019

    1 páginasAD01

    Declaración de confirmación presentada el 16 oct 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Karen Lesley Hepker como director el 31 jul 2018

    1 páginasTM01

    Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 jul 2017

    4 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 16 oct 2017 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado de 34 Beckenham Road Beckenham BR3 4TU a Bath Lodge Castle Norton St. Philip Bath BA2 7NH

    1 páginasAD02

    Notification d'une déclaration relative à une personne disposant d'un contrôle significatif

    2 páginasPSC08

    Cessation de Michael Zane Hepker en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 17 oct 2016

    1 páginasPSC07

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 jul 2016

    6 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 16 oct 2016 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 jul 2015

    6 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 16 oct 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital08 dic 2015

    Estado de capital el 08 dic 2015

    • Capital: GBP 76,461.84
    SH01

    Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 jul 2014

    23 páginasAA

    Misceláneos

    Section 519
    1 páginasMISC

    Exercice comptable précédent raccourci du 31 jul 2014 au 30 jul 2014

    3 páginasAA01

    Nombramiento de Adrian Brian Hepker como director el 29 oct 2014

    3 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de RUGBY ESTATES LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    HEPKER, Adrian Brian
    Midsomer Norton
    BA3 2DZ Radstock
    The Island House
    Bath
    England
    Director
    Midsomer Norton
    BA3 2DZ Radstock
    The Island House
    Bath
    England
    South AfricaSouth AfricanComputer Consultant192805320001
    HEPKER, Hugh Bernard
    Midsomer Norton
    Radstock
    BA3 2DZ Bath
    The Island House
    England
    Director
    Midsomer Norton
    Radstock
    BA3 2DZ Bath
    The Island House
    England
    South AfricaSouth AfricanBusinessman192806450001
    HEPKER, Michael Zane
    Malden Road
    NW5 3HH London
    26
    England
    Director
    Malden Road
    NW5 3HH London
    26
    England
    EnglandBritishLegal Advisor175974250002
    JONES, Stephen Douglas
    Watts Lane
    BR7 5PJ Chislehurst
    Oak Lodge
    Kent
    Secretario
    Watts Lane
    BR7 5PJ Chislehurst
    Oak Lodge
    Kent
    British135144660001
    JONES, Stephen Douglas
    Oak Lodge
    Watts Lane
    BR7 5PJ Chislehurst
    Kent
    Secretario
    Oak Lodge
    Watts Lane
    BR7 5PJ Chislehurst
    Kent
    British8695620002
    WHITE, Timothy Scott
    Cornwall Road
    AL1 1SQ St Albans
    37
    Hertfordshire
    Secretario
    Cornwall Road
    AL1 1SQ St Albans
    37
    Hertfordshire
    British94700490001
    BUCHANAN, Keith Michael
    The Seedlings
    Bridge Road
    PE12 9EQ Long Sutton
    Lincolnshire
    Director
    The Seedlings
    Bridge Road
    PE12 9EQ Long Sutton
    Lincolnshire
    BritishCompany Director6017680002
    DENNIS, Gerald Lambert
    1 Prince Arthur Road
    Hampstead
    NW3 6AX London
    Director
    1 Prince Arthur Road
    Hampstead
    NW3 6AX London
    BritishDirector27050760001
    HEPKER, Karen Lesley
    Nr Norton St. Philip
    BA2 7NH Bath
    Bath Lodge Castle
    Somerset
    United Kingdom
    Director
    Nr Norton St. Philip
    BA2 7NH Bath
    Bath Lodge Castle
    Somerset
    United Kingdom
    United KingdomBritishHotelier175973980001
    JACKSON, John Andrew
    7 Hill Court
    34 Highgate West Hill Highgate
    N6 6NU London
    Director
    7 Hill Court
    34 Highgate West Hill Highgate
    N6 6NU London
    United KingdomBritishDirector6810690002
    JONES, Stephen Douglas
    Oak Lodge
    Watts Lane
    BR7 5PJ Chislehurst
    Kent
    Director
    Oak Lodge
    Watts Lane
    BR7 5PJ Chislehurst
    Kent
    United KingdomBritishCompany Director8695620002
    LINDOP, David John
    4 Farm Street
    London
    W1J 5RD
    Director
    4 Farm Street
    London
    W1J 5RD
    United KingdomBritishDirector157056280001
    MACKIE, Raymond John
    The Rosary
    Mile Path
    GU22 0DY Woking
    Surrey
    Director
    The Rosary
    Mile Path
    GU22 0DY Woking
    Surrey
    EnglandBritishChartered Accountant58192040001
    MARISCOTTI, Michael Gordon
    Redcraft
    Spencers Green
    HP23 6LA Tring
    Hertfordshire
    Director
    Redcraft
    Spencers Green
    HP23 6LA Tring
    Hertfordshire
    BritishCompany Director17449850001
    MARTIN, Benjamin John
    Roughetts
    Eggpie Lane Hildenborough
    TN11 8PE Tonbridge
    Kent
    Director
    Roughetts
    Eggpie Lane Hildenborough
    TN11 8PE Tonbridge
    Kent
    United KingdomBritishDirector38321400001
    TAYLOR, Neal Anthony
    Weybridge Park
    KT13 8SJ Weybridge
    9
    Surrey
    Director
    Weybridge Park
    KT13 8SJ Weybridge
    9
    Surrey
    EnglandEnglishDirector65914360002
    TEACHER, Michael John
    18 Valencia Road
    HA7 4JH Stanmore
    Middlesex
    Director
    18 Valencia Road
    HA7 4JH Stanmore
    Middlesex
    United KingdomBritishDirector25420830001
    TWEEDDALE-TYE, David Michael Francis
    Ovington Street
    SW3 2JB London
    34
    United Kingdom
    Director
    Ovington Street
    SW3 2JB London
    34
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director111888220002
    TYRIE, Andrew Guy, The Rt Hon. The Lord Tyrie Of Chichester,
    9 Burton House
    Durniton
    GU28 0QU Petworth
    West Sussex
    Director
    9 Burton House
    Durniton
    GU28 0QU Petworth
    West Sussex
    EnglandBritishMp84237830001
    WILDMAN, Alexander James Franklin
    Chesson Road
    W14 9QU London
    102
    Director
    Chesson Road
    W14 9QU London
    102
    United KingdomBritishDirector44059520002
    WILSON, Andrew Luis
    Alassio
    243 Thorpe Hall Avenue
    SS1 3SG Thorpe Bay Southend
    Essex
    Director
    Alassio
    243 Thorpe Hall Avenue
    SS1 3SG Thorpe Bay Southend
    Essex
    United KingdomBritishCompany Director31101960006

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de RUGBY ESTATES LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Mr Michael Zane Hepker
    Norton St. Philip
    BA2 7NH Bath
    Bath Lodge Castle
    England
    16 oct 2016
    Norton St. Philip
    BA2 7NH Bath
    Bath Lodge Castle
    England
    Nacionalidad: British
    País de residencia: United Kingdom
    Naturaleza del control
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre la empresa.

    ¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para RUGBY ESTATES LIMITED?

    Declaraciones de personas con control significativo
    Notificado elCesado elDeclaración
    17 oct 2016La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa.

    ¿Tiene RUGBY ESTATES LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Share charge
    Creado el 07 sept 2006
    Entregado el 27 sept 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed charge the investments including all rights of enforcement. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 27 sept 2006Registro de un cargo (395)
    • 07 nov 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Mortgage of shares
    Creado el 02 feb 1995
    Entregado el 07 feb 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys due or to become due from the company and each borrower (as defined) to the chargee on any account whatsoever under each finance document (as defined)
    Breve descripción
    The shares all dividends payable on all of the shares all stocks shares securities rights moneys or property. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Bayerische Hypotheken-Und Wechsel-Bank Aktiengesellschaft, London Branch
    Transacciones
    • 07 feb 1995Registro de un cargo (395)
    • 07 nov 2013Satisfacción de una carga (MR04)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0