MATTHEW CLARK BIBENDUM LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | MATTHEW CLARK BIBENDUM LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02550982 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de MATTHEW CLARK BIBENDUM LIMITED?
- Comercio al por mayor de vino, cerveza, bebidas espirituosas y otras bebidas alcohólicas (46342) / Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas
¿Dónde se encuentra MATTHEW CLARK BIBENDUM LIMITED?
| Dirección de la sede social | Pavilion 2 The Pavilions Bridgwater Road BS99 6ZZ Bristol England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de MATTHEW CLARK BIBENDUM LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| CONVIVIALITY GROUP LIMITED | 27 jun 2017 | 27 jun 2017 |
| MATTHEW CLARK WHOLESALE LIMITED | 30 sept 1996 | 30 sept 1996 |
| FREETRADERS LIMITED | 18 feb 1991 | 18 feb 1991 |
| FREE TRADERS LIMITED | 09 ene 1991 | 09 ene 1991 |
| OVAL (668) LIMITED | 23 oct 1990 | 23 oct 1990 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de MATTHEW CLARK BIBENDUM LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 28 feb 2026 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 nov 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 28 feb 2025 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para MATTHEW CLARK BIBENDUM LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 07 nov 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 21 nov 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 07 nov 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para MATTHEW CLARK BIBENDUM LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Cambio de datos del director Mr Andrea Pozzi el 13 nov 2025 | 2 páginas | CH01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 07 nov 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 28 feb 2025 | 43 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Clara Shand como director el 28 feb 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 01 dic 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 29 feb 2024 | 44 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Ewan James Robertson como director el 25 jun 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Patrick Mcmahon como director el 06 jun 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 28 feb 2023 | 44 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 01 dic 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de James Kowszun como director el 30 nov 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de Whitchurch Lane Bristol BS14 0JZ a Pavilion 2 the Pavilions Bridgwater Road Bristol BS99 6ZZ el 24 nov 2023 | 1 páginas | AD01 | ||
Nombramiento de Mr Ewan James Robertson como director el 01 jun 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mark Mcgloin como director el 01 jun 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Richard Joseph Webster como director el 31 mar 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 01 dic 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 28 feb 2022 | 39 páginas | AA | ||
Segunda presentación de la Declaración de confirmación fechada el 01 dic 2021 | 3 páginas | RP04CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 28 feb 2021 | 36 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Ewan James Robertson como director el 23 feb 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Cambio de datos del director Mr Richard Joseph Webster el 01 feb 2022 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del director Mr Andrea Pozzi el 31 ene 2022 | 2 páginas | CH01 | ||
Nombramiento de James Kowszun como director el 19 ene 2022 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Clara Shand como director el 19 ene 2022 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr Richard Joseph Webster como director el 19 ene 2022 | 2 páginas | AP01 | ||
¿Quiénes son los directivos de MATTHEW CLARK BIBENDUM LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C&C MANAGEMENT SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | Keeper Road Crumlin Bulmers House Dublin 12, D12 K702 Ireland |
| 172928540001 | ||||||||||||||
| HEFFERNAN, Riona | Director | The Pavilions Bridgwater Road BS99 6ZZ Bristol Pavilion 2 England | Ireland | Irish | 291613850001 | |||||||||||||
| MCGLOIN, Mark | Director | The Pavilions Bridgwater Road BS99 6ZZ Bristol Pavilion 2 England | Ireland | Irish | 309698680001 | |||||||||||||
| POZZI, Andrea | Director | The Pavilions Bridgwater Road BS99 6ZZ Bristol Pavilion 2 England | Italy | Italian | 195181530003 | |||||||||||||
| BARRASS, Judith Heather | Secretario | The Old Byre Sevington Grittleton SN14 7LD Chippenham | British | 76221580002 | ||||||||||||||
| BASHFORTH, Edward Michael | Secretario | Second Avenue DE14 2WF Burton-On-Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | 172483120001 | |||||||||||||||
| CLOTHIER, Esther | Secretario | The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR Guildford Accolade House Surrey United Kingdom | 161078100001 | |||||||||||||||
| COLQUHOUN, Anne Therese | Secretario | Apartment B Kings Ride House Prince Albert Drive SL5 8AQ Ascot | British | 28396500005 | ||||||||||||||
| COLQUHOUN, Anne Therese | Secretario | The Coach House Weston Lane BA1 4AA Bath | British | 28396500003 | ||||||||||||||
| GREGORY, David Noel | Secretario | 15 Orchard Rise TW10 5BX Richmond Surrey | British | 14735490001 | ||||||||||||||
| MALHOTRA, Deepak Kumar | Secretario | The Guildway, Old Portsmouth Road Artington GU3 1LR Guildford Constellation House Surrey United Kingdom | British | 69554640002 | ||||||||||||||
| MUSSELWHITE, Madeleine Suzanne | Secretario | The Guildway, Old Portsmouth Road Artington GU3 1LR Guildford Constellation House Surrey United Kingdom | 157759910001 | |||||||||||||||
| C&C MANAGEMENT SERVICES (UK) LIMITED | Secretario corporativo | Grenadier Road Exeter Business Park EX1 3LH Exeter Ashford House England |
| 245149380001 | ||||||||||||||
| ADER, Michael Simon | Director | Whitegable House Kirk Lane NG11 6NN Ruddington | England | British | 152055250001 | |||||||||||||
| AYLWIN, Mark Terence | Director | BS14 0JZ Bristol Whitchurch Lane | England | British | 105140040001 | |||||||||||||
| BASHFORTH, Edward Michael | Director | Second Avenue DE14 2WF Burton-On-Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 131551840002 | |||||||||||||
| BONES, David Christopher | Director | 6 Trowle Common BA14 9BJ Trowbridge Wiltshire | England | British | 60302270001 | |||||||||||||
| CARSON, Christopher | Director | White Gates 11 Oxshott Way KT11 2RU Cobham Surrey | British | 26602290003 | ||||||||||||||
| CHRISTENSEN, Troy | Director | BS14 0JZ Bristol Whitchurch Lane England | Australia | American | 130789730002 | |||||||||||||
| CHRISTENSEN, Troy | Director | The Guildway, Old Portsmouth Road Artington GU3 1LR Guildford Constellation House Surrey United Kingdom | Australia | American | 130789730002 | |||||||||||||
| COLQUHOUN, Anne Therese | Director | Apartment B Kings Ride House Prince Albert Drive SL5 8AQ Ascot | United Kingdom | British | 28396500005 | |||||||||||||
| CRANE, Charles Michael | Director | 41 Queens Gardens W2 3AA London | British | 14735480001 | ||||||||||||||
| CREIGHTON, Thomas Hugh | Director | Apple Acre High Road CR5 3QR Chipstead Surrey | England | British | 157727790001 | |||||||||||||
| DANDO, Stephen Peter | Director | Second Avenue DE14 2WF Burton-On-Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 152083750001 | |||||||||||||
| DUTTON, Philip | Director | Second Avenue DE14 2WF Burton-On-Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 141395280001 | |||||||||||||
| ETHERIDGE, Hugh Charles | Director | 5 Springfield Place BA1 5RA Bath Avon | United Kingdom | British | 1491130002 | |||||||||||||
| FISHER, David Michael | Director | Ashley Wood Kingsdown SN14 9BH Corsham Wiltshire | British | 76571110001 | ||||||||||||||
| GLENNIE, Helen Margaret | Director | The Guildway, Old Portsmouth Road Artington GU3 1LR Guildford Constellation House Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | 137615160001 | |||||||||||||
| GREGORY, David Noel | Director | 15 Orchard Rise TW10 5BX Richmond Surrey | England | British | 14735490001 | |||||||||||||
| GRISMAN, Martin Gerald | Director | BS14 0JZ Bristol Whitchurch Lane | England | British | 69428030002 | |||||||||||||
| GRISMAN, Martin Gerald | Director | BS14 0JZ Bristol Whitchurch Lane England | England | British | 69428030002 | |||||||||||||
| HODGES, Nigel Ian | Director | Sonning House 2 Canns Lane TA6 6QF North Petherton Somerset | British | 75692570001 | ||||||||||||||
| HOYLE, Russell Blackburn | Director | 77 Richmond Park Road East Sheen SW14 8JY London | British | 52822380001 | ||||||||||||||
| HUMPHREYS, Andrew | Director | BS14 0JZ Bristol Whitchurch Lane | England | British | 200489460001 | |||||||||||||
| HUNTER, Diana | Director | BS14 0JZ Bristol Whitchurch Lane | England | British | 170154190002 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de MATTHEW CLARK BIBENDUM LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Clark Bibendum (Holdings) Limited | 06 abr 2016 | Whitchurch BS14 0JZ Bristol Whitchurch Lane United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0