CONFEDERATION OF UK COAL PRODUCERS

CONFEDERATION OF UK COAL PRODUCERS

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCONFEDERATION OF UK COAL PRODUCERS
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social
    Número de empresa 02551116
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenesNo
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de CONFEDERATION OF UK COAL PRODUCERS?

    • Actividades de otras organizaciones de miembros n.c.p. (94990) / Otras actividades de servicios

    ¿Dónde se encuentra CONFEDERATION OF UK COAL PRODUCERS?

    Dirección de la sede social
    C/O Cox Costello Langwood House
    63-81 High Street
    WD3 1EQ Rickmansworth
    Hertfordshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de CONFEDERATION OF UK COAL PRODUCERS?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 jun 2016

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para CONFEDERATION OF UK COAL PRODUCERS?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 30 jun 2016

    7 páginasAA

    Exercice comptable en cours prolongé du 31 dic 2015 au 30 jun 2016

    1 páginasAA01

    Cese del nombramiento de Ian Anthony Charles Parkin como director el 27 oct 2015

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 23 oct 2015, aucune liste de membres fournie

    5 páginasAR01

    Cese del nombramiento de Ann Fellows, M.B.E. como secretario el 30 jun 2015

    1 páginasTM02

    Cambio de datos del director Mr John Campbell el 19 oct 2015

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Ian Anthony Charles Parkin el 19 oct 2015

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Neil Andrew Brown el 19 oct 2015

    2 páginasCH01

    Nombramiento de Mr Robert Kenneth Thompson como director el 03 dic 2014

    2 páginasAP01

    Domicilio social registrado cambiado de Confederation House Thornes Office Park Denby Dale Road Wakefield West Yorkshire WF2 7AN a C/O Cox Costello Langwood House 63-81 High Street Rickmansworth Hertfordshire WD3 1EQ el 16 nov 2015

    1 páginasAD01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 dic 2014

    4 páginasAA

    Segunda presentación de AR01 previamente entregado a Companies House elaborado el 23 oct 2013

    21 páginasRP04

    Segunda presentación de AR01 previamente entregado a Companies House elaborado el 23 oct 2012

    23 páginasRP04

    Cese del nombramiento de Gavin Anthony Styles como director el 03 dic 2014

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Simon Byway como director el 28 nov 2014

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Derek Mark Harrington como director el 24 nov 2014

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 23 oct 2014, aucune liste de membres fournie

    5 páginasAR01

    Nombramiento de Mr Gavin Anthony Styles como director el 02 jun 2012

    2 páginasAP01

    Domicilio social registrado cambiado de , Conferderation House, Thornes Office Park, Denby Dale Road, Wakefield, WF2 7AN a Confederation House Thornes Office Park Denby Dale Road Wakefield West Yorkshire WF2 7AN el 05 nov 2014

    1 páginasAD01

    Nombramiento de Mr Simon Byway como director el 01 jul 2012

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Thomas John Allchurch como director el 09 oct 2014

    1 páginasTM01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 dic 2013

    4 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de CONFEDERATION OF UK COAL PRODUCERS?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BROWN, Neil Andrew
    Langwood House
    63-81 High Street
    WD3 1EQ Rickmansworth
    C/O Cox Costello
    Hertfordshire
    England
    Director
    Langwood House
    63-81 High Street
    WD3 1EQ Rickmansworth
    C/O Cox Costello
    Hertfordshire
    England
    United KingdomBritish172615700001
    CAMPBELL, John
    Langwood House
    63-81 High Street
    WD3 1EQ Rickmansworth
    C/O Cox Costello
    Hertfordshire
    England
    Director
    Langwood House
    63-81 High Street
    WD3 1EQ Rickmansworth
    C/O Cox Costello
    Hertfordshire
    England
    United KingdomBritish191409340002
    THOMPSON, Robert Kenneth
    Langwood House
    63-81 High Street
    WD3 1EQ Rickmansworth
    C/O Cox Costello
    Hertfordshire
    England
    Director
    Langwood House
    63-81 High Street
    WD3 1EQ Rickmansworth
    C/O Cox Costello
    Hertfordshire
    England
    WalesBritish156919650001
    FELLOWS, M.B.E., Ann
    Langwood House
    63-81 High Street
    WD3 1EQ Rickmansworth
    C/O Cox Costello
    Hertfordshire
    England
    Secretario
    Langwood House
    63-81 High Street
    WD3 1EQ Rickmansworth
    C/O Cox Costello
    Hertfordshire
    England
    British39346050005
    GARNESS, Melvin
    11 The Drive
    DN22 6SD Retford
    Nottinghamshire
    Secretario
    11 The Drive
    DN22 6SD Retford
    Nottinghamshire
    British18761260001
    ALLCHURCH, Thomas John
    c/o Confederation Of Uk Coal Producers
    Thornes Office Park
    Denby Dale Road
    WF2 7AN Wakefield
    Confederation House
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Director
    c/o Confederation Of Uk Coal Producers
    Thornes Office Park
    Denby Dale Road
    WF2 7AN Wakefield
    Confederation House
    West Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish59108210004
    BEATTIE, Robert James
    The Mount House
    The Mount Farm
    EH35 5NN Ormiston
    East Lothian
    Director
    The Mount House
    The Mount Farm
    EH35 5NN Ormiston
    East Lothian
    British61571490001
    BREWER, David
    Stanley House 161 Chelsea Road
    S11 9BQ Sheffield
    Director
    Stanley House 161 Chelsea Road
    S11 9BQ Sheffield
    EnglandBritish62261620002
    BREWER, David
    Stanley House 161 Chelsea Road
    S11 9BQ Sheffield
    Director
    Stanley House 161 Chelsea Road
    S11 9BQ Sheffield
    EnglandBritish62261620002
    BROWN, James Scott
    Kirklands Of Damside
    PH3 1EU Auchterarder
    Perthshire
    Director
    Kirklands Of Damside
    PH3 1EU Auchterarder
    Perthshire
    ScotlandBritish255210001
    BUDGE, Richard John
    Conferderation House
    Thornes Office Park
    WF2 7AN Denby Dale Road
    Wakefield
    Director
    Conferderation House
    Thornes Office Park
    WF2 7AN Denby Dale Road
    Wakefield
    United KingdomBritish27948060002
    BYWAY, Simon
    Harworth Park, Blyth Road
    Harworth
    DN11 8DB Doncaster
    Harworth Park
    South Yorkshire
    England
    Director
    Harworth Park, Blyth Road
    Harworth
    DN11 8DB Doncaster
    Harworth Park
    South Yorkshire
    England
    EnglandBritish178514550001
    CAIRNS, Philip
    Conferderation House
    Thornes Office Park
    WF2 7AN Denby Dale Road
    Wakefield
    Director
    Conferderation House
    Thornes Office Park
    WF2 7AN Denby Dale Road
    Wakefield
    United KingdomBritish127894480003
    CAVE, Philip John
    c/o Confederation Of Uk Coal Producers
    Thornes Office Park
    Denby Dale Road
    WF2 7AN Wakefield
    Confederation House
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Director
    c/o Confederation Of Uk Coal Producers
    Thornes Office Park
    Denby Dale Road
    WF2 7AN Wakefield
    Confederation House
    West Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish108806440003
    CHANCE, John Charles
    Linden Farm Bullbridge Hill
    Fritchley
    DE56 2FL Belper
    Derbyshire
    Director
    Linden Farm Bullbridge Hill
    Fritchley
    DE56 2FL Belper
    Derbyshire
    British43220520001
    CLARKE, Robert Anthony
    44 Leadhall Lane
    HG2 9NE Harrogate
    North Yorkshire
    Director
    44 Leadhall Lane
    HG2 9NE Harrogate
    North Yorkshire
    British3221280001
    CRABB, Niall Crawford
    24 Ancrum Road
    EH22 3AJ Dalkeith
    Midlothian
    Director
    24 Ancrum Road
    EH22 3AJ Dalkeith
    Midlothian
    British67196950004
    CRABB, Niall Crawford
    The Paddock
    Arleston Lane Wellington
    TF1 2LY Telford
    Shropshire
    Director
    The Paddock
    Arleston Lane Wellington
    TF1 2LY Telford
    Shropshire
    British67196950001
    CROSLAND, Ian Maxwell
    The Falls High Street
    Silkstone
    S75 4JN Barnsley
    South Yorkshire
    Director
    The Falls High Street
    Silkstone
    S75 4JN Barnsley
    South Yorkshire
    British55221540001
    DEVINE, Iain James
    Pontefract Road
    Ackworth
    WF7 7EU Pontefract
    Paddock House
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Director
    Pontefract Road
    Ackworth
    WF7 7EU Pontefract
    Paddock House
    West Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish87925400001
    FENTON, Guy James
    Loanhead Farmhouse
    Guildtown
    PH2 6DF Perth
    Director
    Loanhead Farmhouse
    Guildtown
    PH2 6DF Perth
    ScotlandBritish52045430003
    GARNER, Philip Edward
    c/o Confederation Of Uk Coal Producers
    Thornes Office Park
    Denby Dale Road
    WF2 7AN Wakefield
    Confederation House
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Director
    c/o Confederation Of Uk Coal Producers
    Thornes Office Park
    Denby Dale Road
    WF2 7AN Wakefield
    Confederation House
    West Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish120193760001
    GILBERTSON, Alan Seaton
    39 Castle Street
    Warkworth
    NE65 0UN Morpeth
    Northumberland
    Director
    39 Castle Street
    Warkworth
    NE65 0UN Morpeth
    Northumberland
    British69796870001
    GODFREY, Colin Leonard
    Liddell House
    Silver Street South Cerney
    GL7 5TS Cirencester
    Gloucestershire
    Director
    Liddell House
    Silver Street South Cerney
    GL7 5TS Cirencester
    Gloucestershire
    United KingdomBritish48286090001
    GOLIGHTLY, Andrew Philip
    11 Spring Gardens
    West Auckland
    DL14 9SL Bishop Auckland
    County Durham
    Director
    11 Spring Gardens
    West Auckland
    DL14 9SL Bishop Auckland
    County Durham
    British64156970002
    HARRINGTON, Derek Mark
    Thornes Office Park
    Denby Dale Road
    WF2 7AN Wakefield
    Confederation House
    West Yorkshire
    England
    Director
    Thornes Office Park
    Denby Dale Road
    WF2 7AN Wakefield
    Confederation House
    West Yorkshire
    England
    EnglandBritish127775390001
    HINKLEY, Geoffrey Andrew
    6 Reigate Hill Close
    RH2 9PG Reigate
    Surrey
    Director
    6 Reigate Hill Close
    RH2 9PG Reigate
    Surrey
    British37928390001
    HUGHES, James
    1 Strethill Road
    Coalbrookdale
    TF8 7DP Telford
    Salop
    Director
    1 Strethill Road
    Coalbrookdale
    TF8 7DP Telford
    Salop
    British69658440001
    HUNT, Melvyn William Benoit
    The Old Barn
    1 Grange Court High Grange
    DL15 8AZ Crook
    County Durham
    Director
    The Old Barn
    1 Grange Court High Grange
    DL15 8AZ Crook
    County Durham
    United KingdomBritish16763200002
    IKE, Henry Max
    6 Hutton Close
    Nether Poppleton
    YO26 6PJ York
    North Yorkshire
    Director
    6 Hutton Close
    Nether Poppleton
    YO26 6PJ York
    North Yorkshire
    Dutch67313250001
    LEVACK, Richard John
    Craighead
    Whistleberry Road
    G72 0TH Blantyre
    Glasgow
    Director
    Craighead
    Whistleberry Road
    G72 0TH Blantyre
    Glasgow
    British22998090002
    MCGLEN, Christopher Andrew
    Conferderation House
    Thornes Office Park
    WF2 7AN Denby Dale Road
    Wakefield
    Director
    Conferderation House
    Thornes Office Park
    WF2 7AN Denby Dale Road
    Wakefield
    United KingdomBritish110428450001
    MCMEEKIN, Peter Henry Hubert
    11 Barn Mead
    Theydon Bois
    CM16 7ET Epping
    Essex
    Director
    11 Barn Mead
    Theydon Bois
    CM16 7ET Epping
    Essex
    British31080540001
    O'BRIEN, Patrick Sampson
    The Pantiles Main Street
    Hayton
    DN22 9LH Retford
    Nottinghamshire
    Director
    The Pantiles Main Street
    Hayton
    DN22 9LH Retford
    Nottinghamshire
    British52186290001
    PARKIN, Ian Anthony Charles
    Langwood House
    63-81 High Street
    WD3 1EQ Rickmansworth
    C/O Cox Costello
    Hertfordshire
    England
    Director
    Langwood House
    63-81 High Street
    WD3 1EQ Rickmansworth
    C/O Cox Costello
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritish18214980001

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0