CONFEDERATION OF UK COAL PRODUCERS
Visión general
| Nombre de la empresa | CONFEDERATION OF UK COAL PRODUCERS |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social |
| Número de empresa | 02551116 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de CONFEDERATION OF UK COAL PRODUCERS?
- Actividades de otras organizaciones de miembros n.c.p. (94990) / Otras actividades de servicios
¿Dónde se encuentra CONFEDERATION OF UK COAL PRODUCERS?
| Dirección de la sede social | C/O Cox Costello Langwood House 63-81 High Street WD3 1EQ Rickmansworth Hertfordshire |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de CONFEDERATION OF UK COAL PRODUCERS?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 jun 2016 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para CONFEDERATION OF UK COAL PRODUCERS?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||
Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 30 jun 2016 | 7 páginas | AA | ||
Exercice comptable en cours prolongé du 31 dic 2015 au 30 jun 2016 | 1 páginas | AA01 | ||
Cese del nombramiento de Ian Anthony Charles Parkin como director el 27 oct 2015 | 1 páginas | TM01 | ||
Déclaration annuelle établie au 23 oct 2015, aucune liste de membres fournie | 5 páginas | AR01 | ||
Cese del nombramiento de Ann Fellows, M.B.E. como secretario el 30 jun 2015 | 1 páginas | TM02 | ||
Cambio de datos del director Mr John Campbell el 19 oct 2015 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del director Mr Ian Anthony Charles Parkin el 19 oct 2015 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del director Mr Neil Andrew Brown el 19 oct 2015 | 2 páginas | CH01 | ||
Nombramiento de Mr Robert Kenneth Thompson como director el 03 dic 2014 | 2 páginas | AP01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de Confederation House Thornes Office Park Denby Dale Road Wakefield West Yorkshire WF2 7AN a C/O Cox Costello Langwood House 63-81 High Street Rickmansworth Hertfordshire WD3 1EQ el 16 nov 2015 | 1 páginas | AD01 | ||
Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 dic 2014 | 4 páginas | AA | ||
Segunda presentación de AR01 previamente entregado a Companies House elaborado el 23 oct 2013 | 21 páginas | RP04 | ||
Segunda presentación de AR01 previamente entregado a Companies House elaborado el 23 oct 2012 | 23 páginas | RP04 | ||
Cese del nombramiento de Gavin Anthony Styles como director el 03 dic 2014 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Simon Byway como director el 28 nov 2014 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Derek Mark Harrington como director el 24 nov 2014 | 1 páginas | TM01 | ||
Déclaration annuelle établie au 23 oct 2014, aucune liste de membres fournie | 5 páginas | AR01 | ||
Nombramiento de Mr Gavin Anthony Styles como director el 02 jun 2012 | 2 páginas | AP01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de , Conferderation House, Thornes Office Park, Denby Dale Road, Wakefield, WF2 7AN a Confederation House Thornes Office Park Denby Dale Road Wakefield West Yorkshire WF2 7AN el 05 nov 2014 | 1 páginas | AD01 | ||
Nombramiento de Mr Simon Byway como director el 01 jul 2012 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Thomas John Allchurch como director el 09 oct 2014 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 dic 2013 | 4 páginas | AA | ||
¿Quiénes son los directivos de CONFEDERATION OF UK COAL PRODUCERS?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BROWN, Neil Andrew | Director | Langwood House 63-81 High Street WD3 1EQ Rickmansworth C/O Cox Costello Hertfordshire England | United Kingdom | British | 172615700001 | |||||
| CAMPBELL, John | Director | Langwood House 63-81 High Street WD3 1EQ Rickmansworth C/O Cox Costello Hertfordshire England | United Kingdom | British | 191409340002 | |||||
| THOMPSON, Robert Kenneth | Director | Langwood House 63-81 High Street WD3 1EQ Rickmansworth C/O Cox Costello Hertfordshire England | Wales | British | 156919650001 | |||||
| FELLOWS, M.B.E., Ann | Secretario | Langwood House 63-81 High Street WD3 1EQ Rickmansworth C/O Cox Costello Hertfordshire England | British | 39346050005 | ||||||
| GARNESS, Melvin | Secretario | 11 The Drive DN22 6SD Retford Nottinghamshire | British | 18761260001 | ||||||
| ALLCHURCH, Thomas John | Director | c/o Confederation Of Uk Coal Producers Thornes Office Park Denby Dale Road WF2 7AN Wakefield Confederation House West Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 59108210004 | |||||
| BEATTIE, Robert James | Director | The Mount House The Mount Farm EH35 5NN Ormiston East Lothian | British | 61571490001 | ||||||
| BREWER, David | Director | Stanley House 161 Chelsea Road S11 9BQ Sheffield | England | British | 62261620002 | |||||
| BREWER, David | Director | Stanley House 161 Chelsea Road S11 9BQ Sheffield | England | British | 62261620002 | |||||
| BROWN, James Scott | Director | Kirklands Of Damside PH3 1EU Auchterarder Perthshire | Scotland | British | 255210001 | |||||
| BUDGE, Richard John | Director | Conferderation House Thornes Office Park WF2 7AN Denby Dale Road Wakefield | United Kingdom | British | 27948060002 | |||||
| BYWAY, Simon | Director | Harworth Park, Blyth Road Harworth DN11 8DB Doncaster Harworth Park South Yorkshire England | England | British | 178514550001 | |||||
| CAIRNS, Philip | Director | Conferderation House Thornes Office Park WF2 7AN Denby Dale Road Wakefield | United Kingdom | British | 127894480003 | |||||
| CAVE, Philip John | Director | c/o Confederation Of Uk Coal Producers Thornes Office Park Denby Dale Road WF2 7AN Wakefield Confederation House West Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 108806440003 | |||||
| CHANCE, John Charles | Director | Linden Farm Bullbridge Hill Fritchley DE56 2FL Belper Derbyshire | British | 43220520001 | ||||||
| CLARKE, Robert Anthony | Director | 44 Leadhall Lane HG2 9NE Harrogate North Yorkshire | British | 3221280001 | ||||||
| CRABB, Niall Crawford | Director | 24 Ancrum Road EH22 3AJ Dalkeith Midlothian | British | 67196950004 | ||||||
| CRABB, Niall Crawford | Director | The Paddock Arleston Lane Wellington TF1 2LY Telford Shropshire | British | 67196950001 | ||||||
| CROSLAND, Ian Maxwell | Director | The Falls High Street Silkstone S75 4JN Barnsley South Yorkshire | British | 55221540001 | ||||||
| DEVINE, Iain James | Director | Pontefract Road Ackworth WF7 7EU Pontefract Paddock House West Yorkshire United Kingdom | England | British | 87925400001 | |||||
| FENTON, Guy James | Director | Loanhead Farmhouse Guildtown PH2 6DF Perth | Scotland | British | 52045430003 | |||||
| GARNER, Philip Edward | Director | c/o Confederation Of Uk Coal Producers Thornes Office Park Denby Dale Road WF2 7AN Wakefield Confederation House West Yorkshire United Kingdom | England | British | 120193760001 | |||||
| GILBERTSON, Alan Seaton | Director | 39 Castle Street Warkworth NE65 0UN Morpeth Northumberland | British | 69796870001 | ||||||
| GODFREY, Colin Leonard | Director | Liddell House Silver Street South Cerney GL7 5TS Cirencester Gloucestershire | United Kingdom | British | 48286090001 | |||||
| GOLIGHTLY, Andrew Philip | Director | 11 Spring Gardens West Auckland DL14 9SL Bishop Auckland County Durham | British | 64156970002 | ||||||
| HARRINGTON, Derek Mark | Director | Thornes Office Park Denby Dale Road WF2 7AN Wakefield Confederation House West Yorkshire England | England | British | 127775390001 | |||||
| HINKLEY, Geoffrey Andrew | Director | 6 Reigate Hill Close RH2 9PG Reigate Surrey | British | 37928390001 | ||||||
| HUGHES, James | Director | 1 Strethill Road Coalbrookdale TF8 7DP Telford Salop | British | 69658440001 | ||||||
| HUNT, Melvyn William Benoit | Director | The Old Barn 1 Grange Court High Grange DL15 8AZ Crook County Durham | United Kingdom | British | 16763200002 | |||||
| IKE, Henry Max | Director | 6 Hutton Close Nether Poppleton YO26 6PJ York North Yorkshire | Dutch | 67313250001 | ||||||
| LEVACK, Richard John | Director | Craighead Whistleberry Road G72 0TH Blantyre Glasgow | British | 22998090002 | ||||||
| MCGLEN, Christopher Andrew | Director | Conferderation House Thornes Office Park WF2 7AN Denby Dale Road Wakefield | United Kingdom | British | 110428450001 | |||||
| MCMEEKIN, Peter Henry Hubert | Director | 11 Barn Mead Theydon Bois CM16 7ET Epping Essex | British | 31080540001 | ||||||
| O'BRIEN, Patrick Sampson | Director | The Pantiles Main Street Hayton DN22 9LH Retford Nottinghamshire | British | 52186290001 | ||||||
| PARKIN, Ian Anthony Charles | Director | Langwood House 63-81 High Street WD3 1EQ Rickmansworth C/O Cox Costello Hertfordshire England | England | British | 18214980001 |
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0