FINTRADE TECHNOLOGIES LTD

FINTRADE TECHNOLOGIES LTD

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaFINTRADE TECHNOLOGIES LTD
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02552592
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de FINTRADE TECHNOLOGIES LTD?

    • (2754) /

    ¿Dónde se encuentra FINTRADE TECHNOLOGIES LTD?

    Dirección de la sede social
    Kings Wharf
    20-30 Kings Road
    RG1 3EX Reading
    Berkshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de FINTRADE TECHNOLOGIES LTD?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    ALLOY WHEELS INTERNATIONAL LIMITED05 feb 199105 feb 1991
    MISLEX (5) LIMITED26 oct 199026 oct 1990

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de FINTRADE TECHNOLOGIES LTD?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 jun 2002

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para FINTRADE TECHNOLOGIES LTD?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Aplazamiento de la disolución

    1 páginasL64.04

    Finalización de la liquidación

    1 páginasL64.07

    Misceláneos

    Sec of state's release of liq
    1 páginasMISC

    Misceláneos

    Sec of state's release of liq
    1 páginasMISC

    Orden del tribunal para liquidar

    1 páginasCOCOMP

    Orden del tribunal para liquidar

    1 páginasCOCOMP

    Declaración de recibos y pagos del liquidador

    8 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador

    5 páginas4.68

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Informe de progreso del administrador

    4 páginas2.24B

    Aviso de cambio de la administración a la liquidación voluntaria de acreedores

    4 páginas2.34B

    Resultado de la reunión de acreedores

    3 páginas2.23B

    Declaración de la propuesta del administrador

    15 páginas2.17B

    Informe de progreso del administrador

    5 páginas2.24B

    Declaración de asuntos

    18 páginas2.16B

    Resultado de la reunión de acreedores

    3 páginas2.23B

    Declaración de la propuesta del administrador

    31 páginas2.17B

    Nombramiento de un administrador

    1 páginas2.12B

    legacy

    1 páginas287

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    6 páginas363a

    legacy

    1 páginas288c

    ¿Quiénes son los directivos de FINTRADE TECHNOLOGIES LTD?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    ARM SECRETARIES LIMITED
    Somers Mounts Hill
    Benenden
    TN17 4ET Cranbrook
    Kent
    Secretario corporativo
    Somers Mounts Hill
    Benenden
    TN17 4ET Cranbrook
    Kent
    60146690007
    VERMAAK, Gerhardus
    13 Mayflower House
    Valetta Way
    ME1 1FA Rochester
    Kent
    Director
    13 Mayflower House
    Valetta Way
    ME1 1FA Rochester
    Kent
    South AfricanBusinessman80269840003
    BELL, Paul Harrison
    Rowan House Stonewall Park Road
    Langton Green
    TN3 0HN Tunbridge Wells
    Kent
    Secretario
    Rowan House Stonewall Park Road
    Langton Green
    TN3 0HN Tunbridge Wells
    Kent
    BritishCompany Director74801170002
    DAVIES, Stephen Raymond
    15 Court Lodge
    Shorne
    DA12 3EQ Gravesend
    Kent
    Secretario
    15 Court Lodge
    Shorne
    DA12 3EQ Gravesend
    Kent
    BritishDirector50734440001
    DRURY, Kenneth Malcolm
    Dairy Farm Cottage
    Sutton Hoo,
    IP12 3DJ Woodbridge
    Suffolk
    Secretario
    Dairy Farm Cottage
    Sutton Hoo,
    IP12 3DJ Woodbridge
    Suffolk
    BritishDirector56761690004
    EVANS, Lyn
    2 Dental Close
    Borden
    ME10 1DT Sittingbourne
    Kent
    Secretario
    2 Dental Close
    Borden
    ME10 1DT Sittingbourne
    Kent
    BritishFinancial Director66828710002
    HERSCH, Benson Selwyn
    60 Grange Gardens
    HA5 5QF Pinner
    Middlesex
    Secretario
    60 Grange Gardens
    HA5 5QF Pinner
    Middlesex
    British6057020001
    LINLEY, Andrew Northam
    9 Briar Fields
    Grove Green
    ME14 5UZ Maidstone
    Kent
    Secretario
    9 Briar Fields
    Grove Green
    ME14 5UZ Maidstone
    Kent
    South African39628820001
    BELL, Paul Harrison
    Rowan House Stonewall Park Road
    Langton Green
    TN3 0HN Tunbridge Wells
    Kent
    Director
    Rowan House Stonewall Park Road
    Langton Green
    TN3 0HN Tunbridge Wells
    Kent
    BritishCompany Director74801170002
    COOK, Peter George
    2 Grove Cottages
    Hogg Lane
    WD6 3AL Elstree
    Middlesex
    Director
    2 Grove Cottages
    Hogg Lane
    WD6 3AL Elstree
    Middlesex
    BritishChartered Accountant36768870001
    DAVIES, Stephen Raymond
    15 Court Lodge
    Shorne
    DA12 3EQ Gravesend
    Kent
    Director
    15 Court Lodge
    Shorne
    DA12 3EQ Gravesend
    Kent
    EnglandBritishDirector50734440001
    DEELEY, Michael David
    33 Copper Tree Court
    Loose
    ME15 9RW Maidstone
    Kent
    Director
    33 Copper Tree Court
    Loose
    ME15 9RW Maidstone
    Kent
    BritishDivisional Managing Director4904280001
    DRURY, Kenneth Malcolm
    Dairy Farm Cottage
    Sutton Hoo,
    IP12 3DJ Woodbridge
    Suffolk
    Director
    Dairy Farm Cottage
    Sutton Hoo,
    IP12 3DJ Woodbridge
    Suffolk
    BritishCo Director56761690004
    DYNE, Ronald Irvin
    6 Marsh Close
    Mill Hill
    NW7 4NY London
    Director
    6 Marsh Close
    Mill Hill
    NW7 4NY London
    BritishChartered Accountant10505810001
    LE ROUX, Allan
    13 Mayflower House
    Valetta Way
    ME1 1FA Rochester
    Kent
    Director
    13 Mayflower House
    Valetta Way
    ME1 1FA Rochester
    Kent
    South AfricanCo Director83399270002
    LINDSAY, Antony Dennis
    26 Jubilee Close
    Cam
    GL11 5JQ Dursley
    Gloucestershire
    Director
    26 Jubilee Close
    Cam
    GL11 5JQ Dursley
    Gloucestershire
    BritishPlant Director31476550001
    LINLEY, Andrew Northam
    9 Briar Fields
    Grove Green
    ME14 5UZ Maidstone
    Kent
    Director
    9 Briar Fields
    Grove Green
    ME14 5UZ Maidstone
    Kent
    South AfricanChartered Accountant39628820001
    MERRITT, Paul Henry
    Green Hedges
    Chambers Green Road Pluckley
    TN27 0RH Ashford
    Kent
    Director
    Green Hedges
    Chambers Green Road Pluckley
    TN27 0RH Ashford
    Kent
    BritishPlant Director86760460001
    NOAKES, Bernard
    24 Petersfield
    Broomfield
    CM1 4EP Chelmsford
    Essex
    Director
    24 Petersfield
    Broomfield
    CM1 4EP Chelmsford
    Essex
    United KingdomBritishSales Marketing Director20377840002
    SCHLOSBERG, Hilton Hiller
    2 Lake Drive
    Hartsbourne Road
    WD2 1QP Bushey Heath
    Hertfordshire
    Director
    2 Lake Drive
    Hartsbourne Road
    WD2 1QP Bushey Heath
    Hertfordshire
    South AfricanExecutive36217260002
    WALLER, John Daniel Arthur
    Berkeley House Berkeley Road
    TN20 6EH Mayfield
    East Sussex
    Director
    Berkeley House Berkeley Road
    TN20 6EH Mayfield
    East Sussex
    BritishPlant Director31476590001

    ¿Tiene FINTRADE TECHNOLOGIES LTD alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 22 jul 2002
    Entregado el 05 ago 2002
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 05 ago 2002Registro de un cargo (395)
    Account charge
    Creado el 06 abr 2001
    Entregado el 18 abr 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All obligations and liabilities of the company and/or aac to the bank as at the date of the charge or thereafter (as from time to time modified, amended, renewed or extended) under the agreement and/or any security document (including the charge) to which the company and/or aac is a party and all other monies, obligations and liabilities of the company and/or aac to the bank howsoever arising (all terms as defined)
    Breve descripción
    With full title guarantee all its right, title and interest in the account and the deposit as a continuing security in favour of the bank for the discharge of the secured obligations.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 18 abr 2001Registro de un cargo (395)
    • 03 ago 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 16 ago 2000
    Entregado el 22 ago 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 22 ago 2000Registro de un cargo (395)
    • 03 ago 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed charge
    Creado el 17 mar 1998
    Entregado el 18 mar 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    1 x efco horizontal conveyorised alloy wheel pre-heating oven serial number 45697 together with the proceeds and products thereof benefit of all policies of insurance warranties guarantees and other contracts in respect of the prope rty. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Royscot Industrial Leasing LTD
    • Royscot Commercial Leasing LTD.
    • Royscot Leasing LTD.
    • Royscot Trust PLC
    • Royscot Spa Leasing Limited
    Transacciones
    • 18 mar 1998Registro de un cargo (395)
    • 03 ago 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 22 ene 1997
    Entregado el 30 ene 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the obligors (as defined) to any beneficiary (as defined) pursuant to the terms of any of the finance documents and/or in connection with any loan facility or other financial accommodation from time to time granted and on any other account whatsoever together with all expenses under the terms of this debenture
    Breve descripción
    .. a specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The British Linen Bank Limited
    Transacciones
    • 30 ene 1997Registro de un cargo (395)
    • 03 ago 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Group cross-guarantee indemnity and debenture
    Creado el 22 ene 1997
    Entregado el 04 feb 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under clause 2 of the deed
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Must Screens Bv
    Transacciones
    • 04 feb 1997Registro de un cargo (395)
    • 03 ago 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creado el 28 feb 1995
    Entregado el 08 mar 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The plant machinery chattels or other equipment of the company as specified in the attached continuation sheets which also contain details of covenants by and restrictions on the company which protect and further define the charge. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The British Linen Bank Limited
    Transacciones
    • 08 mar 1995Registro de un cargo (395)
    • 31 ene 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creado el 28 abr 1994
    Entregado el 05 may 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The plant machinery chattels or other equipment described in the schedule to the deed together with any alterations accessories replacements and renewals from time to time thereto. The benefit of any guarantee warranty or other obligations in relation thereto........ See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The British Linen Bank Limited
    Transacciones
    • 05 may 1994Registro de un cargo (395)
    • 31 ene 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 23 jul 1993
    Entregado el 27 jul 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Meespierson N.V.
    Transacciones
    • 27 jul 1993Registro de un cargo (395)
    • 31 ene 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 23 jul 1993
    Entregado el 26 jul 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The British Linen Bank Limited
    Transacciones
    • 26 jul 1993Registro de un cargo (395)
    • 31 ene 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creado el 23 jul 1993
    Entregado el 24 jul 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The plant machinery and chattels of the company as detailed on form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The British Linen Bank Limited
    Transacciones
    • 24 jul 1993Registro de un cargo (395)
    • 31 ene 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 08 abr 1993
    Entregado el 15 abr 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All that f/h property comprising the former parkfield works lying to the east of cardiff road,taff's well,taff-ely mid glamorgan t/n WA405745.
    Personas con derecho
    • Allied Trust Bank Limited
    Transacciones
    • 15 abr 1993Registro de un cargo (395)
    • 06 feb 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 08 abr 1993
    Entregado el 15 abr 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All that f/h property comprising the mellingriffith works,whitchurch,cardiff,s glamorgan t/n wa 150348.
    Personas con derecho
    • Allied Trust Bank Limited
    Transacciones
    • 15 abr 1993Registro de un cargo (395)
    • 06 feb 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 31 jul 1991
    Entregado el 16 ago 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 12/1/91 and/or a supplemental loan agreement dated 22/7/91 on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land lying to the east of cardiff road, taff's well title no:- wa 405745 together with the entire benefit of all its rights title & inteest in all occupational and/& business leases a tenancies etc. fixed charge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipment (see form 395 for full details).
    Personas con derecho
    • Swiss Bank Corporation
    Transacciones
    • 16 ago 1991Registro de una carga
    • 27 jul 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 31 jul 1991
    Entregado el 16 ago 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 12/1/91 and/or a supplemental loan agreement dated 22/7/91 on any account whatsoever
    Breve descripción
    Property at milingriffith works, whitchurch title no:- wa 150348 together with the entire benefit of all its rights title & interest in all occupational and/or business leases a tenancies etc. fixed charge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipment. (See form 395 for full details).
    Personas con derecho
    • Swiss Bank Corporation PLC
    Transacciones
    • 16 ago 1991Registro de una carga
    • 27 jul 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creado el 12 ene 1991
    Entregado el 24 ene 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    (Including trade fixtures & fittings) (see form 395 for full details and details of the property).. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Swiss Bank Corporation
    Transacciones
    • 24 ene 1991Registro de una carga
    • 27 jul 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene FINTRADE TECHNOLOGIES LTD algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    10 dic 2004Fin de la administración
    11 dic 2003Inicio de la administración
    En administración
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Antony David Nygate
    Bdo Stoy Hayward
    8 Baker Street
    London
    W1u 3ll
    Profesional
    Bdo Stoy Hayward
    8 Baker Street
    London
    W1u 3ll
    James Joseph Bannon
    Bdo Stoy Hayward Llp
    8 Baker Street
    W1U 3LL London
    Profesional
    Bdo Stoy Hayward Llp
    8 Baker Street
    W1U 3LL London
    1
    FechaTipo
    10 dic 2004Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de acreedores
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    2
    FechaTipo
    05 ago 2010Fecha de disolución
    12 dic 2005Fecha de la petición
    05 ago 2008Conclusión de la liquidación
    08 mar 2006Inicio de la liquidación
    Liquidación forzosa
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    The Official Receiver Or London
    21 Bloomsbury Street
    London
    WC1B 3SS
    Profesional
    21 Bloomsbury Street
    London
    WC1B 3SS

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0