COAL PENSION (SECURITIES) NOMINEES LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | COAL PENSION (SECURITIES) NOMINEES LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Activa |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social |
Número de empresa | 02553780 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | No |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de COAL PENSION (SECURITIES) NOMINEES LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra COAL PENSION (SECURITIES) NOMINEES LIMITED?
Dirección de la sede social | Ventana House 2 Concourse Way Sheaf Street S1 2BJ Sheffield |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de COAL PENSION (SECURITIES) NOMINEES LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
COAL PENSIONS (SECURITIES) NOMINEES LIMITED | 29 ago 1996 | 29 ago 1996 |
GLOBE VENTURE NOMINEES LIMITED | 03 dic 1990 | 03 dic 1990 |
URBANTASK LIMITED | 31 oct 1990 | 31 oct 1990 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de COAL PENSION (SECURITIES) NOMINEES LIMITED?
Vencido | No |
---|---|
Próximas cuentas | |
Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2024 |
Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2025 |
Últimas cuentas | |
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2023 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para COAL PENSION (SECURITIES) NOMINEES LIMITED?
Última declaración de confirmación cerrada hasta | 01 sept 2025 |
---|---|
Próxima declaración de confirmación vence | 15 sept 2025 |
Última declaración de confirmación | |
Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 01 sept 2024 |
Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para COAL PENSION (SECURITIES) NOMINEES LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Cambio de datos del director Mr Mark Andrew Walker el 16 abr 2025 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del director Mrs Janka Unsworth Deckerova el 16 abr 2025 | 2 páginas | CH01 | ||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 dic 2023 | 3 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 01 sept 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 dic 2022 | 3 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 01 sept 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Daniel John Whincup como director el 21 sept 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Geoffrey Mellor como director el 21 sept 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 dic 2021 | 3 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 01 sept 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 dic 2020 | 3 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 01 sept 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 dic 2019 | 3 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 01 sept 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 dic 2018 | 2 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 01 sept 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 dic 2017 | 2 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 01 sept 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mr Mark Andrew Walker como director el 17 ene 2018 | 2 páginas | AP01 | ||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 dic 2016 | 2 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 01 sept 2017 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Stefan Dunatov como director el 11 abr 2017 | 1 páginas | TM01 | ||
Cambio de datos del director Mr Daniel John Whincup-Young el 17 ene 2017 | 2 páginas | CH01 | ||
Nombramiento de Mrs Janka Unsworth Deckerova como director el 01 ene 2017 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr Daniel John Whincup-Young como director el 01 ene 2017 | 2 páginas | AP01 | ||
¿Quiénes son los directivos de COAL PENSION (SECURITIES) NOMINEES LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNSWORTH DECKEROVA, Janka | Director | 2 Concourse Way Sheaf Street S1 2BJ Sheffield Ventana House | United Kingdom | Slovak | Director | 221684660001 | ||||
WALKER, Mark Andrew | Director | 2 Concourse Way Sheaf Street S1 2BJ Sheffield Ventana House | United Kingdom | British | Director | 242131380001 | ||||
ASHTON, Christopher John Robert | Secretario | 2 Jowitt Road S11 9FJ Sheffield South Yorkshire | British | Accountant | 80069450001 | |||||
BURGESS, Mark Geoffrey William | Secretario | 5 Glenmore House Richmond Hill TW10 6BQ Richmond Surrey | British | Chartered Accountant | 28476620004 | |||||
HARRIS, Peter Malcolm | Secretario | 43 Lyons Crescent TN9 1EY Tonbridge Kent | British | 50673480002 | ||||||
HENSMAN, Michael John | Secretario | 49 Sandstone Avenue S9 1AJ Sheffield South Yorkshire | British | Accountant | 77960500001 | |||||
IRVINE, Frederick Malcolm | Secretario | Stonewold 49 Heathhurst Road Sanderstead CR2 0BB South Croydon Surrey | British | Chartered Accountant | 2021450001 | |||||
LEVINGS, Alan Clifford | Secretario | 8 Rookswood Close RG27 9EU Hook Hampshire | British | 123716400001 | ||||||
STORER, Jonathan Michael | Secretario | 2 Concourse Way Sheaf Street S1 2BJ Sheffield Ventana House United Kingdom | 161485380001 | |||||||
WHALE, Kevin John | Secretario | 37 Dawson Road KT1 3AU Kingston Upon Thames Surrey | British | 46925320001 | ||||||
BARNES, Joseph | Director | 37 Howden Close DN4 7JN Doncaster South Yorkshire | British | Director | 56869920001 | |||||
BEEVOR, David Nigel | Director | 44 Stevenage Road SW6 6HA London | British | Finance Director | 13934140001 | |||||
BENNETT, Guy Patrick De Courcy | Director | 20 Hendham Road SW17 7DQ London | British | Investment Manager | 19144530002 | |||||
BROWN, John Forster | Director | 7 Hurst Avenue N6 5TX London | United Kingdom | British | Investment Manager | 4183480002 | ||||
BRUCE, George Alexander | Director | 85 Den Bank Drive S10 5PF Sheffield South Yorkshire | United Kingdom | British | Finance Dir | 45343180001 | ||||
BURGESS, Mark Geoffrey William | Director | 5 Glenmore House Richmond Hill TW10 6BQ Richmond Surrey | British | Chartered Accountant | 28476620004 | |||||
CLARKE, Jonathan George Gough | Director | Westland Farm Ockley Road GU6 7SL Ewhurst Surrey | British | Investment Manager | 72712910001 | |||||
DAVISON, Guy Bryce | Director | 128 Kensington Park Road W1 2EP London | British | Investment Manager | 48717030002 | |||||
DI MASCIO, Riccardo | Director | 19 Grimwade Avenue CR0 5DJ Croydon | United Kingdom | British | Managing Director | 43353350001 | ||||
DINNING, William Robert John | Director | 2 Concourse Way Sheaf Street S1 2BJ Sheffield Ventana House United Kingdom | United Kingdom | British | Investment | 73659590001 | ||||
DUNATOV, Stefan | Director | 2 Concourse Way Sheaf Street S1 2BJ Sheffield Ventana House United Kingdom | Great Britain | New Zealand | Chief Investment Officer | 168204920001 | ||||
HALL, Robin Alexander | Director | Amberley House Roding Lane IG7 6BE Chigwell Essex | British | Managing Director | 35549940001 | |||||
HARRIS, Peter Malcolm | Director | 43 Lyons Crescent TN9 1EY Tonbridge Kent | British | Accountant | 50673480002 | |||||
HENSMAN, Michael John | Director | 49 Sandstone Avenue S9 1AJ Sheffield South Yorkshire | England | British | Finance Management | 77960500001 | ||||
IRVINE, Frederick Malcolm | Director | Stonewold 49 Heathhurst Road Sanderstead CR2 0BB South Croydon Surrey | British | Chartered Accountant | 2021450001 | |||||
JOY, Andrew Neville | Director | Marelands GU10 5JB Bentley Hampshire | England | British | Investment Manager | 44663290001 | ||||
KENISTON-COOPER, Graham James | Director | 17 Ovington Square SW3 1LH London | England | British | Investment Manager | 73698890002 | ||||
LANE, Gerard Christopher | Director | 2 Concourse Way Sheaf Street S1 2BJ Sheffield Ventana House United Kingdom | England | British | Chief Operating Officer | 61572180001 | ||||
LANGMUIR, Hugh Macgillivray | Director | 14 Ashchurch Park Villas W12 9SP London | British | Investment Manager | 42365820001 | |||||
LINDEN, Brian Andrew | Director | 7 Westmoreland Road Barnes SW13 9RZ London | United Kingdom | British | Investment Manager | 36233000002 | ||||
MARCHANT, Andrew William | Director | Pitch Place Farm Thursley GU8 6QW Godalming Surrey | British | Investment Manager | 10380660001 | |||||
MASKELL, Philip John | Director | 1 Grange Cottages Broad Common Road RG10 0RD Hurst Berkshire | British | Investment Manager | 5733160002 | |||||
MELLOR, Geoffrey | Director | 2 Concourse Way Sheaf Street S1 2BJ Sheffield Ventana House United Kingdom | United Kingdom | British | Chief Executive | 122094870001 | ||||
MORGAN, David George | Director | Coldwell House Coldwell Hill Oughtibridge S35 0FY Sheffield | British | Chief Executive | 11606590003 | |||||
MUNTON, Richard James | Director | The Forge Hamptons TN11 9RE Tonbridge Kent | British | Investment Manager | 11882410003 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de COAL PENSION (SECURITIES) NOMINEES LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trustees Of The Mineworkers' Pension Scheme Limited | 06 abr 2016 | Concourse Way S1 2BJ Sheffield Ventana House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Coal Staff Superannuation Scheme Trustees Limited | 06 abr 2016 | 2 Concourse Way Sheaf Street S1 2BJ Sheffield Ventana House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0