REDWOOD BOOKS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaREDWOOD BOOKS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02558633
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de REDWOOD BOOKS LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra REDWOOD BOOKS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    8 Springfield Close
    Ovington
    NE42 6WZ Prudhoe
    Northumberland
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de REDWOOD BOOKS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    DOTESIOS LIMITED07 ene 199107 ene 1991
    UNITEQUAL LIMITED15 nov 199015 nov 1990

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de REDWOOD BOOKS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2013

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para REDWOOD BOOKS LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para REDWOOD BOOKS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Domicilio social registrado cambiado de * Cox & Wyman House Cardiff Road Reading Berks RG1 8EX* el 13 mar 2014

    1 páginasAD01

    Déclaration annuelle établie au 29 sept 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital12 nov 2013

    Estado de capital el 12 nov 2013

    • Capital: GBP 50,000
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2013

    3 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 29 sept 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2012

    3 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 29 sept 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2011

    3 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 29 sept 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cese del nombramiento de Jonathan Owen como secretario

    1 páginasTM02

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2010

    11 páginasAA

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2009

    10 páginasAA

    Resoluciones

    Resolutions
    22 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución del Memorándum de Asociación

    RES01

    Declaración de los objetos de la sociedad

    2 páginasCC04

    legacy

    4 páginas363a

    legacy

    1 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    4 páginas363a

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2008

    3 páginasAA

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2007

    3 páginasAA

    legacy

    2 páginas363a

    ¿Quiénes son los directivos de REDWOOD BOOKS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    ROBSON, Matthew William
    Reivers
    Springfield Close
    NE42 6EL Ovington
    Northumberland
    Secretario
    Reivers
    Springfield Close
    NE42 6EL Ovington
    Northumberland
    BritishBarrister93423100001
    ROBSON, Matthew William
    Reivers
    Springfield Close
    NE42 6EL Ovington
    Northumberland
    Director
    Reivers
    Springfield Close
    NE42 6EL Ovington
    Northumberland
    EnglandBritishBarrister93423100001
    CARLOT, Michel
    14 Bis Rue De La Voute
    Paris
    FOREIGN 75012
    France
    Secretario
    14 Bis Rue De La Voute
    Paris
    FOREIGN 75012
    France
    FrenchGeneral Counsel68149410001
    FISHER, Anthony David
    Highclere House
    Woods Hill Limpley Stoke
    BA3 6HZ Bath
    Secretario
    Highclere House
    Woods Hill Limpley Stoke
    BA3 6HZ Bath
    British1426470001
    LOUSSIER, Julien
    59 Rue Jouffroy D'Abbans
    FOREIGN 75017 Paris
    France
    Secretario
    59 Rue Jouffroy D'Abbans
    FOREIGN 75017 Paris
    France
    FrenchFinancial Director89031330001
    MARRIOTT DODINGTON, Spencer
    6 Falconer Road
    BA1 4NH Bath
    Banes
    Secretario
    6 Falconer Road
    BA1 4NH Bath
    Banes
    British84700710001
    OWEN, Jonathan Spencer
    42 Woodland Avenue
    BN3 6BL Hove
    East Sussex
    Secretario
    42 Woodland Avenue
    BN3 6BL Hove
    East Sussex
    BritishAccountant92040070002
    BATESON, Kenneth
    Uplands
    Innox Hill Gardens
    BA11 2LN Frome
    Somerset
    Director
    Uplands
    Innox Hill Gardens
    BA11 2LN Frome
    Somerset
    BritishCompany Director - Printer51755890001
    BOVARD, Timothy Landon
    7 Boulevard Anatole France
    FOREIGN Boulogne
    92100
    France
    Director
    7 Boulevard Anatole France
    FOREIGN Boulogne
    92100
    France
    BritishCompany Director101457350001
    CARLOT, Michel
    14 Bis Rue De La Voute
    Paris
    FOREIGN 75012
    France
    Director
    14 Bis Rue De La Voute
    Paris
    FOREIGN 75012
    France
    FrenchGeneral Counsel68149410001
    CLARK, Peter Richard
    Brookfield House
    The Ley
    SN13 8EW Box
    Wiltshire
    Director
    Brookfield House
    The Ley
    SN13 8EW Box
    Wiltshire
    BritishDirector73089270001
    DE BARDIES, Thierry
    8 Rue Du Belvedere
    92100 Boulogne
    FOREIGN Paris
    France
    Director
    8 Rue Du Belvedere
    92100 Boulogne
    FOREIGN Paris
    France
    FrenchCompany Director68371900001
    FISHER, Anthony David
    Highclere House
    Woods Hill Limpley Stoke
    BA3 6HZ Bath
    Director
    Highclere House
    Woods Hill Limpley Stoke
    BA3 6HZ Bath
    BritishCompany Chairman/Director - Accountant1426470001
    GEE, Trevor Michael
    28 Patney Road
    Chirton
    SN12 3QT Devizes
    Wiltshire
    Director
    28 Patney Road
    Chirton
    SN12 3QT Devizes
    Wiltshire
    BritishCompany Director38276640001
    HILL, Robert
    The Glebe House
    Stanton Drew
    BS18 4EH Bristol
    Avon
    Director
    The Glebe House
    Stanton Drew
    BS18 4EH Bristol
    Avon
    BritishCompany Director - Printer1105640001
    JOHNSON, Keith Howard
    14 Beach House Gardens
    SS8 7DX Canvey Island
    Essex
    Director
    14 Beach House Gardens
    SS8 7DX Canvey Island
    Essex
    BritishSheet Sales Director31229550001
    KIRKLAND, Keith Hedley
    Cymberline 51 The Borough
    Downton
    SP5 3LX Salisbury
    Wiltshire
    Director
    Cymberline 51 The Borough
    Downton
    SP5 3LX Salisbury
    Wiltshire
    BritishSales Director72727820001
    LEACH, Peter Charles
    10 Frome Road
    BA15 1LB Bradford On Avon
    Wiltshire
    Director
    10 Frome Road
    BA15 1LB Bradford On Avon
    Wiltshire
    United KingdomBritishCompany Director38276620002
    LOUSSIER, Julien
    59 Rue Jouffroy D'Abbans
    FOREIGN 75017 Paris
    France
    Director
    59 Rue Jouffroy D'Abbans
    FOREIGN 75017 Paris
    France
    FrenchFinancial Director89031330001
    MARRIOTT DODINGTON, Spencer
    6 Falconer Road
    BA1 4NH Bath
    Banes
    Director
    6 Falconer Road
    BA1 4NH Bath
    Banes
    BritishGroup Finance Dir84700710001
    OWEN, Jonathan Spencer
    42 Woodland Avenue
    BN3 6BL Hove
    East Sussex
    Director
    42 Woodland Avenue
    BN3 6BL Hove
    East Sussex
    BritishChartered Accountant92040070002
    PALFRAMAN, Peter
    Larchwood
    Claverton Down Road
    BA2 7AE Bath
    Avon
    Director
    Larchwood
    Claverton Down Road
    BA2 7AE Bath
    Avon
    United KingdomBritishCompany Director46419220001
    VINCENT, Peter Michael Christopher
    31 Newtown
    BA15 1NF Bradford On Avon
    Wiltshire
    Director
    31 Newtown
    BA15 1NF Bradford On Avon
    Wiltshire
    BritishManaging Director - Printing Company18177680001
    WHITE, Christopher Duncan
    1 Copley Court
    Hanham
    BS15 3SH Bristol
    South Gloucestershire
    Director
    1 Copley Court
    Hanham
    BS15 3SH Bristol
    South Gloucestershire
    EnglandBritishAccountant73695700001
    WILLIS, Richard William
    36 Southstoke Road
    Combe Down
    BA2 5SN Bath
    Avon
    Director
    36 Southstoke Road
    Combe Down
    BA2 5SN Bath
    Avon
    BritishCompany Director/Accountant5602390002

    ¿Tiene REDWOOD BOOKS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Book debts debenture
    Creado el 29 sept 1995
    Entregado el 30 sept 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All the book debts and other debts of the company both present and future.
    Personas con derecho
    • Tsb Commercial Finance Limited
    Transacciones
    • 30 sept 1995Registro de un cargo (395)
    • 19 ago 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed charge supplemental to a debenture
    Creado el 06 ago 1993
    Entregado el 20 ago 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of the debenture
    Breve descripción
    All right, title and interest of the company in or arising out of a factoring or invoice discounting deed dated 9TH july 1991. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 20 ago 1993Registro de un cargo (395)
    • 08 feb 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 06 jul 1993
    Entregado el 21 jul 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 21 jul 1993Registro de un cargo (395)
    • 08 feb 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 09 sept 1991
    Entregado el 13 sept 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All of the company's stock of raw and finished paper card and allied products. All the company's work in progress wherever situated including all completed incompleted and partially completed printed books journals magazines pamplhlets catalogues newspapers manuals brochures or any other printed materials or publications whatsoever.
    Personas con derecho
    • Credit Lyannais
    Transacciones
    • 13 sept 1991Registro de una carga
    • 17 jul 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0