MATRIX (HIGHLANDS) LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | MATRIX (HIGHLANDS) LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02558700 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de MATRIX (HIGHLANDS) LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra MATRIX (HIGHLANDS) LIMITED?
| Dirección de la sede social | Gladstone Place 36-38 Upper Marlborough Road AL1 3UU St. Albans Hertfordshire England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de MATRIX (HIGHLANDS) LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| TRAVELBASIC LIMITED | 15 nov 1990 | 15 nov 1990 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de MATRIX (HIGHLANDS) LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2019 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para MATRIX (HIGHLANDS) LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||||||
Estado de capital el 12 feb 2021
| 3 páginas | SH19 | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 15 nov 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 31 dic 2019 | 20 páginas | AA | ||||||||||||||
legacy | 79 páginas | PARENT_ACC | ||||||||||||||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE2 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | AGREEMENT2 | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 15 nov 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 31 dic 2018 | 20 páginas | AA | ||||||||||||||
legacy | 64 páginas | PARENT_ACC | ||||||||||||||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE2 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | AGREEMENT2 | ||||||||||||||
Modification des détails de Malthurst Petroleum Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 16 jul 2019 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||||||
Nombramiento de Thomas Mckenzie Biggart como director el 11 mar 2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Pinsent Masons Secretarial Limited como secretario el 07 mar 2019 | 2 páginas | AP04 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de David Hathaway como secretario el 07 mar 2019 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Graham Paul Timbers como director el 12 feb 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Simon Paul Lane como director el 19 dic 2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr William Bahlsen Bannister como director el 19 dic 2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Vincent House 4 Grove Lane Epping Essex CM16 4LH a Gladstone Place 36-38 Upper Marlborough Road St. Albans Hertfordshire AL1 3UU el 21 dic 2018 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de MATRIX (HIGHLANDS) LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED | Secretario corporativo | Park Row LS1 5AB Leeds 1 England |
| 76579530001 | ||||||||||
| BANNISTER, William Bahlsen | Director | 36-38 Upper Marlborough Road AL1 3UU St. Albans Gladstone Place Hertfordshire England | United Kingdom | British | 252731900001 | |||||||||
| BIGGART, Thomas Mckenzie | Director | 36-38 Upper Marlborough Road AL1 3UU St. Albans Gladstone Place Hertfordshire England | Scotland | British | 215843640001 | |||||||||
| LANE, Simon Paul | Director | 36-38 Upper Marlborough Road AL1 3UU St. Albans Gladstone Place Hertfordshire England | England | British | 252862090001 | |||||||||
| HATHAWAY, David | Secretario | 36-38 Upper Marlborough Road AL1 3UU St. Albans Gladstone Place Hertfordshire England | 173702820001 | |||||||||||
| IQBAL, Damian Shameem | Secretario | 4 Grove Lane CM16 4LH Epping Vincent House Essex England | 173703080001 | |||||||||||
| KERRIDGE, Nicola Jane | Secretario | Melway House Child Okeford DT11 8EW Blandford Forum Dorset | British | 20367220003 | ||||||||||
| BACK, Steven John | Director | 4 Grove Lane CM16 4LH Epping Vincent House Essex | United Kingdom | British | 205661380001 | |||||||||
| DICKENS, Karen Juanita, Dr | Director | 4 Grove Lane CM16 4LH Epping Vincent House Essex | United Kingdom | British | 124061360001 | |||||||||
| GRAY, Michael Stuart | Director | Slackbuie Way IV2 6AT Inverness 16 Inverness-Shire United Kingdom | United Kingdom | British | 82067270002 | |||||||||
| KERRIDGE, Mark William | Director | Melway House Child Okeford DT11 8EW Blandford Forum Dorset | United Kingdom | British | 9965070004 | |||||||||
| KERRIDGE, Nicola Jane | Director | Melway House Child Okeford DT11 8EW Blandford Forum Dorset | United Kingdom | British | 20367220003 | |||||||||
| KERRIDGE, William Nicholas | Director | Prowtings Chawton GU34 1SD Alton Hampshire | United Kingdom | British | 9299940001 | |||||||||
| LYNN, John Charles | Director | 4 Grove Lane CM16 4LH Epping Vincent House Essex England | United Kingdom | British | 29838790004 | |||||||||
| PEACOCK, Graham Frederick | Director | 4 Grove Lane CM16 4LH Epping Vincent House Essex England | United Kingdom | British | 5133310002 | |||||||||
| SCOTT, Richard Antony Cargill | Director | 4 Grove Lane CM16 4LH Epping Vincent House Essex England | England | British | 107002130001 | |||||||||
| TIMBERS, Graham Paul | Director | 36-38 Upper Marlborough Road AL1 3UU St. Albans Gladstone Place Hertfordshire England | England | British | 127888240001 | |||||||||
| TOBBELL, Susan Margaret | Director | 4 Grove Lane CM16 4LH Epping Vincent House Essex England | United Kingdom | British | 17957620003 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de MATRIX (HIGHLANDS) LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malthurst Petroleum Limited | 06 abr 2016 | 36-38 Upper Marlborough Road AL1 3UU St Albans Gladstone Place Hertfordshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene MATRIX (HIGHLANDS) LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creado el 20 ago 2015 Entregado el 25 ago 2015 | Satisfecho en su totalidad | ||
La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 10 dic 2009 Entregado el 15 dic 2009 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security | Creado el 30 nov 2009 Entregado el 02 feb 2010 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción All and whole the subjects k/a and forming that area of ground at mintlaw service station south street mintlaw aberdeen comprising first:- (first) (one) all and whole that piece of ground lying in the village and lands and estate of mintlaw in the parish of longside and county of aberdeen, being the area of ground more particularly described in and shown delinated and coloured pink on the plan annexed (two) all and whole that lot of area of ground situated in the square in the village of mintlaw in the parish of longside and county of aberdeen see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security which was presented for registration in scotland on 8 january 2007 and | Creado el 03 ene 2007 Entregado el 24 ene 2007 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Pitlochry service station perth road pitlochry. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security which was presented for registration in scotland on 20TH september 2000 and | Creado el 31 ago 2000 Entregado el 28 sept 2000 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Breve descripción That area of ground extending to 91 poles 24 square yards or thereby lying in the former burgh of forres and county of moray together with the whole buildings and other erections thereon; all fittings fixtures therein and all right,title and interest thereon. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security | Creado el 02 oct 1992 Entregado el 16 oct 1992 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee in terms of a minute of agreement dated 1ST and 22ND july 1992 and any future agreement. | |
Breve descripción All and whole the dominium utile and dominium directum of all and whole that piece of ground lying in the village and lands and estate of mintlaw in the parish of longside and county of aberdeen. For full details please see doc M385C. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security | Creado el 19 jun 1991 Entregado el 27 jun 1991 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £91800 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the guarantee by F.W.kerridge limited in respect of the obligations of the company | |
Breve descripción All and whole that area of ground extending to ninety one poles, twenty four square yards of thereby imperial standard measure lying in the former burgh of forres and county of moray see form 395 for details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0