MATRIX (HIGHLANDS) LIMITED

MATRIX (HIGHLANDS) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaMATRIX (HIGHLANDS) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02558700
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de MATRIX (HIGHLANDS) LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra MATRIX (HIGHLANDS) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Gladstone Place
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Hertfordshire
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de MATRIX (HIGHLANDS) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    TRAVELBASIC LIMITED15 nov 199015 nov 1990

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de MATRIX (HIGHLANDS) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2019

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para MATRIX (HIGHLANDS) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Estado de capital el 12 feb 2021

    • Capital: GBP 1
    3 páginasSH19

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Share premium account cancelled 26/01/2021
    RES13
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Declaración de confirmación presentada el 15 nov 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 31 dic 2019

    20 páginasAA

    legacy

    79 páginasPARENT_ACC

    legacy

    3 páginasGUARANTEE2

    legacy

    1 páginasAGREEMENT2

    Declaración de confirmación presentada el 15 nov 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 31 dic 2018

    20 páginasAA

    legacy

    64 páginasPARENT_ACC

    legacy

    3 páginasGUARANTEE2

    legacy

    1 páginasAGREEMENT2

    Modification des détails de Malthurst Petroleum Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 16 jul 2019

    2 páginasPSC05

    Nombramiento de Thomas Mckenzie Biggart como director el 11 mar 2019

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Pinsent Masons Secretarial Limited como secretario el 07 mar 2019

    2 páginasAP04

    Cese del nombramiento de David Hathaway como secretario el 07 mar 2019

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Graham Paul Timbers como director el 12 feb 2019

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Simon Paul Lane como director el 19 dic 2018

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr William Bahlsen Bannister como director el 19 dic 2018

    2 páginasAP01

    Domicilio social registrado cambiado de Vincent House 4 Grove Lane Epping Essex CM16 4LH a Gladstone Place 36-38 Upper Marlborough Road St. Albans Hertfordshire AL1 3UU el 21 dic 2018

    1 páginasAD01

    ¿Quiénes son los directivos de MATRIX (HIGHLANDS) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    England
    Secretario corporativo
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    England
    Tipo de identificaciónSociedad limitada del Reino Unido
    Número de registro02318923
    76579530001
    BANNISTER, William Bahlsen
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    England
    Director
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    England
    United KingdomBritish252731900001
    BIGGART, Thomas Mckenzie
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    England
    Director
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    England
    ScotlandBritish215843640001
    LANE, Simon Paul
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    England
    Director
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritish252862090001
    HATHAWAY, David
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    England
    Secretario
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    England
    173702820001
    IQBAL, Damian Shameem
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Vincent House
    Essex
    England
    Secretario
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Vincent House
    Essex
    England
    173703080001
    KERRIDGE, Nicola Jane
    Melway House
    Child Okeford
    DT11 8EW Blandford Forum
    Dorset
    Secretario
    Melway House
    Child Okeford
    DT11 8EW Blandford Forum
    Dorset
    British20367220003
    BACK, Steven John
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Vincent House
    Essex
    Director
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Vincent House
    Essex
    United KingdomBritish205661380001
    DICKENS, Karen Juanita, Dr
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Vincent House
    Essex
    Director
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Vincent House
    Essex
    United KingdomBritish124061360001
    GRAY, Michael Stuart
    Slackbuie Way
    IV2 6AT Inverness
    16
    Inverness-Shire
    United Kingdom
    Director
    Slackbuie Way
    IV2 6AT Inverness
    16
    Inverness-Shire
    United Kingdom
    United KingdomBritish82067270002
    KERRIDGE, Mark William
    Melway House
    Child Okeford
    DT11 8EW Blandford Forum
    Dorset
    Director
    Melway House
    Child Okeford
    DT11 8EW Blandford Forum
    Dorset
    United KingdomBritish9965070004
    KERRIDGE, Nicola Jane
    Melway House
    Child Okeford
    DT11 8EW Blandford Forum
    Dorset
    Director
    Melway House
    Child Okeford
    DT11 8EW Blandford Forum
    Dorset
    United KingdomBritish20367220003
    KERRIDGE, William Nicholas
    Prowtings
    Chawton
    GU34 1SD Alton
    Hampshire
    Director
    Prowtings
    Chawton
    GU34 1SD Alton
    Hampshire
    United KingdomBritish9299940001
    LYNN, John Charles
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Vincent House
    Essex
    England
    Director
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Vincent House
    Essex
    England
    United KingdomBritish29838790004
    PEACOCK, Graham Frederick
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Vincent House
    Essex
    England
    Director
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Vincent House
    Essex
    England
    United KingdomBritish5133310002
    SCOTT, Richard Antony Cargill
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Vincent House
    Essex
    England
    Director
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Vincent House
    Essex
    England
    EnglandBritish107002130001
    TIMBERS, Graham Paul
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    England
    Director
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritish127888240001
    TOBBELL, Susan Margaret
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Vincent House
    Essex
    England
    Director
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Vincent House
    Essex
    England
    United KingdomBritish17957620003

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de MATRIX (HIGHLANDS) LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Malthurst Petroleum Limited
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    United Kingdom
    06 abr 2016
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroEngland And Wales
    Número de registro00762360
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.

    ¿Tiene MATRIX (HIGHLANDS) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 20 ago 2015
    Entregado el 25 ago 2015
    Satisfecho en su totalidad
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Agent
    Transacciones
    • 25 ago 2015Registro de una carga (MR01)
    • 06 mar 2017Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 10 dic 2009
    Entregado el 15 dic 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 15 dic 2009Registro de un cargo (MG01)
    • 06 mar 2017Satisfacción de una carga (MR04)
    Standard security
    Creado el 30 nov 2009
    Entregado el 02 feb 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All and whole the subjects k/a and forming that area of ground at mintlaw service station south street mintlaw aberdeen comprising first:- (first) (one) all and whole that piece of ground lying in the village and lands and estate of mintlaw in the parish of longside and county of aberdeen, being the area of ground more particularly described in and shown delinated and coloured pink on the plan annexed (two) all and whole that lot of area of ground situated in the square in the village of mintlaw in the parish of longside and county of aberdeen see image for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 02 feb 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 20 ago 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 8 january 2007 and
    Creado el 03 ene 2007
    Entregado el 24 ene 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Pitlochry service station perth road pitlochry.
    Personas con derecho
    • Bp Oil UK Limited
    Transacciones
    • 24 ene 2007Registro de un cargo (395)
    • 20 ago 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 20TH september 2000 and
    Creado el 31 ago 2000
    Entregado el 28 sept 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    That area of ground extending to 91 poles 24 square yards or thereby lying in the former burgh of forres and county of moray together with the whole buildings and other erections thereon; all fittings fixtures therein and all right,title and interest thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Girobank PLC
    Transacciones
    • 28 sept 2000Registro de un cargo (395)
    • 21 ene 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Standard security
    Creado el 02 oct 1992
    Entregado el 16 oct 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee in terms of a minute of agreement dated 1ST and 22ND july 1992 and any future agreement.
    Breve descripción
    All and whole the dominium utile and dominium directum of all and whole that piece of ground lying in the village and lands and estate of mintlaw in the parish of longside and county of aberdeen. For full details please see doc M385C.
    Personas con derecho
    • Bp Oil UK Limited
    Transacciones
    • 16 oct 1992Registro de un cargo (395)
    • 20 ago 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Standard security
    Creado el 19 jun 1991
    Entregado el 27 jun 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £91800 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the guarantee by F.W.kerridge limited in respect of the obligations of the company
    Breve descripción
    All and whole that area of ground extending to ninety one poles, twenty four square yards of thereby imperial standard measure lying in the former burgh of forres and county of moray see form 395 for details.
    Personas con derecho
    • Texaco Limited
    Transacciones
    • 27 jun 1991Registro de una carga
    • 15 jun 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0