TAUNTON CIDER
Visión general
| Nombre de la empresa | TAUNTON CIDER |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad privada sin límite de capital |
| Número de empresa | 02560211 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de TAUNTON CIDER?
- Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra TAUNTON CIDER?
| Dirección de la sede social | Constellation House The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR Artington Guildford Surrey |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de TAUNTON CIDER?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| TAUNTON BRANDS LIMITED | 14 jun 1991 | 14 jun 1991 |
| GRAVITAS 1001 LIMITED | 20 nov 1990 | 20 nov 1990 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de TAUNTON CIDER?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 28 feb 2011 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para TAUNTON CIDER?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 nov 2012 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 nov 2011 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 28 feb 2011 | 12 páginas | AA | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Mr Ronald Charles Fondiller el 27 jun 2011 | 2 páginas | CH03 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Perry Richard Humphrey el 27 jun 2011 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Barbara Joy Laverdi el 27 jun 2011 | 2 páginas | CH03 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr David Eric Klein el 27 jun 2011 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Deepak Malhotra como secretario | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nombramiento de Mr David Eric Klein como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Perry Richard Humphrey como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Troy Christensen como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Francis Hetterich como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Barbara Joy Laverdi como secretario | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Ronald Charles Fondiller como secretario | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
legacy | 3 páginas | MG02 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 nov 2010 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Helen Glennie como secretario | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 28 feb 2010 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Troy Christensen el 11 jun 2010 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Francis Paul Hetterich como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mrs Helen Margaret Glennie como secretario | 1 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Helen Glennie como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de TAUNTON CIDER?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FONDILLER, Ronald Charles | Secretario | The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR Guildford Accolade House Surrey United Kingdom | 159704710001 | |||||||
| LAVERDI, Barbara Joy | Secretario | The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR Guildford Accolade House Surrey United Kingdom | 159704720001 | |||||||
| HUMPHREY, Perry Richard | Director | The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR Guildford Accolade House Surrey United Kingdom | United States | American | 159704890001 | |||||
| KLEIN, David Eric | Director | The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR Guildford Accolade House Surrey United Kingdom | United States | American | 153569440001 | |||||
| COLQUHOUN, Anne Therese | Secretario | Apartment B Kings Ride House Prince Albert Drive SL5 8AQ Ascot | British | 28396500005 | ||||||
| GIBBS, Brian | Secretario | Furlongs 4 Killams Green TA1 3YQ Taunton Somerset | British | 10630840002 | ||||||
| GLENNIE, Helen Margaret | Secretario | Constellation House The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR Artington Guildford Surrey | 149568800001 | |||||||
| MALHOTRA, Deepak Kumar | Secretario | Constellation House The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR Artington Guildford Surrey | British | 69554640002 | ||||||
| ADAMS, Peter George | Director | Lower Northcott Farm Sheldon EX15 2JF Cullompton Devon | British | 112143030001 | ||||||
| BOASE, Martin | Director | 27 St Leonards Terrace SW3 4QG London | United Kingdom | British | 1460150003 | |||||
| CARSON, Christopher | Director | White Gates 11 Oxshott Way KT11 2RU Cobham Surrey | British | 26602290003 | ||||||
| CHRISTENSEN, Troy | Director | Constellation House The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR Artington Guildford Surrey | Australia | American | 130789730002 | |||||
| COLQUHOUN, Anne Therese | Director | Apartment B Kings Ride House Prince Albert Drive SL5 8AQ Ascot | United Kingdom | British | 28396500005 | |||||
| COTTRELL, Michael Noel Francis | Director | Laurenden Forstal Challock Lees TN25 4AU Ashford Kent | British | 16762950001 | ||||||
| CREIGHTON, Thomas Hugh | Director | Apple Acre High Road CR5 3QR Chipstead Surrey | England | British | 157727790001 | |||||
| DAVIS, Peter John | Director | 9 Christchurch Street SW3 4AN London | British | 988330001 | ||||||
| ETHERIDGE, Hugh Charles | Director | 5 Springfield Place BA1 5RA Bath Avon | United Kingdom | British | 1491130002 | |||||
| FOTHERGILL, David | Director | Woodfordes Stoke St Mary TA3 5BY Taunton Somerset | British | 35902810001 | ||||||
| GARNER, Michael Frederick | Director | Old Drews Knotty Green HP9 2TT Beaconsfield Buckinghamshire | United Kingdom | British | 17481250001 | |||||
| GLENNIE, Helen Margaret | Director | Constellation House The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR Artington Guildford Surrey | United Kingdom | British | 137615160001 | |||||
| GOUGH, Jeremy David Erle | Director | 15 Burstock Road SW15 2PW London | British | 62545050001 | ||||||
| HETTERICH, Francis Paul | Director | The Guildway, Old Portsmouth Road Artington GU3 1LR Guildford Constellation House Surrey United Kingdom | United States | American | 147054340001 | |||||
| HODGES, Nigel Ian | Director | Sonning House 2 Canns Lane TA6 6QF North Petherton Somerset | British | 75692570001 | ||||||
| HUNTLEY, Peter William | Director | 28 Allan Glen Gardens Bishopbriggs G64 3BG Glasgow | Scotland | British | 46387640002 | |||||
| KLEIN, David | Director | 45 Princes Road The Alberts TW10 6DQ Richmond Surrey | American | 119928070001 | ||||||
| LONGSTAFF, Brian William | Director | The Old Rectory TA3 6AG Beer Crocombe Somerset | British | 10586030001 | ||||||
| MALHOTRA, Deepak Kumar | Director | Constellation House The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR Artington Guildford Surrey | United Kingdom | British | 69554640002 | |||||
| MORAMARCO, Jon | Director | C8 Trinity Gate Epsom Road GU1 3PW Guildford Surrey | American | 114902210001 | ||||||
| MURRAY, Norman Loch | Director | 8 Pentland Avenue EH13 0HZ Edinburgh | Scotland | British | 22920002 | |||||
| NASH, Andrew John | Director | Cheddon Corner Cheddon Fitzpaine TA2 8LB Taunton Somerset | England | British | 53544690001 | |||||
| PEARCH, Nicholas Keith | Director | The Close Church Street Blagdon BS18 6SJ Bristol Avon | British | 21035260001 | ||||||
| PETERS, Richard David | Director | Rose Cottage, Upper House Lane Shamley Green GU5 0SX Guildford Surrey | United Kingdom | British | 60630980002 | |||||
| ROBERTS, Charles Francis Miles | Director | The Poplars Staplegrove TA2 6AJ Taunton Somerset | British | 21087800001 |
¿Tiene TAUNTON CIDER alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Assignment | Creado el 08 nov 1991 Entregado el 26 nov 1991 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of any relevant documents | |
Breve descripción All rights title interest in and to the insurance policies.see schedule attachedfor details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Guarantee and debenture | Creado el 22 may 1991 Entregado el 05 jun 1991 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All moneys due or to become due from the company to the chargee under the terms of the "relevant documents" as defined in the deed | |
Breve descripción (Please see doc M634C for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Deed of assignment of key man policies | Creado el 22 may 1991 Entregado el 05 jun 1991 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of any relevant documents (as defined) | |
Breve descripción All the company's right title and interest in and to the interim insurance policies- see form 395 (ref 66) for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0