TAUNTON CIDER

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaTAUNTON CIDER
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad privada sin límite de capital
    Número de empresa 02560211
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de TAUNTON CIDER?

    • Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra TAUNTON CIDER?

    Dirección de la sede social
    Constellation House
    The Guildway Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Artington Guildford
    Surrey
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de TAUNTON CIDER?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    TAUNTON BRANDS LIMITED14 jun 199114 jun 1991
    GRAVITAS 1001 LIMITED20 nov 199020 nov 1990

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de TAUNTON CIDER?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta28 feb 2011

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para TAUNTON CIDER?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Déclaration annuelle établie au 01 nov 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital06 nov 2012

    Estado de capital el 06 nov 2012

    • Capital: GBP .2
    SH01

    Déclaration annuelle établie au 01 nov 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 28 feb 2011

    12 páginasAA

    Cambio de datos del secretario Mr Ronald Charles Fondiller el 27 jun 2011

    2 páginasCH03

    Cambio de datos del director Mr Perry Richard Humphrey el 27 jun 2011

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del secretario Barbara Joy Laverdi el 27 jun 2011

    2 páginasCH03

    Cambio de datos del director Mr David Eric Klein el 27 jun 2011

    2 páginasCH01

    Cese del nombramiento de Deepak Malhotra como secretario

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Mr David Eric Klein como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Perry Richard Humphrey como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Troy Christensen como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Francis Hetterich como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Barbara Joy Laverdi como secretario

    2 páginasAP03

    Nombramiento de Mr Ronald Charles Fondiller como secretario

    2 páginasAP03

    legacy

    3 páginasMG02

    Déclaration annuelle établie au 01 nov 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cese del nombramiento de Helen Glennie como secretario

    1 páginasTM02

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 28 feb 2010

    4 páginasAA

    Cambio de datos del director Mr Troy Christensen el 11 jun 2010

    2 páginasCH01

    Nombramiento de Mr Francis Paul Hetterich como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mrs Helen Margaret Glennie como secretario

    1 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Helen Glennie como director

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de TAUNTON CIDER?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    FONDILLER, Ronald Charles
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    Secretario
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    159704710001
    LAVERDI, Barbara Joy
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    Secretario
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    159704720001
    HUMPHREY, Perry Richard
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    United StatesAmerican159704890001
    KLEIN, David Eric
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    United StatesAmerican153569440001
    COLQUHOUN, Anne Therese
    Apartment B Kings Ride House
    Prince Albert Drive
    SL5 8AQ Ascot
    Secretario
    Apartment B Kings Ride House
    Prince Albert Drive
    SL5 8AQ Ascot
    British28396500005
    GIBBS, Brian
    Furlongs
    4 Killams Green
    TA1 3YQ Taunton
    Somerset
    Secretario
    Furlongs
    4 Killams Green
    TA1 3YQ Taunton
    Somerset
    British10630840002
    GLENNIE, Helen Margaret
    Constellation House
    The Guildway Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Artington Guildford
    Surrey
    Secretario
    Constellation House
    The Guildway Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Artington Guildford
    Surrey
    149568800001
    MALHOTRA, Deepak Kumar
    Constellation House
    The Guildway Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Artington Guildford
    Surrey
    Secretario
    Constellation House
    The Guildway Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Artington Guildford
    Surrey
    British69554640002
    ADAMS, Peter George
    Lower Northcott Farm
    Sheldon
    EX15 2JF Cullompton
    Devon
    Director
    Lower Northcott Farm
    Sheldon
    EX15 2JF Cullompton
    Devon
    British112143030001
    BOASE, Martin
    27 St Leonards Terrace
    SW3 4QG London
    Director
    27 St Leonards Terrace
    SW3 4QG London
    United KingdomBritish1460150003
    CARSON, Christopher
    White Gates
    11 Oxshott Way
    KT11 2RU Cobham
    Surrey
    Director
    White Gates
    11 Oxshott Way
    KT11 2RU Cobham
    Surrey
    British26602290003
    CHRISTENSEN, Troy
    Constellation House
    The Guildway Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Artington Guildford
    Surrey
    Director
    Constellation House
    The Guildway Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Artington Guildford
    Surrey
    AustraliaAmerican130789730002
    COLQUHOUN, Anne Therese
    Apartment B Kings Ride House
    Prince Albert Drive
    SL5 8AQ Ascot
    Director
    Apartment B Kings Ride House
    Prince Albert Drive
    SL5 8AQ Ascot
    United KingdomBritish28396500005
    COTTRELL, Michael Noel Francis
    Laurenden Forstal
    Challock Lees
    TN25 4AU Ashford
    Kent
    Director
    Laurenden Forstal
    Challock Lees
    TN25 4AU Ashford
    Kent
    British16762950001
    CREIGHTON, Thomas Hugh
    Apple Acre
    High Road
    CR5 3QR Chipstead
    Surrey
    Director
    Apple Acre
    High Road
    CR5 3QR Chipstead
    Surrey
    EnglandBritish157727790001
    DAVIS, Peter John
    9 Christchurch Street
    SW3 4AN London
    Director
    9 Christchurch Street
    SW3 4AN London
    British988330001
    ETHERIDGE, Hugh Charles
    5 Springfield Place
    BA1 5RA Bath
    Avon
    Director
    5 Springfield Place
    BA1 5RA Bath
    Avon
    United KingdomBritish1491130002
    FOTHERGILL, David
    Woodfordes
    Stoke St Mary
    TA3 5BY Taunton
    Somerset
    Director
    Woodfordes
    Stoke St Mary
    TA3 5BY Taunton
    Somerset
    British35902810001
    GARNER, Michael Frederick
    Old Drews
    Knotty Green
    HP9 2TT Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Director
    Old Drews
    Knotty Green
    HP9 2TT Beaconsfield
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish17481250001
    GLENNIE, Helen Margaret
    Constellation House
    The Guildway Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Artington Guildford
    Surrey
    Director
    Constellation House
    The Guildway Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Artington Guildford
    Surrey
    United KingdomBritish137615160001
    GOUGH, Jeremy David Erle
    15 Burstock Road
    SW15 2PW London
    Director
    15 Burstock Road
    SW15 2PW London
    British62545050001
    HETTERICH, Francis Paul
    The Guildway, Old Portsmouth Road
    Artington
    GU3 1LR Guildford
    Constellation House
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    The Guildway, Old Portsmouth Road
    Artington
    GU3 1LR Guildford
    Constellation House
    Surrey
    United Kingdom
    United StatesAmerican147054340001
    HODGES, Nigel Ian
    Sonning House
    2 Canns Lane
    TA6 6QF North Petherton
    Somerset
    Director
    Sonning House
    2 Canns Lane
    TA6 6QF North Petherton
    Somerset
    British75692570001
    HUNTLEY, Peter William
    28 Allan Glen Gardens
    Bishopbriggs
    G64 3BG Glasgow
    Director
    28 Allan Glen Gardens
    Bishopbriggs
    G64 3BG Glasgow
    ScotlandBritish46387640002
    KLEIN, David
    45 Princes Road
    The Alberts
    TW10 6DQ Richmond
    Surrey
    Director
    45 Princes Road
    The Alberts
    TW10 6DQ Richmond
    Surrey
    American119928070001
    LONGSTAFF, Brian William
    The Old Rectory
    TA3 6AG Beer Crocombe
    Somerset
    Director
    The Old Rectory
    TA3 6AG Beer Crocombe
    Somerset
    British10586030001
    MALHOTRA, Deepak Kumar
    Constellation House
    The Guildway Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Artington Guildford
    Surrey
    Director
    Constellation House
    The Guildway Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Artington Guildford
    Surrey
    United KingdomBritish69554640002
    MORAMARCO, Jon
    C8 Trinity Gate
    Epsom Road
    GU1 3PW Guildford
    Surrey
    Director
    C8 Trinity Gate
    Epsom Road
    GU1 3PW Guildford
    Surrey
    American114902210001
    MURRAY, Norman Loch
    8 Pentland Avenue
    EH13 0HZ Edinburgh
    Director
    8 Pentland Avenue
    EH13 0HZ Edinburgh
    ScotlandBritish22920002
    NASH, Andrew John
    Cheddon Corner
    Cheddon Fitzpaine
    TA2 8LB Taunton
    Somerset
    Director
    Cheddon Corner
    Cheddon Fitzpaine
    TA2 8LB Taunton
    Somerset
    EnglandBritish53544690001
    PEARCH, Nicholas Keith
    The Close Church Street
    Blagdon
    BS18 6SJ Bristol
    Avon
    Director
    The Close Church Street
    Blagdon
    BS18 6SJ Bristol
    Avon
    British21035260001
    PETERS, Richard David
    Rose Cottage, Upper House Lane
    Shamley Green
    GU5 0SX Guildford
    Surrey
    Director
    Rose Cottage, Upper House Lane
    Shamley Green
    GU5 0SX Guildford
    Surrey
    United KingdomBritish60630980002
    ROBERTS, Charles Francis Miles
    The Poplars
    Staplegrove
    TA2 6AJ Taunton
    Somerset
    Director
    The Poplars
    Staplegrove
    TA2 6AJ Taunton
    Somerset
    British21087800001

    ¿Tiene TAUNTON CIDER alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Assignment
    Creado el 08 nov 1991
    Entregado el 26 nov 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of any relevant documents
    Breve descripción
    All rights title interest in and to the insurance policies.see schedule attachedfor details.
    Personas con derecho
    • Samuel Montagu &Co. Limited as Trustee for the Security Beneficaries
    Transacciones
    • 26 nov 1991Registro de un cargo (395)
    • 02 feb 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Guarantee and debenture
    Creado el 22 may 1991
    Entregado el 05 jun 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys due or to become due from the company to the chargee under the terms of the "relevant documents" as defined in the deed
    Breve descripción
    (Please see doc M634C for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Samuel Montagu & Co. Limited(As Trustee for the Security Beneficiaries)
    Transacciones
    • 05 jun 1991Registro de una carga
    • 21 ago 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of assignment of key man policies
    Creado el 22 may 1991
    Entregado el 05 jun 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of any relevant documents (as defined)
    Breve descripción
    All the company's right title and interest in and to the interim insurance policies- see form 395 (ref 66) for full details.
    Personas con derecho
    • Samuel Montague & Co LTD(As Trustee for the Security Beneficiaries)
    Transacciones
    • 05 jun 1991Registro de una carga
    • 21 ago 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0