SHOREPAC LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaSHOREPAC LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02562324
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de SHOREPAC LIMITED?

    • (2121) /

    ¿Dónde se encuentra SHOREPAC LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Beech House Whitebrook Park
    68 Lower Cookham Road
    SL6 8XY Maidenhead
    Berkshire
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de SHOREPAC LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 abr 2010

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para SHOREPAC LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Renuncia de bienes vacantes

    1 páginasBONA

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Cese del nombramiento de Carolyn Cattermole como director

    1 páginasTM01

    La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida

    1 páginasSOAS(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 10 may 2011

    • Capital: GBP 10
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Declaración de los objetos de la sociedad

    2 páginasCC04

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de modificación de los Artículos de Asociación

    RES01

    Déclaration annuelle établie au 17 sept 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 abr 2010

    7 páginasAA

    Cese del nombramiento de Alexander Manisty como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Anthony Thorne como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Miles William Roberts como director

    2 páginasAP01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 abr 2009

    7 páginasAA

    Cambio de datos del director Alexander Manisty el 01 oct 2009

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Dr Anthony David Thorne el 01 oct 2009

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Stephen William Dryden el 01 oct 2009

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Carolyn Tracy Cattermole el 01 oct 2009

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del secretario Anne Steele el 01 oct 2009

    1 páginasCH03

    legacy

    4 páginas363a

    legacy

    1 páginas287

    ¿Quiénes son los directivos de SHOREPAC LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    STEELE, Anne
    Whitebrook Park
    68 Lower Cookham Road
    SL6 8XY Maidenhead
    Beech House
    Berkshire
    United Kingdom
    Secretario
    Whitebrook Park
    68 Lower Cookham Road
    SL6 8XY Maidenhead
    Beech House
    Berkshire
    United Kingdom
    British77624110001
    DRYDEN, Stephen William
    Whitebrook Park
    68 Lower Cookham Road
    SL6 8XY Maidenhead
    Beech House
    Berkshire
    United Kingdom
    Director
    Whitebrook Park
    68 Lower Cookham Road
    SL6 8XY Maidenhead
    Beech House
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish47821400004
    ROBERTS, Miles William
    Whitebrook Park
    68 Lower Cookham Road
    SL6 8XY Maidenhead
    Beech House
    Berkshire
    United Kingdom
    Director
    Whitebrook Park
    68 Lower Cookham Road
    SL6 8XY Maidenhead
    Beech House
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish57880630003
    BALL, Janet Vivien
    The Beeches St Marys Lane
    LN11 0DU Louth
    Lincolnshire
    Secretario
    The Beeches St Marys Lane
    LN11 0DU Louth
    Lincolnshire
    British22587470002
    FENSOME, Richard James
    Ravenscroft
    15 Fulmer Drive
    SL9 7HH Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Secretario
    Ravenscroft
    15 Fulmer Drive
    SL9 7HH Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British84096960001
    ULYATT, Ann
    Raybecca
    Main Road Thimbleby
    LN9 5RB Horncastle
    Lincolnshire
    Secretario
    Raybecca
    Main Road Thimbleby
    LN9 5RB Horncastle
    Lincolnshire
    British20885500001
    BALL, Janet Vivien
    The Beeches St Marys Lane
    LN11 0DU Louth
    Lincolnshire
    Director
    The Beeches St Marys Lane
    LN11 0DU Louth
    Lincolnshire
    British22587470002
    BALL, Kenneth William
    The Beeches St Marys Lane
    LN11 0DU Louth
    Lincolnshire
    Director
    The Beeches St Marys Lane
    LN11 0DU Louth
    Lincolnshire
    EnglandBritish4246970002
    BLACKFORD, Christopher Fitzgerald
    .
    Dovecote Church Road, Walpole St Peter
    PE14 7NS Wisbech
    Director
    .
    Dovecote Church Road, Walpole St Peter
    PE14 7NS Wisbech
    British61034050002
    BROUGHTON, Geoffrey
    17 St James View
    LN11 9XY Louth
    Lincolnshire
    Director
    17 St James View
    LN11 9XY Louth
    Lincolnshire
    British45727470002
    BUTTON, Graham Christopher
    1 Harmston Park Avenue
    LN5 9GF Lincoln
    Lincolnshire
    Director
    1 Harmston Park Avenue
    LN5 9GF Lincoln
    Lincolnshire
    British77558190002
    CATTERMOLE, Carolyn Tracy
    Whitebrook Park
    68 Lower Cookham Road
    SL6 8XY Maidenhead
    Beech House
    Berkshire
    United Kingdom
    Director
    Whitebrook Park
    68 Lower Cookham Road
    SL6 8XY Maidenhead
    Beech House
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish53026290002
    GOULSBRA, Andrew
    4 Alfred Smith Way
    Legbourne
    LN11 8NE Louth
    Lincolnshire
    Director
    4 Alfred Smith Way
    Legbourne
    LN11 8NE Louth
    Lincolnshire
    British45727460001
    LOWE, John Arthur
    14 North Park Road
    LS8 1JD Leeds
    Director
    14 North Park Road
    LS8 1JD Leeds
    British51404250001
    MANISTY, Alexander
    Whitebrook Park
    68 Lower Cookham Road
    SL6 8XY Maidenhead
    Beech House
    Berkshire
    United Kingdom
    Director
    Whitebrook Park
    68 Lower Cookham Road
    SL6 8XY Maidenhead
    Beech House
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish72427180001
    MORRIS, Gavin Mathew
    20 Argyll Road
    W8 7BG London
    Director
    20 Argyll Road
    W8 7BG London
    EnglandBritish16228990001
    THORNE, Anthony David
    Whitebrook Park
    68 Lower Cookham Road
    SL6 8XY Maidenhead
    Beech House
    Berkshire
    United Kingdom
    Director
    Whitebrook Park
    68 Lower Cookham Road
    SL6 8XY Maidenhead
    Beech House
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish40130640001
    ULYATT, Ann
    Raybecca
    Main Road Thimbleby
    LN9 5RB Horncastle
    Lincolnshire
    Director
    Raybecca
    Main Road Thimbleby
    LN9 5RB Horncastle
    Lincolnshire
    British20885500001

    ¿Tiene SHOREPAC LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    An omnibus guarantee and set-off agreement dated
    Creado el 22 mar 2004
    Entregado el 25 mar 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling or in a currency or currencies other than sterling;.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 25 mar 2004Registro de un cargo (395)
    • 04 may 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 20 march 2002
    Creado el 18 may 2003
    Entregado el 30 may 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 30 may 2003Registro de un cargo (395)
    • 15 nov 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Single debenture
    Creado el 05 abr 1993
    Entregado el 08 abr 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 08 abr 1993Registro de un cargo (395)
    • 02 jul 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 02 abr 1993
    Entregado el 09 abr 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Factory premises at warwick road fairfield industrial estate louth lincs and goodwill of the business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 09 abr 1993Registro de un cargo (395)
    • 15 nov 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0