MOTORS SECRETARIES LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | MOTORS SECRETARIES LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02564446 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de MOTORS SECRETARIES LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra MOTORS SECRETARIES LIMITED?
| Dirección de la sede social | Citypoint 16th Floor One Ropemaker Street EC2Y 9AW London England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de MOTORS SECRETARIES LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| INDEXEQUAL LIMITED | 30 nov 1990 | 30 nov 1990 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de MOTORS SECRETARIES LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2019 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para MOTORS SECRETARIES LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 1 páginas | DS01 | ||
Cese del nombramiento de Jeremy David Swinnerton como director el 28 feb 2020 | 2 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 19 sept 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2019 | 3 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 19 sept 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2018 | 3 páginas | AA | ||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado de Griffin House Osborne Road Luton LU1 3YT England a Chalton House Uk-101-135 Luton Road Chalton Luton LU4 9TT | 1 páginas | AD02 | ||
Cese del nombramiento de Susan Beverley Hughes como director el 31 ene 2018 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 19 sept 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de , 10 Chiswell Street, London, EC1Y 4UQ a Citypoint 16th Floor One Ropemaker Street London EC2Y 9AW el 03 oct 2018 | 1 páginas | AD01 | ||
Cese del nombramiento de Trudy Anne Patrick como director el 30 jun 2018 | 1 páginas | TM01 | ||
Modification des détails de General Motors Uk Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 18 sept 2017 | 2 páginas | PSC05 | ||
Cese del nombramiento de Frances Elizabeth Nicholls como director el 21 mar 2018 | 2 páginas | TM01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017 | 3 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 19 sept 2017 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Natalie Sarah Alice Kennett como director el 31 ago 2017 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016 | 3 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 19 sept 2016 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Motors Nominees Limited como director el 25 ene 2016 | 2 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Susan Beverley Hughes como director el 15 ene 2016 | 3 páginas | AP01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015 | 3 páginas | AA | ||
Nombramiento de Ms Frances Elizabeth Nicholls como director el 01 ene 2016 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Ms Natalie Sarah Alice Kennett como director el 01 ene 2016 | 2 páginas | AP01 | ||
¿Quiénes son los directivos de MOTORS SECRETARIES LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SORENSEN, Paul Antony | Secretario | 16th Floor One Ropemaker Street EC2Y 9AW London Citypoint England | British | 189146410001 | ||||||
| LAWS, Susan Ann | Director | Boundary Cottage Bellingdon HP5 2XN Chesham Buckinghamshire | England | British | 49501780001 | |||||
| SORENSEN, Paul Antony | Director | 16th Floor One Ropemaker Street EC2Y 9AW London Citypoint England | England | British | 189146410001 | |||||
| GLADWIN, Peter William | Secretario | Lakeside Lodge 79 Wedgwood Avenue Blakelands MK14 5JZ Milton Keynes Buckinghamshire | British | 26965400002 | ||||||
| HICKS, Jeremy Christopher | Secretario | 48 Station Road Woburn Sands MK17 8RU Milton Keynes Buckinghamshire | British | 31366620002 | ||||||
| HIGGINS, Andrew Terence | Secretario | 9 Poppy Leys Heronswood NN6 9UL Brixworth | British | 45557540001 | ||||||
| ABBOTT, Michael Richard | Director | Chiswell Street EC1Y 4UQ London 10 England | England | British | 160191960001 | |||||
| AHIR, Baljinder | Director | Chiswell Street EC1Y 4UQ London 10 England | England | British | 160192370001 | |||||
| ARMITT, Michael William | Director | Chiswell Street EC1Y 4UQ London 10 | Uk | British | 183933610001 | |||||
| BARRETT, Nicholas Paul | Director | 38 Kilmarnock Drive Bushmead LU2 7YP Luton Bedfordshire | England | British | 45958930001 | |||||
| BENJAMIN, Keith John | Director | 35 Queens Road AL5 1QW Harpenden Hertfordshire | British | 34539180002 | ||||||
| BROOKES, Edward | Director | 39 Bury New Road Breightmet BL2 6QG Bolton | British | 37674990001 | ||||||
| CHARTERS, Peter Douglas | Director | 1b St Johns Hill TN13 3NX Sevenoaks Kent | British | 42159280002 | ||||||
| CLARK, Andrew David | Director | 1 Chantry Close Woburn Sands MK17 8UB Milton Keynes Bedfordshire | British | 78232040001 | ||||||
| COOK, Steven Jonathan | Director | 4 Chiswell Street London EC1Y 4UP | England | British | 109108950002 | |||||
| CRITCHLEY, Howard John | Director | 13 Coates Gardens EH12 5LG Edinburgh | British | 53421340001 | ||||||
| GLADWIN, Peter William | Director | Lakeside Lodge 79 Wedgwood Avenue Blakelands MK14 5JZ Milton Keynes Buckinghamshire | British | 26965400002 | ||||||
| GORTON, Ian Reid | Director | 4 Kinloch Court Station Road AL5 4UE Harpenden Hertfordshire | British | 47774090001 | ||||||
| HARVEY, John | Director | 146 Altrincham Road SK9 5NQ Wilmslow Cheshire | British | 1306000001 | ||||||
| HAWES, Alastair Stuart | Director | 3f2 39 Viewforth EH10 4JE Edinburgh Midlothian | British | 58121130001 | ||||||
| HICKS, Jeremy Christopher | Director | 48 Station Road Woburn Sands MK17 8RU Milton Keynes Buckinghamshire | British | 31366620002 | ||||||
| HIGGINS, Andrew Terence | Director | 9 Poppy Leys Heronswood NN6 9UL Brixworth | British | 45557540001 | ||||||
| HOCKING, Andrew Glen | Director | Chiswell Street EC1Y 4UQ London 10 England | Ireland | British | 146003350001 | |||||
| HOCKING, Andrew Glen | Director | Sennen Grange Road, Felmersham MK43 7EU Bedford Bedfordshire | British | 71959860001 | ||||||
| HUGHES, Susan Beverley | Director | Osborne Road LU1 3YT Luton Griffin House Bedfordshire | United Kingdom | British | 136763900001 | |||||
| HUGHES, Susan Beverley | Director | 71 Abbots Park AL1 1TW St Albans Hertfordshire | British | 62584350002 | ||||||
| JONES, John Robert | Director | 20 Paris Scholes HD7 1UA Huddersfield West Yorkshire | British | 75415640001 | ||||||
| KEATES, Richard Anthony | Director | 10 Milton Bridge Newport Pagnell Road NN4 6AT Wootton Northamptonshire | British | 49549930001 | ||||||
| KENNETT, Natalie Sarah Alice | Director | Chiswell Street EC1Y 4UQ London 10 | England | British | 204123860001 | |||||
| KENWORTHY, Sarah Louise | Director | 8 Station Road Woburn Sands MK17 8RW Milton Keynes | British | 40608110002 | ||||||
| KENWORTHY, Sarah Louise | Director | 8 Station Road Woburn Sands MK17 8RW Milton Keynes | British | 40608110002 | ||||||
| KEYZOR, Jenny Margaret | Director | 5 Park Street SG4 9AH Hitchin Hertfordshire | British | 62584330002 | ||||||
| LANNON, Declan Patrick | Director | The Old Coach House Dark Lane Oving HP22 4HP Aylesbury Buckinghamshire | Irish | 78997740002 | ||||||
| LENATHEN, Craig | Director | 19 Ercall Road FK2 0RL Brightons Falkirk | British | 72225460001 | ||||||
| MCKECHNIE, Gordon Douglas | Director | 36 Sandycroft Road HP6 6QP Little Chalfont Buckinghamshire | South African | 123373250001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de MOTORS SECRETARIES LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vauxhall Motors Limited | 06 abr 2016 | Osborne Road Uk1-101-135 LU1 3YT Luton Griffin House Beds England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0