INTERACT WORLDWIDE

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaINTERACT WORLDWIDE
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social, exención del uso de 'Limited'
    Número de empresa 02567545
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de INTERACT WORLDWIDE?

    • Otras actividades de asistencia sanitaria (86900) / Actividades sanitarias y de asistencia social

    ¿Dónde se encuentra INTERACT WORLDWIDE?

    Dirección de la sede social
    Finsgate
    5-7 Cranwood Street
    EC1V 9LH London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de INTERACT WORLDWIDE?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    POPULATION CONCERN11 dic 199011 dic 1990

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de INTERACT WORLDWIDE?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 jun 2013

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para INTERACT WORLDWIDE?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Déclaration annuelle établie au 11 dic 2013, aucune liste de membres fournie

    6 páginasAR01

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2013

    33 páginasAA

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    5 páginasDS01

    Nombramiento de Ms Kristen Morgan como secretario el 06 jun 2013

    1 páginasAP03

    Cese del nombramiento de John Pinchard como secretario el 06 jun 2013

    1 páginasTM02

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2012

    38 páginasAA

    Nombramiento de Mr John Worley como director el 09 mar 2012

    2 páginasAP01

    Déclaration annuelle établie au 11 dic 2012, aucune liste de membres fournie

    6 páginasAR01

    Nombramiento de Dr Elizabeth Anne Goodburn como director el 08 mar 2012

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Leon James Ward como director el 04 oct 2012

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Ian Buist como director el 09 may 2012

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2011

    35 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 11 dic 2011, aucune liste de membres fournie

    6 páginasAR01

    Nombramiento de Angela Mary Penrose como director el 10 nov 2011

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Anne Grant como director el 10 nov 2011

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2010

    41 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 11 dic 2010, aucune liste de membres fournie

    6 páginasAR01

    Exercice comptable précédent prolongé du 31 mar 2010 au 30 jun 2010

    1 páginasAA01

    Domicilio social registrado cambiado de Studio 325 Highgate Studios 53-79 Highgate Road London NW5 1TL el 18 may 2010

    1 páginasAD01

    Déclaration annuelle établie au 11 dic 2009, aucune liste de membres fournie

    5 páginasAR01

    Cambio de datos del director Kathleen Burke el 01 oct 2009

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Ms Elizabeth Ann Cooper el 01 oct 2009

    2 páginasCH01

    Nombramiento de Mr John Pinchard como secretario

    1 páginasAP03

    ¿Quiénes son los directivos de INTERACT WORLDWIDE?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MORGAN, Kristen
    5-7 Cranwood Street
    EC1V 9LH London
    Finsgate
    Secretario
    5-7 Cranwood Street
    EC1V 9LH London
    Finsgate
    179411920001
    BURKE, Kathleen Majerus
    Lanchester Road
    Highgate
    N6 4SU London
    5
    Director
    Lanchester Road
    Highgate
    N6 4SU London
    5
    EnglandAmericanTeacher130409680001
    COOPER, Elizabeth Ann
    9 Celia Road
    N19 5ET London
    Director
    9 Celia Road
    N19 5ET London
    United KingdomBritishSelf Employed12098050001
    GOODBURN, Elizabeth Anne, Dr
    5-7 Cranwood Street
    EC1V 9LH London
    Finsgate
    Director
    5-7 Cranwood Street
    EC1V 9LH London
    Finsgate
    EnglandBritishGeneral Practitioner115715440001
    KHAN, Javaid
    5-7 Cranwood Street
    EC1V 9LH London
    Finsgate
    Director
    5-7 Cranwood Street
    EC1V 9LH London
    Finsgate
    United KingdomBritishAccountant78318560001
    PENROSE, Angela Mary
    5-7 Cranwood Street
    EC1V 9LH London
    Finsgate
    Director
    5-7 Cranwood Street
    EC1V 9LH London
    Finsgate
    United KingdomBritishConsultant101420460001
    ROGERSON, Andrew Philip
    5-7 Cranwood Street
    EC1V 9LH London
    Finsgate
    Director
    5-7 Cranwood Street
    EC1V 9LH London
    Finsgate
    United KingdomBritishDevelopment146034040001
    WARD, Leon James
    5-7 Cranwood Street
    EC1V 9LH London
    Finsgate
    Director
    5-7 Cranwood Street
    EC1V 9LH London
    Finsgate
    EnglandBritishStudent And Marketing Officer174135590001
    WORLEY, John
    5-7 Cranwood Street
    EC1V 9LH London
    Finsgate
    Director
    5-7 Cranwood Street
    EC1V 9LH London
    Finsgate
    EnglandBritishInterim Director Of External Relations174831510001
    BOWDEN, Kim Annette
    84 Westcombe Park Road
    Blackheath
    SE3 7QS London
    Secretario
    84 Westcombe Park Road
    Blackheath
    SE3 7QS London
    BritishDirector Of Finance117777870001
    DAVIES, Rosalyn Anne
    137 Huddleston Road
    N7 0EH London
    Secretario
    137 Huddleston Road
    N7 0EH London
    BritishChief Executive101792560002
    DWYER, Doris Mary
    3 Newhaven Road
    SE25 6JQ London
    Secretario
    3 Newhaven Road
    SE25 6JQ London
    British70983340001
    EVANS, Caroline Alison
    337 Hatfield Road
    AL4 0DH St Albans
    Hertfordshire
    Secretario
    337 Hatfield Road
    AL4 0DH St Albans
    Hertfordshire
    BritishAdministrator42712970003
    HIGINBOTHAM, John Alfred
    Walnut & Well Cottage
    The Street Bolney
    RH17 5QW Haywards Heath
    West Sussex
    Secretario
    Walnut & Well Cottage
    The Street Bolney
    RH17 5QW Haywards Heath
    West Sussex
    British1829770001
    MASON, Melody
    Bere Alston
    PL20 7ED Plymouth
    Collytown Farm
    Devon
    United Kingdom
    Secretario
    Bere Alston
    PL20 7ED Plymouth
    Collytown Farm
    Devon
    United Kingdom
    BritishRetired135203110001
    MUSA YAYI, Edith
    3 Tynsdale Road
    NW10 2GB London
    Secretario
    3 Tynsdale Road
    NW10 2GB London
    BritishFinance Director84350490001
    OUDMAYER, Bruno Carel
    Highgate Studios 53-79 Highgate Road
    NW5 1TL London
    325
    Uk
    Secretario
    Highgate Studios 53-79 Highgate Road
    NW5 1TL London
    325
    Uk
    DutchChief Executive Officer132805950001
    PINCHARD, John
    5-7 Cranwood Street
    EC1V 9LH London
    Finsgate
    Secretario
    5-7 Cranwood Street
    EC1V 9LH London
    Finsgate
    146034200001
    BARKER, Gary Lester
    Sunny Bank Maiden Street
    Weston
    SG4 7AA Hitchin
    Hertfordshire
    Director
    Sunny Bank Maiden Street
    Weston
    SG4 7AA Hitchin
    Hertfordshire
    BritishSolicitor31253210001
    BARNES, Simon William Stewart
    Walcot House
    139 Kennington Road
    SE11 6SF London
    Director
    Walcot House
    139 Kennington Road
    SE11 6SF London
    BritishChartered Accountant80712480001
    BLUESTONE, Kenneth Martin
    Crowshole Farmhouse
    Iping Common
    GU29 0JW Midhurst
    West Sussex
    Director
    Crowshole Farmhouse
    Iping Common
    GU29 0JW Midhurst
    West Sussex
    BritishConsultant118290160001
    BROWN, Diana Margaretta
    Route De Morrens
    Ch 1037 Etagnieres
    Switzerland
    Director
    Route De Morrens
    Ch 1037 Etagnieres
    Switzerland
    British23418360002
    BROWNE, Anthony
    5 Leighton Road
    NW5 2QD Kentish Town
    Director
    5 Leighton Road
    NW5 2QD Kentish Town
    BritishJournalist75136030001
    BUIST, Ian
    5-7 Cranwood Street
    EC1V 9LH London
    Finsgate
    Director
    5-7 Cranwood Street
    EC1V 9LH London
    Finsgate
    United KingdomBritishRetired146033500001
    CLEMENTS EYRE, Anne, Lady
    7 Wallside Monkwell Square
    Barbican
    EC2Y 8BH London
    Director
    7 Wallside Monkwell Square
    Barbican
    EC2Y 8BH London
    BritishActress23418380002
    COSSEY, Dilys
    318 Kennington Road
    SE11 4LD London
    Director
    318 Kennington Road
    SE11 4LD London
    United KingdomBritishManager13397920001
    DURBIN, Julia
    107 Roseberry Gardens
    N41 5H London
    Director
    107 Roseberry Gardens
    N41 5H London
    BritishRadio Producer89257400001
    ELDRED, Josy
    31 Brodrick Road
    SW17 7DX London
    Director
    31 Brodrick Road
    SW17 7DX London
    BritishClerk/Advisor House Of Commons62834900001
    EVANS, Robert John Emlyn
    Marrowells
    KT13 9RN Weybridge
    19
    Surrey
    Director
    Marrowells
    KT13 9RN Weybridge
    19
    Surrey
    United KingdomBritishMep138885060001
    GHOLAP, Rajit
    7 Caprea Close
    UB4 9PE Yeading
    Middlesex
    Director
    7 Caprea Close
    UB4 9PE Yeading
    Middlesex
    BritishAccountant98189700001
    GRANT, Anne
    5-7 Cranwood Street
    EC1V 9LH London
    Finsgate
    Director
    5-7 Cranwood Street
    EC1V 9LH London
    Finsgate
    United KingdomBritishRetired146033690001
    HALLETT, Lesley
    1st Floor 106 Denmark Hill
    Camberwell
    SE5 8RX London
    Director
    1st Floor 106 Denmark Hill
    Camberwell
    SE5 8RX London
    United KingdomBritishMarketing + Communication Cons116400720001
    HIGINBOTHAM, John Alfred
    Walnut & Well Cottage
    The Street Bolney
    RH17 5QW Haywards Heath
    West Sussex
    Director
    Walnut & Well Cottage
    The Street Bolney
    RH17 5QW Haywards Heath
    West Sussex
    BritishRetired Company Director1829770001
    JAMES, Arthur Gladdish Trevenen
    125 Harley Street
    W1N 1HE London
    Director
    125 Harley Street
    W1N 1HE London
    BritishRaf (Retd)23418370001
    JANKEL-ELLIOTT, Nicholas Seneca Henry
    87 Purves Road
    NW10 5TE London
    Director
    87 Purves Road
    NW10 5TE London
    United KingdomBritishCompany Partner68025820005

    ¿Tiene INTERACT WORLDWIDE alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 06 nov 2008
    Entregado el 13 nov 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £225,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • The Trustees for the Time Being of Charities Aid Foundation
    Transacciones
    • 13 nov 2008Registro de un cargo (395)
    • 15 ene 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge over cash deposits
    Creado el 06 dic 2000
    Entregado el 14 dic 2000
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    By way of fixed charge all sums of money in the deposit accounts (as defined) with all interest thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Standard Chartered Bank
    Transacciones
    • 14 dic 2000Registro de un cargo (395)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0