INTERACT WORLDWIDE
Visión general
Nombre de la empresa | INTERACT WORLDWIDE |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social, exención del uso de 'Limited' |
Número de empresa | 02567545 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de INTERACT WORLDWIDE?
- Otras actividades de asistencia sanitaria (86900) / Actividades sanitarias y de asistencia social
¿Dónde se encuentra INTERACT WORLDWIDE?
Dirección de la sede social | Finsgate 5-7 Cranwood Street EC1V 9LH London |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de INTERACT WORLDWIDE?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
POPULATION CONCERN | 11 dic 1990 | 11 dic 1990 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de INTERACT WORLDWIDE?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 30 jun 2013 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para INTERACT WORLDWIDE?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||
Déclaration annuelle établie au 11 dic 2013, aucune liste de membres fournie | 6 páginas | AR01 | ||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2013 | 33 páginas | AA | ||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 5 páginas | DS01 | ||
Nombramiento de Ms Kristen Morgan como secretario el 06 jun 2013 | 1 páginas | AP03 | ||
Cese del nombramiento de John Pinchard como secretario el 06 jun 2013 | 1 páginas | TM02 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2012 | 38 páginas | AA | ||
Nombramiento de Mr John Worley como director el 09 mar 2012 | 2 páginas | AP01 | ||
Déclaration annuelle établie au 11 dic 2012, aucune liste de membres fournie | 6 páginas | AR01 | ||
Nombramiento de Dr Elizabeth Anne Goodburn como director el 08 mar 2012 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr Leon James Ward como director el 04 oct 2012 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Ian Buist como director el 09 may 2012 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2011 | 35 páginas | AA | ||
Déclaration annuelle établie au 11 dic 2011, aucune liste de membres fournie | 6 páginas | AR01 | ||
Nombramiento de Angela Mary Penrose como director el 10 nov 2011 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Anne Grant como director el 10 nov 2011 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2010 | 41 páginas | AA | ||
Déclaration annuelle établie au 11 dic 2010, aucune liste de membres fournie | 6 páginas | AR01 | ||
Exercice comptable précédent prolongé du 31 mar 2010 au 30 jun 2010 | 1 páginas | AA01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de Studio 325 Highgate Studios 53-79 Highgate Road London NW5 1TL el 18 may 2010 | 1 páginas | AD01 | ||
Déclaration annuelle établie au 11 dic 2009, aucune liste de membres fournie | 5 páginas | AR01 | ||
Cambio de datos del director Kathleen Burke el 01 oct 2009 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del director Ms Elizabeth Ann Cooper el 01 oct 2009 | 2 páginas | CH01 | ||
Nombramiento de Mr John Pinchard como secretario | 1 páginas | AP03 | ||
¿Quiénes son los directivos de INTERACT WORLDWIDE?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORGAN, Kristen | Secretario | 5-7 Cranwood Street EC1V 9LH London Finsgate | 179411920001 | |||||||
BURKE, Kathleen Majerus | Director | Lanchester Road Highgate N6 4SU London 5 | England | American | Teacher | 130409680001 | ||||
COOPER, Elizabeth Ann | Director | 9 Celia Road N19 5ET London | United Kingdom | British | Self Employed | 12098050001 | ||||
GOODBURN, Elizabeth Anne, Dr | Director | 5-7 Cranwood Street EC1V 9LH London Finsgate | England | British | General Practitioner | 115715440001 | ||||
KHAN, Javaid | Director | 5-7 Cranwood Street EC1V 9LH London Finsgate | United Kingdom | British | Accountant | 78318560001 | ||||
PENROSE, Angela Mary | Director | 5-7 Cranwood Street EC1V 9LH London Finsgate | United Kingdom | British | Consultant | 101420460001 | ||||
ROGERSON, Andrew Philip | Director | 5-7 Cranwood Street EC1V 9LH London Finsgate | United Kingdom | British | Development | 146034040001 | ||||
WARD, Leon James | Director | 5-7 Cranwood Street EC1V 9LH London Finsgate | England | British | Student And Marketing Officer | 174135590001 | ||||
WORLEY, John | Director | 5-7 Cranwood Street EC1V 9LH London Finsgate | England | British | Interim Director Of External Relations | 174831510001 | ||||
BOWDEN, Kim Annette | Secretario | 84 Westcombe Park Road Blackheath SE3 7QS London | British | Director Of Finance | 117777870001 | |||||
DAVIES, Rosalyn Anne | Secretario | 137 Huddleston Road N7 0EH London | British | Chief Executive | 101792560002 | |||||
DWYER, Doris Mary | Secretario | 3 Newhaven Road SE25 6JQ London | British | 70983340001 | ||||||
EVANS, Caroline Alison | Secretario | 337 Hatfield Road AL4 0DH St Albans Hertfordshire | British | Administrator | 42712970003 | |||||
HIGINBOTHAM, John Alfred | Secretario | Walnut & Well Cottage The Street Bolney RH17 5QW Haywards Heath West Sussex | British | 1829770001 | ||||||
MASON, Melody | Secretario | Bere Alston PL20 7ED Plymouth Collytown Farm Devon United Kingdom | British | Retired | 135203110001 | |||||
MUSA YAYI, Edith | Secretario | 3 Tynsdale Road NW10 2GB London | British | Finance Director | 84350490001 | |||||
OUDMAYER, Bruno Carel | Secretario | Highgate Studios 53-79 Highgate Road NW5 1TL London 325 Uk | Dutch | Chief Executive Officer | 132805950001 | |||||
PINCHARD, John | Secretario | 5-7 Cranwood Street EC1V 9LH London Finsgate | 146034200001 | |||||||
BARKER, Gary Lester | Director | Sunny Bank Maiden Street Weston SG4 7AA Hitchin Hertfordshire | British | Solicitor | 31253210001 | |||||
BARNES, Simon William Stewart | Director | Walcot House 139 Kennington Road SE11 6SF London | British | Chartered Accountant | 80712480001 | |||||
BLUESTONE, Kenneth Martin | Director | Crowshole Farmhouse Iping Common GU29 0JW Midhurst West Sussex | British | Consultant | 118290160001 | |||||
BROWN, Diana Margaretta | Director | Route De Morrens Ch 1037 Etagnieres Switzerland | British | 23418360002 | ||||||
BROWNE, Anthony | Director | 5 Leighton Road NW5 2QD Kentish Town | British | Journalist | 75136030001 | |||||
BUIST, Ian | Director | 5-7 Cranwood Street EC1V 9LH London Finsgate | United Kingdom | British | Retired | 146033500001 | ||||
CLEMENTS EYRE, Anne, Lady | Director | 7 Wallside Monkwell Square Barbican EC2Y 8BH London | British | Actress | 23418380002 | |||||
COSSEY, Dilys | Director | 318 Kennington Road SE11 4LD London | United Kingdom | British | Manager | 13397920001 | ||||
DURBIN, Julia | Director | 107 Roseberry Gardens N41 5H London | British | Radio Producer | 89257400001 | |||||
ELDRED, Josy | Director | 31 Brodrick Road SW17 7DX London | British | Clerk/Advisor House Of Commons | 62834900001 | |||||
EVANS, Robert John Emlyn | Director | Marrowells KT13 9RN Weybridge 19 Surrey | United Kingdom | British | Mep | 138885060001 | ||||
GHOLAP, Rajit | Director | 7 Caprea Close UB4 9PE Yeading Middlesex | British | Accountant | 98189700001 | |||||
GRANT, Anne | Director | 5-7 Cranwood Street EC1V 9LH London Finsgate | United Kingdom | British | Retired | 146033690001 | ||||
HALLETT, Lesley | Director | 1st Floor 106 Denmark Hill Camberwell SE5 8RX London | United Kingdom | British | Marketing + Communication Cons | 116400720001 | ||||
HIGINBOTHAM, John Alfred | Director | Walnut & Well Cottage The Street Bolney RH17 5QW Haywards Heath West Sussex | British | Retired Company Director | 1829770001 | |||||
JAMES, Arthur Gladdish Trevenen | Director | 125 Harley Street W1N 1HE London | British | Raf (Retd) | 23418370001 | |||||
JANKEL-ELLIOTT, Nicholas Seneca Henry | Director | 87 Purves Road NW10 5TE London | United Kingdom | British | Company Partner | 68025820005 |
¿Tiene INTERACT WORLDWIDE alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Creado el 06 nov 2008 Entregado el 13 nov 2008 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £225,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Charge over cash deposits | Creado el 06 dic 2000 Entregado el 14 dic 2000 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Breve descripción By way of fixed charge all sums of money in the deposit accounts (as defined) with all interest thereon. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0