T.K. MOTORS LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | T.K. MOTORS LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 02568260 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de T.K. MOTORS LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra T.K. MOTORS LIMITED?
Dirección de la sede social | Loxley House 2 Oakwood Court Little Oak Drive NG15 0DR Annesley Nottingham Nottinghamshire |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de T.K. MOTORS LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
T.K. MOTOR GROUP LTD. | 11 mar 1991 | 11 mar 1991 |
WATCHMERIT LIMITED | 13 dic 1990 | 13 dic 1990 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de T.K. MOTORS LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2016 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para T.K. MOTORS LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||||||
Estado de capital el 14 jul 2017
| 5 páginas | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016 | 6 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 02 jun 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Richard James Maloney como secretario el 01 ene 2017 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Hilary Claire Sykes como director el 01 ene 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Hilary Claire Sykes como secretario el 01 ene 2017 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015 | 6 páginas | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 02 jun 2016 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cambio de datos del director Timothy Paul Holden el 26 oct 2015 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014 | 6 páginas | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 02 jun 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2013 | 6 páginas | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 02 jun 2014 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2012 | 6 páginas | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 02 jun 2013 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||||||
Cancelación total de la carga 8 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2011 | 6 páginas | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 02 jun 2012 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2010 | 6 páginas | AA | ||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de T.K. MOTORS LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALONEY, Richard James | Secretario | Loxley House 2 Oakwood Court Little Oak Drive NG15 0DR Annesley Nottingham Nottinghamshire | 222333850001 | |||||||||||
HOLDEN, Timothy Paul | Director | Loxley House 2 Oakwood Court Little Oak Drive NG15 0DR Annesley Nottingham Nottinghamshire | England | British | Chartered Accountant | 148034310003 | ||||||||
EVANS HALSHAW MOTORS LIMITED | Director corporativo | 2 Oakwood Court Little Oak Drive Annesley NG15 0DR Nottingham Loxley House Nottinghamshire |
| 38967740005 | ||||||||||
KEEN, Michael | Secretario | Woodlee Hillberry Green IM2 6DE Douglas Isle Of Man | British | 83811650001 | ||||||||||
PITT, Andrew Joseph | Secretario | 45 Westholme Road Bidford On Avon B50 4AL Alcester Warwickshire | British | Company Secretary | 10739800001 | |||||||||
SOWERBY, Stephen | Secretario | 37 Brighouse Close L39 3NA Ormskirk Lancashire | British | Financial Director | 26872320001 | |||||||||
SYKES, Hilary Claire | Secretario | Loxley House 2 Oakwood Court Little Oak Drive NG15 0DR Annesley Nottingham Nottinghamshire | British | Company Secretary | 41559790001 | |||||||||
ARCHER, Anthony Bernard | Director | The Moat Barn Glasshouse Lane B94 6PU Lapworth Warwickshire | British | Company Director | 46351440001 | |||||||||
CAMERON, Charles Donald Ewen | Director | Orchard Manor Church Lane Martin Hussingtree WR3 8TQ Worcester Worcestershire | England | British | Company Director | 113187140001 | ||||||||
DALE, Arthur Geoffrey | Director | Kimberley Poolhead Lane B94 5ED Tanworth In Arden Solihull West Midlands | British | Company Director | 10739820001 | |||||||||
KEEN, Michael | Director | Woodlee Hillberry Green IM2 6DE Douglas Isle Of Man | British | Company Director | 83811650001 | |||||||||
SOWERBY, Stephen | Director | 37 Brighouse Close L39 3NA Ormskirk Lancashire | British | Financial Director | 26872320001 | |||||||||
SYKES, Hilary Claire | Director | Loxley House 2 Oakwood Court Little Oak Drive NG15 0DR Annesley Nottingham Nottinghamshire | England | British | Compaany Secretary | 41559790001 | ||||||||
TEATUM, Richard | Director | Viking Lodge Ealand Outgate Ealand DN17 4JD Scunthorpe | British | Company Director | 9538630001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de T.K. MOTORS LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evans Halshaw Motor Holdings Limited | 06 abr 2016 | Little Oak Drive Annesley NG15 0DR Nottingham Loxley House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene T.K. MOTORS LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
A security agreement | Creado el 13 may 2009 Entregado el 21 may 2009 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción For details of property charged please refer to form 395. fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Transfer deed | Creado el 03 sept 1993 Entregado el 09 sept 1993 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Used vehicle charge | Creado el 31 mar 1993 Entregado el 02 abr 1993 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Specific charge over all its interest in any used and unused vehicles under the terms of the used vehicle sale agreement dated 31/03/93. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 03 dic 1991 Entregado el 06 dic 1991 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the debenture | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Deed | Creado el 22 may 1991 Entregado el 23 may 1991 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción 1) all the stock all 2) the dealers right title interest under the dealer agreement see form 395 m/70/l for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Charge | Creado el 22 may 1991 Entregado el 23 may 1991 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under ther terms of a consignment agreement dated 22/5/91 and/or this charge. | |
Breve descripción All the chargors interest (if any) in any vehicle delivered to under the agreement. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 10 may 1991 Entregado el 16 may 1991 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 10 may 1991 Entregado el 14 may 1991 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under ther terms of the charge | |
Breve descripción The used vehicle stocks of the company. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0