T.K. MOTORS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaT.K. MOTORS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02568260
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de T.K. MOTORS LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra T.K. MOTORS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive
    NG15 0DR Annesley Nottingham
    Nottinghamshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de T.K. MOTORS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    T.K. MOTOR GROUP LTD.11 mar 199111 mar 1991
    WATCHMERIT LIMITED13 dic 199013 dic 1990

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de T.K. MOTORS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2016

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para T.K. MOTORS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    legacy

    1 páginasSH20
    S69RKCPE

    Estado de capital el 14 jul 2017

    • Capital: GBP 1
    5 páginasSH19
    A69QRVVU

    legacy

    1 páginasCAP-SS
    S69RKCSQ

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Reduce share prem a/c 29/06/2017
    RES13
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01
    A69QRVTT

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016

    6 páginasAA
    A68QSQ9U

    Declaración de confirmación presentada el 02 jun 2017 con actualizaciones

    5 páginasCS01
    X68GY35N

    Nombramiento de Mr Richard James Maloney como secretario el 01 ene 2017

    2 páginasAP03
    X5XY9649

    Cese del nombramiento de Hilary Claire Sykes como director el 01 ene 2017

    1 páginasTM01
    X5XY95F5

    Cese del nombramiento de Hilary Claire Sykes como secretario el 01 ene 2017

    1 páginasTM02
    X5XY95KI

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015

    6 páginasAA
    A5GC26HU

    Déclaration annuelle établie au 02 jun 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital10 jun 2016

    Estado de capital el 10 jun 2016

    • Capital: GBP 800,000
    SH01
    X58TSWUG

    Cambio de datos del director Timothy Paul Holden el 26 oct 2015

    2 páginasCH01
    X4JXORPM

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014

    6 páginasAA
    A4GNNEOG

    Déclaration annuelle établie au 02 jun 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital11 jun 2015

    Estado de capital el 11 jun 2015

    • Capital: GBP 800,000
    SH01
    X49D5JK0

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2013

    6 páginasAA
    A3GYK44H

    Déclaration annuelle établie au 02 jun 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital16 jun 2014

    Estado de capital el 16 jun 2014

    • Capital: GBP 800,000
    SH01
    X3A5MZ48

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2012

    6 páginasAA
    A2HM7NXL

    Déclaration annuelle établie au 02 jun 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    X2AGVM3K

    Cancelación total de la carga 8

    4 páginasMR04
    L27UFGVV

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2011

    6 páginasAA
    A1IF92W0

    Déclaration annuelle établie au 02 jun 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    X1BLJ70B

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2010

    6 páginasAA
    A4KR4XZP

    ¿Quiénes son los directivos de T.K. MOTORS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MALONEY, Richard James
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive
    NG15 0DR Annesley Nottingham
    Nottinghamshire
    Secretario
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive
    NG15 0DR Annesley Nottingham
    Nottinghamshire
    222333850001
    HOLDEN, Timothy Paul
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive
    NG15 0DR Annesley Nottingham
    Nottinghamshire
    Director
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive
    NG15 0DR Annesley Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritishChartered Accountant148034310003
    EVANS HALSHAW MOTORS LIMITED
    2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Loxley House
    Nottinghamshire
    Director corporativo
    2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Loxley House
    Nottinghamshire
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro2304195
    38967740005
    KEEN, Michael
    Woodlee
    Hillberry Green
    IM2 6DE Douglas
    Isle Of Man
    Secretario
    Woodlee
    Hillberry Green
    IM2 6DE Douglas
    Isle Of Man
    British83811650001
    PITT, Andrew Joseph
    45 Westholme Road
    Bidford On Avon
    B50 4AL Alcester
    Warwickshire
    Secretario
    45 Westholme Road
    Bidford On Avon
    B50 4AL Alcester
    Warwickshire
    BritishCompany Secretary10739800001
    SOWERBY, Stephen
    37 Brighouse Close
    L39 3NA Ormskirk
    Lancashire
    Secretario
    37 Brighouse Close
    L39 3NA Ormskirk
    Lancashire
    BritishFinancial Director26872320001
    SYKES, Hilary Claire
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive
    NG15 0DR Annesley Nottingham
    Nottinghamshire
    Secretario
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive
    NG15 0DR Annesley Nottingham
    Nottinghamshire
    BritishCompany Secretary41559790001
    ARCHER, Anthony Bernard
    The Moat Barn
    Glasshouse Lane
    B94 6PU Lapworth
    Warwickshire
    Director
    The Moat Barn
    Glasshouse Lane
    B94 6PU Lapworth
    Warwickshire
    BritishCompany Director46351440001
    CAMERON, Charles Donald Ewen
    Orchard Manor
    Church Lane Martin Hussingtree
    WR3 8TQ Worcester
    Worcestershire
    Director
    Orchard Manor
    Church Lane Martin Hussingtree
    WR3 8TQ Worcester
    Worcestershire
    EnglandBritishCompany Director113187140001
    DALE, Arthur Geoffrey
    Kimberley
    Poolhead Lane
    B94 5ED Tanworth In Arden Solihull
    West Midlands
    Director
    Kimberley
    Poolhead Lane
    B94 5ED Tanworth In Arden Solihull
    West Midlands
    BritishCompany Director10739820001
    KEEN, Michael
    Woodlee
    Hillberry Green
    IM2 6DE Douglas
    Isle Of Man
    Director
    Woodlee
    Hillberry Green
    IM2 6DE Douglas
    Isle Of Man
    BritishCompany Director83811650001
    SOWERBY, Stephen
    37 Brighouse Close
    L39 3NA Ormskirk
    Lancashire
    Director
    37 Brighouse Close
    L39 3NA Ormskirk
    Lancashire
    BritishFinancial Director26872320001
    SYKES, Hilary Claire
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive
    NG15 0DR Annesley Nottingham
    Nottinghamshire
    Director
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive
    NG15 0DR Annesley Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritishCompaany Secretary41559790001
    TEATUM, Richard
    Viking Lodge Ealand Outgate
    Ealand
    DN17 4JD Scunthorpe
    Director
    Viking Lodge Ealand Outgate
    Ealand
    DN17 4JD Scunthorpe
    BritishCompany Director9538630001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de T.K. MOTORS LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Evans Halshaw Motor Holdings Limited
    Little Oak Drive
    Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Loxley House
    England
    06 abr 2016
    Little Oak Drive
    Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Loxley House
    England
    No
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroEngland & Wales
    Número de registro1212182
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene T.K. MOTORS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A security agreement
    Creado el 13 may 2009
    Entregado el 21 may 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    For details of property charged please refer to form 395. fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent and Trustee for the Secured Parties (The Override Agent)
    Transacciones
    • 21 may 2009Registro de un cargo (395)
    • 07 may 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Transfer deed
    Creado el 03 sept 1993
    Entregado el 09 sept 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 09 sept 1993Registro de un cargo (395)
    • 16 nov 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Used vehicle charge
    Creado el 31 mar 1993
    Entregado el 02 abr 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Specific charge over all its interest in any used and unused vehicles under the terms of the used vehicle sale agreement dated 31/03/93.
    Personas con derecho
    • Psa Wholesale Limited
    Transacciones
    • 02 abr 1993Registro de un cargo (395)
    • 16 nov 1994Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 14 feb 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 03 dic 1991
    Entregado el 06 dic 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the debenture
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Shell U.K.
    Transacciones
    • 06 dic 1991Registro de un cargo (395)
    • 14 feb 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed
    Creado el 22 may 1991
    Entregado el 23 may 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    1) all the stock all 2) the dealers right title interest under the dealer agreement see form 395 m/70/l for full details.
    Personas con derecho
    • Psa Wholesale Limited
    Transacciones
    • 23 may 1991Registro de una carga
    • 16 nov 1994Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 14 feb 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge
    Creado el 22 may 1991
    Entregado el 23 may 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under ther terms of a consignment agreement dated 22/5/91 and/or this charge.
    Breve descripción
    All the chargors interest (if any) in any vehicle delivered to under the agreement.
    Personas con derecho
    • Psa Wholesale Limited
    Transacciones
    • 23 may 1991Registro de una carga
    • 16 nov 1994Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 14 feb 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 10 may 1991
    Entregado el 16 may 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transacciones
    • 16 may 1991Registro de una carga
    • 16 nov 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 10 may 1991
    Entregado el 14 may 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under ther terms of the charge
    Breve descripción
    The used vehicle stocks of the company.
    Personas con derecho
    • Chartered Trust PLC
    Transacciones
    • 14 may 1991Registro de una carga
    • 17 ago 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0