THE CARE AGENCY LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | THE CARE AGENCY LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 02568967 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de THE CARE AGENCY LIMITED?
- Actividades de las agencias de empleo temporal (78200) / Actividades administrativas y de apoyo
¿Dónde se encuentra THE CARE AGENCY LIMITED?
Dirección de la sede social | 1310 Solihull Parkway Birmingham Business Park B37 7YB Solihull Birmingham |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de THE CARE AGENCY LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2019 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para THE CARE AGENCY LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida | 1 páginas | SOAS(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 05 ene 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 mar 2019 | 12 páginas | AA | ||||||||||
Comptes modifiés pour une société dormante établis au 31 mar 2018 | 6 páginas | AAMD | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 05 ene 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas no auditadas abreviadas presentadas hasta el 31 mar 2018 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Notification de Mc Care Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 17 dic 2018 | 2 páginas | PSC02 | ||||||||||
Cessation de Mihomecare Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 17 dic 2018 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||
Notification de Mihomecare Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 18 oct 2018 | 2 páginas | PSC02 | ||||||||||
Cessation de Enara Finance Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 17 oct 2018 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Jonathan Vellacott como director el 12 sept 2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Narinder Singh como director el 12 sept 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Ford David Porter como director el 28 feb 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 05 ene 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas no auditadas abreviadas presentadas hasta el 31 mar 2017 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 1 Hawksworth Road Central Park Telford Shropshire TF2 9TU a 1310 Solihull Parkway Birmingham Business Park Solihull Birmingham B37 7YB el 06 jun 2017 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 13 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de Mitie Company Secretarial Services Limited como secretario el 28 feb 2017 | 2 páginas | TM02 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Colin Andrew Dobell como director el 28 feb 2017 | 2 páginas | TM01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 1 Harlequin Office Park, Fieldfare Emersons Green Bristol England BS16 7FN a 1 Hawksworth Road Central Park Telford Shropshire TF2 9TU el 09 mar 2017 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 05 ene 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2016 | 6 páginas | AA | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de THE CARE AGENCY LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAKER, Julianne | Director | Harlequin Office Park, Fieldfare Emersons Green BS16 7FN Bristol 1 England England | United Kingdom | British | Director | 192429900001 | ||||||||
PORTER, Ford David | Director | Solihull Parkway Birmingham Business Park B37 7YB Solihull 1310 Birmingham | England | British,American | Investment Manager | 235635120001 | ||||||||
VELLACOTT, Jonathan James | Director | Solihull Parkway Birmingham Business Park B37 7YB Solihull 1310 Birmingham | England | British | Executive Chairman | 250741990001 | ||||||||
CARVER, Judith Lynn | Secretario | 23 Abbots Close Knowle B93 9PP Solihull West Midlands | British | 14613120001 | ||||||||||
JACKSON, David | Secretario | 9-11 Church Street West GU21 6DJ Woking First Floor Church Gate Surrey United Kingdom | British | Finance Director | 280628560001 | |||||||||
ROBERTS, Pamela | Secretario | 1 Mill View LE9 3AY Huncote Leicestershire | British | 33867830002 | ||||||||||
TAYLOR, Christopher John | Secretario | Airedale Farm Main Street LE17 5HF Leire Leicestershire | British | 30905150002 | ||||||||||
MITIE COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | Harlequin Office Park, Fieldfare Emersons Green BS16 7FN Bristol 1 England England |
| 173216910001 | ||||||||||
BOOTY, Stephen Martin | Director | 9-11 Church Street West GU21 6DJ Woking First Floor Church Gate Surrey United Kingdom | England | British | Director | 147928010001 | ||||||||
CARVER, Michael Robert | Director | 23 Abbots Close Knowle B93 9PP Solihull West Midlands | British | Computer Manager | 14613130001 | |||||||||
DOBELL, Colin Andrew | Director | Hawksworth Road Central Park TF2 9TU Telford 1 Shropshire | England | British | Managing Director | 63959230003 | ||||||||
DUN, Andrew Frederick | Director | Monarch Court The Brooms Emersons Green BS16 7FH Bristol 8 | United Kingdom | British | Chief Executive Officer | 85855780002 | ||||||||
FELTON, Wayne Harold | Director | Harlequin Office Park, Fieldfare Emersons Green BS16 7FN Bristol 1 England England | United Kingdom | British | Director | 173205650001 | ||||||||
FLANAGAN, Jeffrey Paul | Director | Harlequin Office Park, Fieldfare Emersons Green BS16 7FN Bristol 1 England England | United Kingdom | British | Director | 50878080003 | ||||||||
GRAY, Susan Annette | Director | 9-11 Church Street West GU21 6DJ Woking First Floor Church Gate Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | Managing Director | 55858850004 | ||||||||
HARLAND, David Nicholas | Director | Monarch Court The Brooms BS16 7FH Bristol 8 England | England | British | Accountant | 173208950001 | ||||||||
JACKSON, David | Director | 9-11 Church Street West GU21 6DJ Woking First Floor Church Gate Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | Finance Director | 280628560001 | ||||||||
MANNAN, Rohit | Director | Monarch Court, The Brooms Emersons Green BS16 7FH Bristol 8 United Kingdom | England | British | Director | 181783660001 | ||||||||
ROBERTS, John | Director | 1 Mill View LE9 3AY Huncote Leicestershire | England | British | Accountant | 87050430001 | ||||||||
SINGH, Narinder | Director | Harlequin Office Park, Fieldfare Emersons Green BS16 7FN Bristol 1 England England | England | British | Managing Director | 193406470001 | ||||||||
STAUNTON, Martin | Director | Harlequin Office Park, Fieldfare Emersons Green BS16 7FN Bristol 1 England England | United Kingdom | British | Director | 192431160001 | ||||||||
STIRLAND, Patrick Walter | Director | Harlequin Office Park, Fieldfare Emersons Green BS16 7FN Bristol 1 England England | United Kingdom | British | Director | 69756530007 | ||||||||
TAYLOR, Christopher John | Director | Airedale Farm Main Street LE17 5HF Leire Leicestershire | United Kingdom | British | Company Director | 30905150002 | ||||||||
TAYLOR, Linda Christine | Director | Airedale Farm Main Street LE17 5HF Leire Leicestershire | United Kingdom | British | Employment Agent | 30628690002 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de THE CARE AGENCY LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mc Care Holdings Limited | 17 dic 2018 | Solihull Parkway Birmingham Business Park B37 7YB Birmingham 1310 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Mihomecare Limited | 18 oct 2018 | Solihull Parkway Birmingham Business Park B37 7YB Birmingham 1310 England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Enara Finance Limited | 06 abr 2016 | Harlequin Office Park, Fieldfare Emersons Green BS16 7FN Bristol 1 England England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene THE CARE AGENCY LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Creado el 08 abr 2009 Entregado el 15 abr 2009 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to any one or more of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0