BOWOOD PARTNERS LIMITED

BOWOOD PARTNERS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Declaraciones de personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaBOWOOD PARTNERS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02569473
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de BOWOOD PARTNERS LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra BOWOOD PARTNERS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    16 Eastcheap
    EC3M 1BD London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de BOWOOD PARTNERS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    GRIMSTON INSURANCE SERVICES LIMITED19 dic 199019 dic 1990

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de BOWOOD PARTNERS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 jun 2014

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para BOWOOD PARTNERS LIMITED?

    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta30 jun 2016

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para BOWOOD PARTNERS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Declaración de confirmación presentada el 30 jun 2016 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Estado de capital el 17 jun 2016

    • Capital: GBP 1
    4 páginasSH19

    legacy

    2 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Share premium a/c & other reserve be cancelled 27/05/2016
    RES13
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Retiro de la solicitud de exclusión de la empresa

    1 páginasDS02

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cese del nombramiento de Ian Richardson como director el 11 nov 2015

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 30 jun 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital28 jul 2015

    Estado de capital el 28 jul 2015

    • Capital: GBP 676,650.4
    SH01

    Nombramiento de William David Bloomer como director el 29 abr 2015

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Ian Richardson como director el 29 abr 2015

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Andrew Tuffield como director el 29 abr 2015

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Jonathan Mark Thompson-Copsey como director el 29 abr 2015

    1 páginasTM01

    Exercice comptable en cours prolongé du 30 jun 2015 au 30 sept 2015

    1 páginasAA01

    Domicilio social registrado cambiado de Woodlands Manton Lane Bedford Bedfordshire MK41 7LW a 16 Eastcheap London EC3M 1BD el 30 abr 2015

    1 páginasAD01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2014

    8 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 30 jun 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital21 jul 2014

    Estado de capital el 21 jul 2014

    • Capital: GBP 676,650.4
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2013

    8 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 30 jun 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital23 jul 2013

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 23 jul 2013

    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2012

    9 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 30 jun 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    ¿Quiénes son los directivos de BOWOOD PARTNERS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MOORE, Andrew John
    Eastcheap
    EC3M 1BD London
    16
    United Kingdom
    Secretario
    Eastcheap
    EC3M 1BD London
    16
    United Kingdom
    British133845040001
    BLOOMER, William David
    Eastcheap
    EC3M 1BD London
    16
    United Kingdom
    Director
    Eastcheap
    EC3M 1BD London
    16
    United Kingdom
    United KingdomBritish72374560002
    GRIMSTON, Katherine
    The Old Rectory
    MK18 4AR Finmere
    Bucks
    Secretario
    The Old Rectory
    MK18 4AR Finmere
    Bucks
    British23550560001
    HATHAWAY, Rodney Francis
    Boxted Church Road
    Great Horkesley
    CO6 4AL Colchester
    Elmdene
    Essex
    Secretario
    Boxted Church Road
    Great Horkesley
    CO6 4AL Colchester
    Elmdene
    Essex
    British61813590002
    TRILLO, David John
    45 Ellington Street
    N7 8PN London
    Secretario
    45 Ellington Street
    N7 8PN London
    British14014360001
    WHITING, Andrew Michael John
    14 Buckden Road
    Brampton
    PE28 4PS Huntingdon
    Cambridgeshire
    Secretario
    14 Buckden Road
    Brampton
    PE28 4PS Huntingdon
    Cambridgeshire
    British38444620001
    ALBON, Philip Ian
    Manton Lane
    MK41 7LW Bedford
    Woodlands
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Director
    Manton Lane
    MK41 7LW Bedford
    Woodlands
    Bedfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish53364690001
    ANGEL, Alan Paul
    26 Northwick Circle
    HA3 0EE Harrow
    Middlesex
    Director
    26 Northwick Circle
    HA3 0EE Harrow
    Middlesex
    United KingdomBritish39825440002
    ANGEL, Alan Paul
    9 Aston Avenue
    HA3 0DB Harrow
    Middlesex
    Director
    9 Aston Avenue
    HA3 0DB Harrow
    Middlesex
    British39825440001
    ARNOLD, David John Middleton
    Flat 308
    Gilbert House
    EC2Y 8BD Barbican
    London
    Director
    Flat 308
    Gilbert House
    EC2Y 8BD Barbican
    London
    British36584410002
    ARNOLD, David John Middleton
    Abbotshay Cottage
    Ayot St Lawrence
    AL6 9BS St Albans
    Hertfordshire
    Director
    Abbotshay Cottage
    Ayot St Lawrence
    AL6 9BS St Albans
    Hertfordshire
    British36584410001
    BARNES, Paul
    Shafford Mill
    Childwick Bury
    AL3 6LB St Albans
    Hertfordshire
    Director
    Shafford Mill
    Childwick Bury
    AL3 6LB St Albans
    Hertfordshire
    EnglandEnglish32833320001
    BONIFACE, Michael John Owen
    Rashleigh Horton Road
    Horton
    DA49 BN Kirby
    Kent
    Director
    Rashleigh Horton Road
    Horton
    DA49 BN Kirby
    Kent
    United KingdomBritish207125910001
    BRIDGWATER, Paul Charles
    Manton Lane
    MK41 7LW Bedford
    Woodlands
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Director
    Manton Lane
    MK41 7LW Bedford
    Woodlands
    Bedfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish87505170002
    BRIDGWATER, Paul Charles
    Manton Lane
    MK41 7LW Bedford
    Woodlands
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Director
    Manton Lane
    MK41 7LW Bedford
    Woodlands
    Bedfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish87505170002
    CAVAZZI, Gary Mark
    Wedgwood Knowl Hill
    The Hockering
    GU22 7HL Woking
    Surrey
    Director
    Wedgwood Knowl Hill
    The Hockering
    GU22 7HL Woking
    Surrey
    United KingdomUsa27090250002
    COLLINS, Andrew Dominic John Bucke
    Adlestrop
    GL56 0YN Moreton In Marsh
    Adlestrop Park
    Gloucestershire
    Director
    Adlestrop
    GL56 0YN Moreton In Marsh
    Adlestrop Park
    Gloucestershire
    United KingdomBritish139705290001
    COUGHLIN, Alan Alfred
    17 Lampern Crescent
    CM12 0FE Billericay
    Essex
    Director
    17 Lampern Crescent
    CM12 0FE Billericay
    Essex
    British61617320001
    CURITZ, Maurice Anthony
    Holts Barn Holt Road
    Little Horkesley
    CO6 4DR Colchester
    Essex
    Director
    Holts Barn Holt Road
    Little Horkesley
    CO6 4DR Colchester
    Essex
    British14791280001
    FAGG, Paul John
    24 Doves Croft
    Tunstall
    ME9 8LQ Sittingbourne
    Kent
    Director
    24 Doves Croft
    Tunstall
    ME9 8LQ Sittingbourne
    Kent
    United KingdomBritish48990790002
    GAYTON, Ashley Vivian
    The Paddocks
    Lower Road Peldon
    CO5 7PR Colchester
    Essex
    Director
    The Paddocks
    Lower Road Peldon
    CO5 7PR Colchester
    Essex
    British91623980002
    GINGELL, Timothy
    20 Dorking Road
    KT18 7LX Epsom
    Surrey
    Director
    20 Dorking Road
    KT18 7LX Epsom
    Surrey
    British50905970002
    GREENER, Stephen Thomas
    Ash Farm House Gravel Lane
    Barton Stacey
    SO21 3RL Winchester
    Hampshire
    Director
    Ash Farm House Gravel Lane
    Barton Stacey
    SO21 3RL Winchester
    Hampshire
    United KingdomBritish55748330003
    GRIMSTON, Gerald Charles Walter, The Hon
    The Old Rectory
    MK18 4AR Finmere
    Buckinghamshire
    Director
    The Old Rectory
    MK18 4AR Finmere
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish12430760001
    HUDSON, John Henry
    Strawberry Fields Long Mill Lane
    Crouch Borough Green
    TN15 8QB Sevenoaks
    Kent
    Director
    Strawberry Fields Long Mill Lane
    Crouch Borough Green
    TN15 8QB Sevenoaks
    Kent
    EnglandBritish104588370001
    JEWERS, David John
    Corner Cottage Howe Street
    Great Waltham
    CM3 1BS Chelmsford
    Essex
    Director
    Corner Cottage Howe Street
    Great Waltham
    CM3 1BS Chelmsford
    Essex
    United KingdomBritish113199070001
    MITCHELL, Adrian Edward Michael
    44 Stormont Road
    Battersea
    SW11 5EL London
    Director
    44 Stormont Road
    Battersea
    SW11 5EL London
    British37610700001
    OVENS, Michael John Meyrick
    15 Criffel Avenue
    SW2 4AY London
    Director
    15 Criffel Avenue
    SW2 4AY London
    British14990390002
    REED, David Michael
    Manton Lane
    MK41 7LW Bedford
    Woodlands
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Director
    Manton Lane
    MK41 7LW Bedford
    Woodlands
    Bedfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish159470820001
    RICHARDSON, Ian
    Eastcheap
    EC3M 1BD London
    16
    United Kingdom
    Director
    Eastcheap
    EC3M 1BD London
    16
    United Kingdom
    United KingdomBritish197592500001
    STANCIK, John David
    259 Mayflower Road
    Lake Forest
    Illinois 60045
    America
    Director
    259 Mayflower Road
    Lake Forest
    Illinois 60045
    America
    American42367650002
    THOMPSON-COPSEY, Jonathan Mark
    EC3V 1LE London
    One Whittington Avenue
    England
    Director
    EC3V 1LE London
    One Whittington Avenue
    England
    EnglandBritish146513890002
    TOWNSEND, Philip Michael
    80 Sandford Road
    BR2 9AN Bromley
    Kent
    Director
    80 Sandford Road
    BR2 9AN Bromley
    Kent
    British40919720002
    TRILLO, David John
    45 Ellington Street
    N7 8PN London
    Director
    45 Ellington Street
    N7 8PN London
    EnglandBritish14014360001
    TUFFIELD, Andrew
    114 Cardamom Building
    31 Shad Thames
    SE1 2YR London
    Director
    114 Cardamom Building
    31 Shad Thames
    SE1 2YR London
    United KingdomBritish56383230001

    ¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para BOWOOD PARTNERS LIMITED?

    Declaraciones de personas con control significativo
    Notificado elCesado elDeclaración
    30 jun 2016La empresa aún no ha completado las medidas razonables para determinar si existe alguna persona que sea una persona registrable o una entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa.

    ¿Tiene BOWOOD PARTNERS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Accession deed
    Creado el 17 oct 2008
    Entregado el 23 oct 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 23 oct 2008Registro de un cargo (395)
    • 10 mar 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 28 mar 2007
    Entregado el 07 abr 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 07 abr 2007Registro de un cargo (395)
    • 17 feb 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 21 jun 2006
    Entregado el 05 jul 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Equitable mortgage of land acquired since 28 april 2005 or to be acquired in future. Fixed charge of plant and machinery, goodwill, rights and interest in intellectual property, uncalled share capital, rights and interest in shares and other securities and in contracts. Floating charge of all property and undertaking.. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Cccc Growth Fund, L.L.C.
    Transacciones
    • 05 jul 2006Registro de un cargo (395)
    • 03 abr 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 20 jun 2006
    Entregado el 30 jun 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 30 jun 2006Registro de un cargo (395)
    • 27 jun 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of variation (made in addition to and modifying the security and trust deed dated 6 october 1997 the "principal deed"))
    Creado el 19 nov 1999
    Entregado el 24 nov 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    The payment of all costs charges expenses and other liabilities properly incurred by the chargee its delegates or agents or any receiver appointed under the security and trust deed in or about the exercise of the powers contained in the security and trust deed (as modified) or otherwise in relation thereto including all remuneration payable to any such receiver and the payment of all debts and obligations for the time being due owing or incurred whether actually or contingently by the company in respect of insurance transactions
    Breve descripción
    All monies (including brokerage) for the time being standing to the credit of or pursuant to the byelaw or otherwise required to be paid into an insurance broking account of the company and all approved iba assets of the company (and all assets which would be approved).
    Personas con derecho
    • Lloyd's (A Statutory Corporation)(as Trustee for the Creditors for the Time Being of the Company in Respect of Insurance Transactions)
    Transacciones
    • 24 nov 1999Registro de un cargo (395)
    • 27 may 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Trust deed
    Creado el 06 oct 1997
    Entregado el 08 oct 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    As required by lloyd's brokers byelaw (no 5 of 1988) the company has entered into a trust deed under which all insurance broking account assets are subject to a floating charge held on trust by the society of lloyd's for the benefit of the insurance creditors.
    Personas con derecho
    • The Society of Lloyd's
    Transacciones
    • 08 oct 1997Registro de un cargo (395)
    • 23 ago 2000Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 27 may 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0