BOWOOD PARTNERS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | BOWOOD PARTNERS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02569473 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de BOWOOD PARTNERS LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra BOWOOD PARTNERS LIMITED?
| Dirección de la sede social | 16 Eastcheap EC3M 1BD London |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de BOWOOD PARTNERS LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| GRIMSTON INSURANCE SERVICES LIMITED | 19 dic 1990 | 19 dic 1990 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de BOWOOD PARTNERS LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 jun 2014 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para BOWOOD PARTNERS LIMITED?
| Última declaración de confirmación | |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 30 jun 2016 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para BOWOOD PARTNERS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 30 jun 2016 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Estado de capital el 17 jun 2016
| 4 páginas | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 2 páginas | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 3 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Retiro de la solicitud de exclusión de la empresa | 1 páginas | DS02 | ||||||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Ian Richardson como director el 11 nov 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 30 jun 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nombramiento de William David Bloomer como director el 29 abr 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Ian Richardson como director el 29 abr 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Andrew Tuffield como director el 29 abr 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Jonathan Mark Thompson-Copsey como director el 29 abr 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Exercice comptable en cours prolongé du 30 jun 2015 au 30 sept 2015 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Woodlands Manton Lane Bedford Bedfordshire MK41 7LW a 16 Eastcheap London EC3M 1BD el 30 abr 2015 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2014 | 8 páginas | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 30 jun 2014 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2013 | 8 páginas | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 30 jun 2013 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2012 | 9 páginas | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 30 jun 2012 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de BOWOOD PARTNERS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOORE, Andrew John | Secretario | Eastcheap EC3M 1BD London 16 United Kingdom | British | 133845040001 | ||||||
| BLOOMER, William David | Director | Eastcheap EC3M 1BD London 16 United Kingdom | United Kingdom | British | 72374560002 | |||||
| GRIMSTON, Katherine | Secretario | The Old Rectory MK18 4AR Finmere Bucks | British | 23550560001 | ||||||
| HATHAWAY, Rodney Francis | Secretario | Boxted Church Road Great Horkesley CO6 4AL Colchester Elmdene Essex | British | 61813590002 | ||||||
| TRILLO, David John | Secretario | 45 Ellington Street N7 8PN London | British | 14014360001 | ||||||
| WHITING, Andrew Michael John | Secretario | 14 Buckden Road Brampton PE28 4PS Huntingdon Cambridgeshire | British | 38444620001 | ||||||
| ALBON, Philip Ian | Director | Manton Lane MK41 7LW Bedford Woodlands Bedfordshire United Kingdom | England | British | 53364690001 | |||||
| ANGEL, Alan Paul | Director | 26 Northwick Circle HA3 0EE Harrow Middlesex | United Kingdom | British | 39825440002 | |||||
| ANGEL, Alan Paul | Director | 9 Aston Avenue HA3 0DB Harrow Middlesex | British | 39825440001 | ||||||
| ARNOLD, David John Middleton | Director | Flat 308 Gilbert House EC2Y 8BD Barbican London | British | 36584410002 | ||||||
| ARNOLD, David John Middleton | Director | Abbotshay Cottage Ayot St Lawrence AL6 9BS St Albans Hertfordshire | British | 36584410001 | ||||||
| BARNES, Paul | Director | Shafford Mill Childwick Bury AL3 6LB St Albans Hertfordshire | England | English | 32833320001 | |||||
| BONIFACE, Michael John Owen | Director | Rashleigh Horton Road Horton DA49 BN Kirby Kent | United Kingdom | British | 207125910001 | |||||
| BRIDGWATER, Paul Charles | Director | Manton Lane MK41 7LW Bedford Woodlands Bedfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 87505170002 | |||||
| BRIDGWATER, Paul Charles | Director | Manton Lane MK41 7LW Bedford Woodlands Bedfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 87505170002 | |||||
| CAVAZZI, Gary Mark | Director | Wedgwood Knowl Hill The Hockering GU22 7HL Woking Surrey | United Kingdom | Usa | 27090250002 | |||||
| COLLINS, Andrew Dominic John Bucke | Director | Adlestrop GL56 0YN Moreton In Marsh Adlestrop Park Gloucestershire | United Kingdom | British | 139705290001 | |||||
| COUGHLIN, Alan Alfred | Director | 17 Lampern Crescent CM12 0FE Billericay Essex | British | 61617320001 | ||||||
| CURITZ, Maurice Anthony | Director | Holts Barn Holt Road Little Horkesley CO6 4DR Colchester Essex | British | 14791280001 | ||||||
| FAGG, Paul John | Director | 24 Doves Croft Tunstall ME9 8LQ Sittingbourne Kent | United Kingdom | British | 48990790002 | |||||
| GAYTON, Ashley Vivian | Director | The Paddocks Lower Road Peldon CO5 7PR Colchester Essex | British | 91623980002 | ||||||
| GINGELL, Timothy | Director | 20 Dorking Road KT18 7LX Epsom Surrey | British | 50905970002 | ||||||
| GREENER, Stephen Thomas | Director | Ash Farm House Gravel Lane Barton Stacey SO21 3RL Winchester Hampshire | United Kingdom | British | 55748330003 | |||||
| GRIMSTON, Gerald Charles Walter, The Hon | Director | The Old Rectory MK18 4AR Finmere Buckinghamshire | United Kingdom | British | 12430760001 | |||||
| HUDSON, John Henry | Director | Strawberry Fields Long Mill Lane Crouch Borough Green TN15 8QB Sevenoaks Kent | England | British | 104588370001 | |||||
| JEWERS, David John | Director | Corner Cottage Howe Street Great Waltham CM3 1BS Chelmsford Essex | United Kingdom | British | 113199070001 | |||||
| MITCHELL, Adrian Edward Michael | Director | 44 Stormont Road Battersea SW11 5EL London | British | 37610700001 | ||||||
| OVENS, Michael John Meyrick | Director | 15 Criffel Avenue SW2 4AY London | British | 14990390002 | ||||||
| REED, David Michael | Director | Manton Lane MK41 7LW Bedford Woodlands Bedfordshire United Kingdom | England | British | 159470820001 | |||||
| RICHARDSON, Ian | Director | Eastcheap EC3M 1BD London 16 United Kingdom | United Kingdom | British | 197592500001 | |||||
| STANCIK, John David | Director | 259 Mayflower Road Lake Forest Illinois 60045 America | American | 42367650002 | ||||||
| THOMPSON-COPSEY, Jonathan Mark | Director | EC3V 1LE London One Whittington Avenue England | England | British | 146513890002 | |||||
| TOWNSEND, Philip Michael | Director | 80 Sandford Road BR2 9AN Bromley Kent | British | 40919720002 | ||||||
| TRILLO, David John | Director | 45 Ellington Street N7 8PN London | England | British | 14014360001 | |||||
| TUFFIELD, Andrew | Director | 114 Cardamom Building 31 Shad Thames SE1 2YR London | United Kingdom | British | 56383230001 |
¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para BOWOOD PARTNERS LIMITED?
| Notificado el | Cesado el | Declaración |
|---|---|---|
| 30 jun 2016 | La empresa aún no ha completado las medidas razonables para determinar si existe alguna persona que sea una persona registrable o una entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa. |
¿Tiene BOWOOD PARTNERS LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Accession deed | Creado el 17 oct 2008 Entregado el 23 oct 2008 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 28 mar 2007 Entregado el 07 abr 2007 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 21 jun 2006 Entregado el 05 jul 2006 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Breve descripción Equitable mortgage of land acquired since 28 april 2005 or to be acquired in future. Fixed charge of plant and machinery, goodwill, rights and interest in intellectual property, uncalled share capital, rights and interest in shares and other securities and in contracts. Floating charge of all property and undertaking.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 20 jun 2006 Entregado el 30 jun 2006 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Deed of variation (made in addition to and modifying the security and trust deed dated 6 october 1997 the "principal deed")) | Creado el 19 nov 1999 Entregado el 24 nov 1999 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada The payment of all costs charges expenses and other liabilities properly incurred by the chargee its delegates or agents or any receiver appointed under the security and trust deed in or about the exercise of the powers contained in the security and trust deed (as modified) or otherwise in relation thereto including all remuneration payable to any such receiver and the payment of all debts and obligations for the time being due owing or incurred whether actually or contingently by the company in respect of insurance transactions | |
Breve descripción All monies (including brokerage) for the time being standing to the credit of or pursuant to the byelaw or otherwise required to be paid into an insurance broking account of the company and all approved iba assets of the company (and all assets which would be approved). | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Trust deed | Creado el 06 oct 1997 Entregado el 08 oct 1997 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción As required by lloyd's brokers byelaw (no 5 of 1988) the company has entered into a trust deed under which all insurance broking account assets are subject to a floating charge held on trust by the society of lloyd's for the benefit of the insurance creditors. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0