EMAP CONNECT LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | EMAP CONNECT LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02571197 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de EMAP CONNECT LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra EMAP CONNECT LIMITED?
| Dirección de la sede social | Greater London House Hampstead Road NW1 7EJ London United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de EMAP CONNECT LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| EMAP DORMANT 4 LIMITED | 09 dic 2005 | 09 dic 2005 |
| MIXMAG HOLDINGS LIMITED | 06 dic 1996 | 06 dic 1996 |
| DISCO MIX CLUB HOLDINGS LIMITED | 02 ene 1991 | 02 ene 1991 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de EMAP CONNECT LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2010 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para EMAP CONNECT LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Emily Henrietta Gestetner como director el 29 jun 2012 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Nombramiento de John Keith Gulliver como director el 11 jun 2012 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||||||
Cambio de datos del director Mr Duncan Anthony Painter el 02 abr 2012 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 31 mar 2012 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nombramiento de Mr Duncan Anthony Painter como director el 22 dic 2011 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Martyn John Hindley como director el 22 dic 2011 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2010 | 2 páginas | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 31 mar 2011 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Christopher Taylor como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 30 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cambio de datos del director Martyn John Hindley el 30 sept 2010 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2009 | 2 páginas | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 31 mar 2010 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||||||
Cambio de datos del secretario Ms Shanny Looi el 01 mar 2010 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Helen Hay como secretario | 1 páginas | TM02 | ||||||||||||||
Nombramiento de Helen Frances Hay como secretario | 1 páginas | AP03 | ||||||||||||||
Cambio de datos del director Christopher Nigel John Taylor el 01 mar 2010 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Cambio de datos del director Martyn John Hindley el 01 mar 2010 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Cambio de datos del director Emily Henrietta Gestetner el 01 mar 2010 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2009 | 2 páginas | AA | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | 225 | ||||||||||||||
legacy | 2 páginas | 288a | ||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de EMAP CONNECT LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOOI, Shanny | Secretario | Hampstead Road NW1 7EJ London Greater London House United Kingdom | British | 129906110001 | ||||||
| GULLIVER, John Keith | Director | Hampstead Road NW1 7EJ London Greater London House United Kingdom | United Kingdom | British | 170112360001 | |||||
| PAINTER, Duncan Anthony | Director | Hampstead Road NW1 7EJ London Greater London House United Kingdom | England | British | 132649960001 | |||||
| ANDERS, Philip William | Secretario | 5 Fitzwilliams Court Greatford PE9 4QQ Stamford Lincolnshire | British | 42645630003 | ||||||
| ELSDON, Kate | Secretario | 51 Sackville Crescent Harold Wood RM3 0EH Romford Essex | British | 107227940002 | ||||||
| GILES, Nicholas David Martin | Secretario | 8 Pyms Gardens Abbotsley PE19 6UR St Neots Cambs | British | 85529870001 | ||||||
| HAY, Helen Frances | Secretario | Odell MK43 7BB Bedford The Old Stable Yard Bedfordshire | 149594140001 | |||||||
| HENSON, Mark Richard | Secretario | 5 Hazeland Steading PE10 0PW Morton Lincolnshire | British | 104630800001 | ||||||
| HOGG, Marianne Lisa | Secretario | 43b Norroy Road Putney SW15 1PQ London | British | 101383970001 | ||||||
| LEES, Barbara | Secretario | Milford Street CB1 2LP Cambridge 15a Cambridgeshire | Other | 79614280001 | ||||||
| NAREBOR, Torugbene Eniyekeye | Secretario | 10 Portland Road ME7 2NP Gillingham Kent | British | 120147010002 | ||||||
| WALMSLEY, Derek Kerr | Secretario | Sennen Grange Road MK43 7EU Felmersham North Bedfordshire | British | 16754910001 | ||||||
| HS (NOMINEES) LIMITED | Secretario corporativo | Carinya Tudor Road EN5 5NL New Barnet Hertfordshire | 38715900003 | |||||||
| ANDERS, Philip William | Director | 5 Fitzwilliams Court Greatford PE9 4QQ Stamford Lincolnshire | England | British | 42645630003 | |||||
| BHAKTA-JONES, Nilema | Director | 7b Wolseley Road N8 8RR London | United Kingdom | British | 124888590001 | |||||
| COLE, Christopher Michael | Director | Lucas Avenue HA2 9JU Harrow 30 Middlesex England | United Kingdom | British | 133510510001 | |||||
| ELSDON, Kate | Director | 51 Sackville Crescent Harold Wood RM3 0EH Romford Essex | British | 107227940002 | ||||||
| FOLLAND, Nicholas James | Director | Strethall House Strethall CB11 4XJ Saffron Walden Essex | United Kingdom | British | 73711450003 | |||||
| GESTETNER, Emily Henrietta | Director | Hampstead Road NW1 7EJ London Greater London House United Kingdom | United Kingdom | British | 138386390001 | |||||
| GILES, Nicholas David Martin | Director | 8 Pyms Gardens Abbotsley PE19 6UR St Neots Cambs | British | 85529870001 | ||||||
| HENSON, Mark Richard | Director | 5 Hazeland Steading PE10 0PW Morton Lincolnshire | United Kingdom | British | 104630800001 | |||||
| HINDLEY, Martyn John | Director | Hampstead Road NW1 7EJ London Greater London House United Kingdom | England | British | 134332760002 | |||||
| HOGG, Marianne Lisa | Director | 15 Roskell Road SW15 1DS London | British | 101383970002 | ||||||
| LAVELLI, John Stephen | Director | 2 Nathans Close AL6 9QB Welwyn Hertfordshire | British | 56438160001 | ||||||
| MOLONEY, Thomas Charles | Director | 20 Queen Elizabeths Walk N16 0HX London | United Kingdom | British | 15672060004 | |||||
| NAREBOR, Torugbene Eniyekeye | Director | 10 Portland Road ME7 2NP Gillingham Kent | British | 120147010002 | ||||||
| PHILLIPS, Alison Barbara | Director | The Gatehouse 1 Rhymers Gate Wyton PE17 2JR Huntingdon | Uk | British | 61837750001 | |||||
| TAYLOR, Christopher Nigel John | Director | Hampstead Road NW1 7EJ London Greater London House United Kingdom | British | 130943020001 | ||||||
| WALMSLEY, Derek Kerr | Director | High Street Pavenham MK43 7NJ Bedford Walnut Barn Bedfordshire | England | British | 135181230001 | |||||
| WHITEHEAD, Christine | Director | Cut Heath House Parsonage Lane SL2 3PA Farnham Common Buckinghamshire | British | 3277810003 | ||||||
| WHITEHOUSE, Thomas Richard | Director | Cut Heath House Parsonage Lane Farnham Common SL2 3PA Slough Buckinghamshire | British | 58982570001 |
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0