THE KEEP MOTOR GROUP (EPSOM) LIMITED

THE KEEP MOTOR GROUP (EPSOM) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaTHE KEEP MOTOR GROUP (EPSOM) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02574080
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de THE KEEP MOTOR GROUP (EPSOM) LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra THE KEEP MOTOR GROUP (EPSOM) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    11 Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link Clifton Moor
    YO30 4XG York
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de THE KEEP MOTOR GROUP (EPSOM) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    CARTOW LIMITED16 ene 199116 ene 1991

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de THE KEEP MOTOR GROUP (EPSOM) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2011

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para THE KEEP MOTOR GROUP (EPSOM) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    8 páginas4.71

    Domicilio social registrado cambiado de C/O Arriva Plc 1 Admiral Way Doxford International Business Park Sunderland SR3 3XP el 14 sept 2012

    2 páginasAD01

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 04 sept 2012

    LRESSP

    Cese del nombramiento de Martin James Hibbert como director el 28 ago 2012

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2011

    6 páginasAA

    Cambio de datos del secretario Ms Elizabeth Anne Thorpe el 26 may 2012

    1 páginasCH03

    Déclaration annuelle établie au 02 nov 2011 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital03 nov 2011

    Estado de capital el 03 nov 2011

    • Capital: GBP 400,002
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2010

    6 páginasAA

    Nombramiento de Kenneth Mcintyre Carlaw como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de David Turner como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Martin James Hibbert como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Stephen Lonsdale como director

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 02 nov 2010 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01

    Cambio de datos del director Stephen Philip Lonsdale el 02 nov 2010

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr David Paul Turner el 02 nov 2010

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del secretario Ms Elizabeth Anne Thorpe el 02 nov 2010

    1 páginasCH03

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2009

    6 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 02 nov 2009

    14 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2008

    6 páginasAA

    legacy

    4 páginas363a

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2007

    6 páginasAA

    legacy

    3 páginas363a

    ¿Quiénes son los directivos de THE KEEP MOTOR GROUP (EPSOM) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    DAVIES, Elizabeth Anne
    C/O Arriva Plc
    1 Admiral Way Doxford
    SR3 3XP International Business Park
    Sunderland
    Secretario
    C/O Arriva Plc
    1 Admiral Way Doxford
    SR3 3XP International Business Park
    Sunderland
    British102907000002
    CARLAW, Kenneth Mcintyre
    Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link Clifton Moor
    YO30 4XG York
    11
    Director
    Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link Clifton Moor
    YO30 4XG York
    11
    EnglandBritishCompany Secretary161250030001
    SEAR MAYES, David
    25 Carisbrooke Road
    Mountsorrel
    LE12 7BR Loughborough
    Leicestershire
    Secretario
    25 Carisbrooke Road
    Mountsorrel
    LE12 7BR Loughborough
    Leicestershire
    British10555810001
    THORPE, Elizabeth Anne
    2 Oakwood
    DH7 0NP Lanchester
    County Durham
    Secretario
    2 Oakwood
    DH7 0NP Lanchester
    County Durham
    British102907000001
    TURNER, David Paul
    139 Eastern Way Darras Hall
    Ponteland
    NE20 9RH Newcastle Upon Tyne
    Secretario
    139 Eastern Way Darras Hall
    Ponteland
    NE20 9RH Newcastle Upon Tyne
    BritishSecretary48937720001
    VIRTUE, John
    91 Hollywood Avenue
    Gosforth
    NE3 5BU Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Secretario
    91 Hollywood Avenue
    Gosforth
    NE3 5BU Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British102404840001
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Secretario designado corporativo
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    BELL, Joseph
    Highup 52 Binns Lane
    Holmfirth
    HD7 1BJ Huddersfield
    West Yorkshire
    Director
    Highup 52 Binns Lane
    Holmfirth
    HD7 1BJ Huddersfield
    West Yorkshire
    BritishExecutive16822660001
    CLARKSON, Christopher
    57 Henbury Road
    Westbury-On-Trym
    BS9 3NP Bristol
    Avon
    Director
    57 Henbury Road
    Westbury-On-Trym
    BS9 3NP Bristol
    Avon
    United KingdomBritishExecutive84819430001
    COWIE, Thomas, Sir
    Broadwood Hall
    DH7 0TD Lanchester
    County Durham
    Director
    Broadwood Hall
    DH7 0TD Lanchester
    County Durham
    United KingdomBritishCompany Director142033700001
    DAVISON, Gerald Richard
    Oak Farm
    Butchers Lane
    TA7 9LY Shapwick
    Somerset
    Director
    Oak Farm
    Butchers Lane
    TA7 9LY Shapwick
    Somerset
    BritishBusiness Consultant37548680001
    HIBBERT, Martin James
    C/O Arriva Plc
    1 Admiral Way Doxford
    SR3 3XP International Business Park
    Sunderland
    Director
    C/O Arriva Plc
    1 Admiral Way Doxford
    SR3 3XP International Business Park
    Sunderland
    EnglandBritishChartered Accountant111092090001
    HODGSON, Gordon William
    Bramble House
    Easington Lane
    DH5 0QX Houghton Le Spring
    Tyne & Wear
    Director
    Bramble House
    Easington Lane
    DH5 0QX Houghton Le Spring
    Tyne & Wear
    BritishChartered Accountant1108360001
    JANE, Iain Stewart
    The Folly 53 Barmpton Lane
    DL1 3HH Darlington
    County Durham
    Director
    The Folly 53 Barmpton Lane
    DL1 3HH Darlington
    County Durham
    BritishDirector45241110001
    LONSDALE, Stephen Philip
    C/O Arriva Plc
    1 Admiral Way Doxford
    SR3 3XP International Business Park
    Sunderland
    Director
    C/O Arriva Plc
    1 Admiral Way Doxford
    SR3 3XP International Business Park
    Sunderland
    United KingdomBritishChartered Accountant4971910001
    O'HAGAN, Leonard John Patrick
    Moyallen
    11 Elton Park
    IRISH Sandycove
    County Dublin
    Ireland
    Director
    Moyallen
    11 Elton Park
    IRISH Sandycove
    County Dublin
    Ireland
    IrishCompany Director15365240001
    PYKETT, Terrance Neil
    Humblebee Hall
    WR7 4PF North Piddle
    Worcestershire
    Director
    Humblebee Hall
    WR7 4PF North Piddle
    Worcestershire
    EnglandBritishCompany Director8804520002
    RAY, John Alfred
    50 The Gables
    Sedgefield
    TS21 3EU Stockton On Tees
    Cleveland
    Director
    50 The Gables
    Sedgefield
    TS21 3EU Stockton On Tees
    Cleveland
    BritishCompany Director58415290001
    SEAR MAYES, David
    25 Carisbrooke Road
    Mountsorrel
    LE12 7BR Loughborough
    Leicestershire
    Director
    25 Carisbrooke Road
    Mountsorrel
    LE12 7BR Loughborough
    Leicestershire
    BritishExecutive10555810001
    TURNER, David Paul
    C/O Arriva Plc
    1 Admiral Way Doxford
    SR3 3XP International Business Park
    Sunderland
    Director
    C/O Arriva Plc
    1 Admiral Way Doxford
    SR3 3XP International Business Park
    Sunderland
    United KingdomBritishChartered Secretary48937720001
    LONDON LAW SERVICES LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Director designado corporativo
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001500001

    ¿Tiene THE KEEP MOTOR GROUP (EPSOM) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Deed of charge
    Creado el 25 mar 1994
    Entregado el 07 abr 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    First fixed charge all book debts and other debts now and from time to time due or owing to the company. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 07 abr 1994Registro de un cargo (395)
    • 21 abr 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of charge
    Creado el 28 may 1993
    Entregado el 17 jun 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed charge all book debts and other debts now and from time to time due or owing to the company. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 17 jun 1993Registro de un cargo (395)
    • 23 jun 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Floating charge
    Creado el 28 may 1993
    Entregado el 17 jun 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Floating charge over all the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 17 jun 1993Registro de un cargo (395)
    • 21 abr 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene THE KEEP MOTOR GROUP (EPSOM) LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    08 abr 2013Fecha de disolución
    04 sept 2012Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Andrew Timothy Clay
    11 Clifton Moor Business Village James Nicholson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    Profesional
    11 Clifton Moor Business Village James Nicholson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    Rob Sadler
    Begbies Traynor (Central) Llp 11 Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link, Clifton Moor
    YO30 4XG York
    Profesional
    Begbies Traynor (Central) Llp 11 Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link, Clifton Moor
    YO30 4XG York

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0