IMAGO 2014 LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaIMAGO 2014 LIMITED
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02575558
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de IMAGO 2014 LIMITED?

    • Comercio al por mayor de equipos y componentes electrónicos y de telecomunicaciones (46520) / Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas

    ¿Dónde se encuentra IMAGO 2014 LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Odyssey Westridge
    Highclere
    RG20 9PX Newbury
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de IMAGO 2014 LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    IMAGO 2014 PLC19 sept 201419 sept 2014
    IMAGO GROUP PLC05 mar 200405 mar 2004
    IMAGO MICRO LIMITED10 jul 199110 jul 1991
    DIPLEMA 245 LIMITED21 ene 199121 ene 1991

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de IMAGO 2014 LIMITED?

    Vencido
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el30 sept 2020
    Próximas cuentas vencen el30 jun 2021
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 sept 2019

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para IMAGO 2014 LIMITED?

    Vencido
    Última declaración de confirmación cerrada hasta21 ene 2020
    Próxima declaración de confirmación vence04 feb 2020
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta21 ene 2019
    Vencido

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para IMAGO 2014 LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Restauración por orden judicial

    4 páginasAC92

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida

    1 páginasSOAS(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cuentas de microempresa preparadas hasta el 30 sept 2019

    2 páginasAA

    Cuentas de microempresa preparadas hasta el 30 sept 2018

    2 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 21 ene 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 sept 2017

    5 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 21 ene 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cambio de datos del secretario Mrs Kay Vickerage el 12 dic 2017

    1 páginasCH03

    Domicilio social registrado cambiado de "Genesis" Snelsmore Common Newbury RG14 3BG England a Odyssey Westridge Highclere Newbury RG20 9PX el 12 dic 2017

    1 páginasAD01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 30 sept 2016

    3 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 21 ene 2017 con actualizaciones

    6 páginasCS01

    Cuentas consolidadas preparadas hasta el 30 sept 2015

    25 páginasAA

    Nombramiento de Mrs Kay Vickerage como director el 01 abr 2016

    2 páginasAP01

    Déclaration annuelle établie au 21 ene 2016 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital26 ene 2016

    Estado de capital el 26 ene 2016

    • Capital: GBP 51,984.1
    SH01

    Cuentas consolidadas preparadas hasta el 30 sept 2014

    35 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 21 ene 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital22 ene 2015

    Estado de capital el 22 ene 2015

    • Capital: GBP 51,984.1
    SH01

    Exercice comptable en cours prolongé du 31 jul 2014 au 30 sept 2014

    1 páginasAA01

    Cancelación total de la carga 12

    4 páginasMR04

    Certificado de cambio de nombre y re-registro de Compañía Pública Limitada a Privada

    1 páginasCERT11

    Re-registro del Memorándum y Estatutos

    44 páginasMAR

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de re-registro

    RES02

    Re-registro de una sociedad anónima a una sociedad de responsabilidad limitada

    1 páginasRR02

    ¿Quiénes son los directivos de IMAGO 2014 LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    VICKERAGE, Kay
    Westridge
    Highclere
    RG20 9PX Newbury
    Odyssey
    England
    Secretario
    Westridge
    Highclere
    RG20 9PX Newbury
    Odyssey
    England
    British12466950002
    GEORGE, Andrew
    54 Wentworth Gardens
    GU34 2BJ Alton
    Hampshire
    Director
    54 Wentworth Gardens
    GU34 2BJ Alton
    Hampshire
    EnglandBritish115104730001
    VICKERAGE, Ian Geoffrey
    Snelsmore Common
    RG14 3BG Newbury
    "Genesis"
    Berkshire
    England
    Director
    Snelsmore Common
    RG14 3BG Newbury
    "Genesis"
    Berkshire
    England
    EnglandBritish24979700003
    VICKERAGE, Kay
    Westridge
    Highclere
    RG20 9PX Newbury
    Odyssey
    England
    Director
    Westridge
    Highclere
    RG20 9PX Newbury
    Odyssey
    England
    EnglandBritish207223290001
    WEBSTER, Martin
    10 St Peters Place
    W9 2EE London
    Secretario designado
    10 St Peters Place
    W9 2EE London
    British900005040001
    JONES, Kevin Gareth Brown
    52 Cartmel Drive
    Woodley
    RG5 3NG Reading
    Director
    52 Cartmel Drive
    Woodley
    RG5 3NG Reading
    British62807710002
    REARDON, Jonathan Andrew
    Westfield Latchmore Bank
    Little Hallingbury
    CM22 7PH Bishop's Stortford
    Hertfordshire
    Director designado
    Westfield Latchmore Bank
    Little Hallingbury
    CM22 7PH Bishop's Stortford
    Hertfordshire
    British900005030001
    WEBSTER, Martin
    10 St Peters Place
    W9 2EE London
    Director designado
    10 St Peters Place
    W9 2EE London
    British900005040001
    WRIGHT, Andrew John
    Acre Edge
    Longton By Passage, Walmer Bridge
    PR4 5RE Preston
    Lancashire
    Director
    Acre Edge
    Longton By Passage, Walmer Bridge
    PR4 5RE Preston
    Lancashire
    EnglandBritish70446280001
    ZABOURA, Margaret
    15 Whiteknights Road
    RG6 7BY Reading
    Berkshire
    Director
    15 Whiteknights Road
    RG6 7BY Reading
    Berkshire
    British60020330001
    ZARAIAH, Ralph
    31 Sycamore Close
    Garston
    WD2 6DF Watford
    Hertfordshire
    Director
    31 Sycamore Close
    Garston
    WD2 6DF Watford
    Hertfordshire
    British45893470001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de IMAGO 2014 LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Mr Ian Geoffrey Vickerage
    Westridge
    Highclere
    RG20 9PX Newbury
    Odyssey
    England
    14 abr 2016
    Westridge
    Highclere
    RG20 9PX Newbury
    Odyssey
    England
    No
    Nacionalidad: British
    País de residencia: England
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de las acciones de la compañía.
    Mrs Kay Vickerage
    Westridge
    Highclere
    RG20 9PX Newbury
    Odyssey
    England
    14 abr 2016
    Westridge
    Highclere
    RG20 9PX Newbury
    Odyssey
    England
    No
    Nacionalidad: British
    País de residencia: England
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene IMAGO 2014 LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    All assets debenture
    Creado el 31 ene 2012
    Entregado el 02 feb 2012
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transacciones
    • 02 feb 2012Registro de un cargo (MG01)
    • 24 sept 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 10 ago 2004
    Entregado el 28 ago 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 28 ago 2004Registro de un cargo (395)
    • 09 jun 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Fixed and floating charge
    Creado el 02 oct 2003
    Entregado el 18 oct 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transacciones
    • 18 oct 2003Registro de un cargo (395)
    • 09 jun 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Fixed and floating charge
    Creado el 16 jul 2003
    Entregado el 19 jul 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transacciones
    • 19 jul 2003Registro de un cargo (395)
    • 09 jun 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Deposit agreement to secure own liabilities
    Creado el 21 nov 2000
    Entregado el 30 nov 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The account with the bank denominated in sterlimg designated lloyds tsb PLC re imago micro limited and now numbered 7559424, all deposits with the bank's treasury division in the name of the bank re the company.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 30 nov 2000Registro de un cargo (395)
    • 16 sept 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Charge
    Creado el 02 oct 2000
    Entregado el 04 oct 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreement dated 28 september 2000 (as defined)
    Breve descripción
    Fixed charge upon all book and other debts present and future and all things in action, floating charge the stock in trade and the whole of the charged assets described above.
    Personas con derecho
    • Ibm United Kingdom Financial Services Limited
    Transacciones
    • 04 oct 2000Registro de un cargo (395)
    • 13 sept 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deposit deed
    Creado el 02 dic 1999
    Entregado el 11 dic 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed and lease of even date
    Breve descripción
    All the companys right title benefit and interest in and to the account in which the deposit of £11,940.35 is held together with a sum equivalent to vat thereon.
    Personas con derecho
    • Britel Developments (Thatcham) Limited
    Transacciones
    • 11 dic 1999Registro de un cargo (395)
    • 09 jun 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Deposit deed
    Creado el 02 dic 1999
    Entregado el 09 dic 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease dated 2 december 1999
    Breve descripción
    £11,940 due or to become due from the company to the chargee.
    Personas con derecho
    • Britel Developments (Thatcham) Limited
    Transacciones
    • 09 dic 1999Registro de un cargo (395)
    • 09 jun 2014Todo el bien o empresa ha sido liberado de la carga (MR05)
    • 16 sept 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Charge by way of debenture
    Creado el 10 feb 1998
    Entregado el 14 feb 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Close Invoice Finance Limited
    Transacciones
    • 14 feb 1998Registro de un cargo (395)
    • 13 sept 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 28 abr 1994
    Entregado el 11 may 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a financing agreement or on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed charge over all book debts and other debts other than such debts as the factor may have specifically agreed in writing to exclude from such charge. Floating charge on all book debts and other debts of the company which are not charged by way of fixed charge.
    Personas con derecho
    • Close Invoice Financing Limited
    Transacciones
    • 11 may 1994Registro de un cargo (395)
    • 04 feb 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Single debenture
    Creado el 17 mar 1994
    Entregado el 23 mar 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 23 mar 1994Registro de un cargo (395)
    • 04 feb 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 04 ago 1991
    Entregado el 15 ago 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    (Including trade fixtures) (see form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 15 ago 1991Registro de una carga
    • 29 abr 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0