IMAGO 2014 LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | IMAGO 2014 LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02575558 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de IMAGO 2014 LIMITED?
- Comercio al por mayor de equipos y componentes electrónicos y de telecomunicaciones (46520) / Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas
¿Dónde se encuentra IMAGO 2014 LIMITED?
| Dirección de la sede social | Odyssey Westridge Highclere RG20 9PX Newbury England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de IMAGO 2014 LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| IMAGO 2014 PLC | 19 sept 2014 | 19 sept 2014 |
| IMAGO GROUP PLC | 05 mar 2004 | 05 mar 2004 |
| IMAGO MICRO LIMITED | 10 jul 1991 | 10 jul 1991 |
| DIPLEMA 245 LIMITED | 21 ene 1991 | 21 ene 1991 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de IMAGO 2014 LIMITED?
| Vencido | Sí |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 30 sept 2020 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 jun 2021 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 sept 2019 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para IMAGO 2014 LIMITED?
| Vencido | Sí |
|---|---|
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 21 ene 2020 |
| Próxima declaración de confirmación vence | 04 feb 2020 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 21 ene 2019 |
| Vencido | Sí |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para IMAGO 2014 LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Restauración por orden judicial | 4 páginas | AC92 | ||||||||||
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida | 1 páginas | SOAS(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 30 sept 2019 | 2 páginas | AA | ||||||||||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 30 sept 2018 | 2 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 21 ene 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 sept 2017 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 21 ene 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Mrs Kay Vickerage el 12 dic 2017 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de "Genesis" Snelsmore Common Newbury RG14 3BG England a Odyssey Westridge Highclere Newbury RG20 9PX el 12 dic 2017 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 30 sept 2016 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 21 ene 2017 con actualizaciones | 6 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 30 sept 2015 | 25 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mrs Kay Vickerage como director el 01 abr 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 21 ene 2016 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 30 sept 2014 | 35 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 21 ene 2015 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Exercice comptable en cours prolongé du 31 jul 2014 au 30 sept 2014 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 12 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Certificado de cambio de nombre y re-registro de Compañía Pública Limitada a Privada | 1 páginas | CERT11 | ||||||||||
Re-registro del Memorándum y Estatutos | 44 páginas | MAR | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Re-registro de una sociedad anónima a una sociedad de responsabilidad limitada | 1 páginas | RR02 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de IMAGO 2014 LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VICKERAGE, Kay | Secretario | Westridge Highclere RG20 9PX Newbury Odyssey England | British | 12466950002 | ||||||
| GEORGE, Andrew | Director | 54 Wentworth Gardens GU34 2BJ Alton Hampshire | England | British | 115104730001 | |||||
| VICKERAGE, Ian Geoffrey | Director | Snelsmore Common RG14 3BG Newbury "Genesis" Berkshire England | England | British | 24979700003 | |||||
| VICKERAGE, Kay | Director | Westridge Highclere RG20 9PX Newbury Odyssey England | England | British | 207223290001 | |||||
| WEBSTER, Martin | Secretario designado | 10 St Peters Place W9 2EE London | British | 900005040001 | ||||||
| JONES, Kevin Gareth Brown | Director | 52 Cartmel Drive Woodley RG5 3NG Reading | British | 62807710002 | ||||||
| REARDON, Jonathan Andrew | Director designado | Westfield Latchmore Bank Little Hallingbury CM22 7PH Bishop's Stortford Hertfordshire | British | 900005030001 | ||||||
| WEBSTER, Martin | Director designado | 10 St Peters Place W9 2EE London | British | 900005040001 | ||||||
| WRIGHT, Andrew John | Director | Acre Edge Longton By Passage, Walmer Bridge PR4 5RE Preston Lancashire | England | British | 70446280001 | |||||
| ZABOURA, Margaret | Director | 15 Whiteknights Road RG6 7BY Reading Berkshire | British | 60020330001 | ||||||
| ZARAIAH, Ralph | Director | 31 Sycamore Close Garston WD2 6DF Watford Hertfordshire | British | 45893470001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de IMAGO 2014 LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado |
|---|---|---|---|
| Mr Ian Geoffrey Vickerage | 14 abr 2016 | Westridge Highclere RG20 9PX Newbury Odyssey England | No |
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||
Naturaleza del control
| |||
| Mrs Kay Vickerage | 14 abr 2016 | Westridge Highclere RG20 9PX Newbury Odyssey England | No |
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||
Naturaleza del control
| |||
¿Tiene IMAGO 2014 LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| All assets debenture | Creado el 31 ene 2012 Entregado el 02 feb 2012 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 10 ago 2004 Entregado el 28 ago 2004 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Fixed and floating charge | Creado el 02 oct 2003 Entregado el 18 oct 2003 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Fixed and floating charge | Creado el 16 jul 2003 Entregado el 19 jul 2003 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Deposit agreement to secure own liabilities | Creado el 21 nov 2000 Entregado el 30 nov 2000 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción The account with the bank denominated in sterlimg designated lloyds tsb PLC re imago micro limited and now numbered 7559424, all deposits with the bank's treasury division in the name of the bank re the company. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Charge | Creado el 02 oct 2000 Entregado el 04 oct 2000 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreement dated 28 september 2000 (as defined) | |
Breve descripción Fixed charge upon all book and other debts present and future and all things in action, floating charge the stock in trade and the whole of the charged assets described above. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Deposit deed | Creado el 02 dic 1999 Entregado el 11 dic 1999 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed and lease of even date | |
Breve descripción All the companys right title benefit and interest in and to the account in which the deposit of £11,940.35 is held together with a sum equivalent to vat thereon. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Deposit deed | Creado el 02 dic 1999 Entregado el 09 dic 1999 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease dated 2 december 1999 | |
Breve descripción £11,940 due or to become due from the company to the chargee. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Charge by way of debenture | Creado el 10 feb 1998 Entregado el 14 feb 1998 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 28 abr 1994 Entregado el 11 may 1994 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a financing agreement or on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed charge over all book debts and other debts other than such debts as the factor may have specifically agreed in writing to exclude from such charge. Floating charge on all book debts and other debts of the company which are not charged by way of fixed charge. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Single debenture | Creado el 17 mar 1994 Entregado el 23 mar 1994 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 04 ago 1991 Entregado el 15 ago 1991 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción (Including trade fixtures) (see form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0