AVOVE LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | AVOVE LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02578069 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de AVOVE LIMITED?
- Otras actividades de apoyo a los negocios n.c.p. (82990) / Actividades administrativas y de apoyo
¿Dónde se encuentra AVOVE LIMITED?
| Dirección de la sede social | Unit 42 Eaton Avenue Buckshaw Village PR7 7NA Chorley England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de AVOVE LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| AMEY UTILITY SERVICES LIMITED | 29 may 2014 | 29 may 2014 |
| ENTERPRISE UTILITY SERVICES LIMITED | 15 nov 2011 | 15 nov 2011 |
| ARM GROUP LIMITED | 09 mar 1994 | 09 mar 1994 |
| AGENTCHARM LIMITED | 30 ene 1991 | 30 ene 1991 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de AVOVE LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para AVOVE LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 01 nov 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 15 nov 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 01 nov 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para AVOVE LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declaración de confirmación presentada el 01 nov 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 025780690007 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Registro de la carga 025780690008, creada el 07 may 2025 | 59 páginas | MR01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2024 | 39 páginas | AA | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Mark Perkins el 16 ene 2025 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Darren Simon Jones el 16 ene 2025 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Patrick Rafferty el 16 ene 2025 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 nov 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2023 | 39 páginas | AA | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Part 2nd Floor Offices, Unit 5, Matrix Park Eaton Avenue Buckshaw Village Chorley PR7 7NA United Kingdom a Unit 42 Eaton Avenue Buckshaw Village Chorley PR7 7NA el 15 abr 2024 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 nov 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2022 | 46 páginas | AA | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Memorándum y Estatutos | 10 páginas | MA | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2021 | 39 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 nov 2022 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Sherard Secretariat Services Limited como secretario el 01 nov 2022 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Modification des détails de Rubicon Partners Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 12 abr 2022 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Notification de Rubicon Partners Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 12 abr 2022 | 2 páginas | PSC02 | ||||||||||
Cessation de A.R.M Services Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 12 abr 2022 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Daniel Stephen O'neill como director el 24 jun 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Joseph Boucher como director el 20 jun 2022 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Craig Matthew Mcgilvray como director el 12 abr 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Andrew Latham Nelson como director el 12 abr 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Ian Fisher como director el 12 abr 2022 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de AVOVE LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOUCHER, Joseph | Director | Eaton Avenue Buckshaw Village PR7 7NA Chorley Unit 42 England | United Kingdom | Irish | 279422430001 | |||||||||
| FISHER, Ian | Director | 8-12 York Gate NW1 4QT London Rubicon Partners United Kingdom | United Kingdom | British | 180100650002 | |||||||||
| JONES, Darren Simon | Director | Eaton Avenue Buckshaw Village PR7 7NA Chorley Unit 42 England | United Kingdom | British | 248833760002 | |||||||||
| PERKINS, Mark | Director | Eaton Avenue Buckshaw Village PR7 7NA Chorley Unit 42 England | England | British | 295457930001 | |||||||||
| RAFFERTY, Patrick | Director | Eaton Avenue Buckshaw Village PR7 7NA Chorley Unit 42 England | United Kingdom | English | 276611700001 | |||||||||
| ASHTON, David John | Secretario | Riverside Pooley Bridge CA6 4QN Penrith Cumbria | British | 6729690002 | ||||||||||
| BIRCH, Paul | Secretario | Centurion Way PR26 6TX Leyland Lancaster House Lancashire United Kingdom | British | 76116640002 | ||||||||||
| CARELESS, Robert | Secretario | 43 Newey Road Hall Green B28 0JQ Birmingham West Midlands | British | 652260001 | ||||||||||
| GAVAN, John Vincent | Secretario | 23 Fulshaw Avenue SK9 5JE Wilmslow Cheshire | British | 36153790001 | ||||||||||
| PITFIELD, Bernadette Mary | Secretario | 34 Broadwood Drive Fulwood PR2 9SS Preston Lancashire | British | 17129780002 | ||||||||||
| PITFIELD, Bernadette Mary | Secretario | 34 Broadwood Drive Fulwood PR2 9SS Preston Lancashire | British | 17129780002 | ||||||||||
| WHITEHEAD, Graham | Secretario | 2 Willow Road Uppermill OL3 6JP Oldham Lancashire | British | 68223420001 | ||||||||||
| WILLIAMS, Neil Edward | Secretario | 57 Albany Drive Walton Le Dale PR5 4TX Preston Lancashire | British | 2927950001 | ||||||||||
| SHERARD SECRETARIAT SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | 10 Furnival Street EC4A 1AB London Chancery Exchange United Kingdom |
| 109588620001 | ||||||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secretario designado corporativo | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||||||
| ARNOLD, David Llewelyn | Director | Centurion Way PR26 6TX Leyland Lancaster House Lancashire United Kingdom | United Kingdom | British | 181213200001 | |||||||||
| ASHTON, David John | Director | Riverside Pooley Bridge CA6 4QN Penrith Cumbria | British | 6729690002 | ||||||||||
| BIRCH, Paul | Director | Centurion Way PR26 6TX Leyland Lancaster House Lancashire United Kingdom | England | British | 76116640003 | |||||||||
| BIRKETT, Malcolm David | Director | 33 Edge Fold Road Worsley M28 7GE Manchester | British | 68556370001 | ||||||||||
| BUTLER, Thomas Strickland | Director | Fairfield Whittingham Lane Haighton PR2 5SL Preston Lancashire | British | 6729700002 | ||||||||||
| CARELESS, Robert | Director | 43 Newey Road Hall Green B28 0JQ Birmingham West Midlands | British | 652260001 | ||||||||||
| EASTWOOD, Andrew Michael | Director | Centurion Way PR26 6TX Leyland Lancaster House Lancashire United Kingdom | England | British | 160883820001 | |||||||||
| EWELL, Melvyn | Director | Edmund Halley Road OX4 4DQ Oxford The Sherard Building England | England | British | 61515760002 | |||||||||
| FELL, Michael William | Director | 85 High Street CB2 5PZ Cambridge Cambridgeshire | British | 114233310001 | ||||||||||
| FLOOD, Joseph John | Director | Centurion Way PR26 6TX Leyland Lancaster House Lancashire United Kingdom | United Kingdom | British | 164967870001 | |||||||||
| FOWLIE, Kevin Alexander | Director | Holme Road Bamber Bridge PR5 6BP Preston Amey England | England | British | 222621770001 | |||||||||
| FRASER, Ian Ellis | Director | Centurion Way PR26 6TX Leyland Lancaster House Lancashire United Kingdom | Scotland | Uk | 28393850006 | |||||||||
| GAVAN, John Vincent | Director | 23 Fulshaw Avenue SK9 5JE Wilmslow Cheshire | England | British | 36153790001 | |||||||||
| GAWLER, David | Director | 76 Park Road TW12 1HP Hampton Hill Middlesex | United Kingdom | South African | 167282630001 | |||||||||
| GREENBURY, Lee | Director | Sceptre Way Bamber Bridge PR5 6AW Preston Gordon House Lancashire United Kingdom | England | British | 61478920003 | |||||||||
| HOLLAND, Daniel Lawrence | Director | Edmund Halley Road OX4 4DQ Oxford The Sherard Building England | England | British | 94444730003 | |||||||||
| JACKSON, John Ellis | Director | Ellerslie Coronation Road SL5 9LQ Ascot Berkshire | British | 2219540001 | ||||||||||
| JOHNSON, Robert Burton | Director | 73 Higher Lane WA13 0BZ Lymm Cheshire | British | 27320870001 | ||||||||||
| KEOGH, Sean | Director | Whitehead Farm 650 Whittingham Lane Goosnargh PR3 2JJ Preston Lancashire | United Kingdom | British | 123405900001 | |||||||||
| KIRKBY, Neil Robert Ernest | Director | 5 Dashwood Close Grappenhall WA4 3JA Warrington Cheshire | England | British | 51438040006 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de AVOVE LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ersa Bidco Limited | 12 abr 2022 | York Gate NW1 4QG London 8-12 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| A.R.M Services Group Limited | 06 abr 2016 | 10 Furnival Street EC4A 1AB London Chancery Exchange United Kingdom | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0