QUADRANT INTEGRATED SYSTEMS LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | QUADRANT INTEGRATED SYSTEMS LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 02583461 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de QUADRANT INTEGRATED SYSTEMS LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra QUADRANT INTEGRATED SYSTEMS LIMITED?
Dirección de la sede social | Synectics House 3-4 Broadfield Close S8 0XN Sheffield England |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de QUADRANT INTEGRATED SYSTEMS LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
SYNECTICS MANAGED SERVICES LIMITED | 17 abr 2010 | 17 abr 2010 |
DIGITAL DIRECT LIMITED | 27 ago 1998 | 27 ago 1998 |
ICM SECURITY PRODUCTS LIMITED | 10 oct 1995 | 10 oct 1995 |
I C M DEVELOPMENTS LIMITED | 18 feb 1991 | 18 feb 1991 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de QUADRANT INTEGRATED SYSTEMS LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 30 nov 2019 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para QUADRANT INTEGRATED SYSTEMS LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 1 páginas | DS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 nov 2019 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Aviso de cambio de nombre | 2 páginas | CONNOT | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 05 feb 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr David Michael Bedford como director el 06 ene 2020 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Amanda Louise Larnder como director el 06 ene 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de C/O Synectics Plc Studley Point 88 Birmingham Road Studley Warwickshire B80 7AS a Synectics House 3-4 Broadfield Close Sheffield S8 0XN el 02 dic 2019 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 nov 2018 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mrs Amanda Louise Larnder como director el 18 abr 2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Mark Gerald Goodwin como director el 18 abr 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Simon Beswick como director el 18 abr 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mrs Claire Susan Stewart como secretario el 04 mar 2019 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Simon Beswick como secretario el 04 mar 2019 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 05 feb 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Simon Beswick como director el 30 nov 2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Simon Beswick como secretario el 30 nov 2018 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Michael James Stilwell como director el 30 nov 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Michael James Stilwell como secretario el 30 nov 2018 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 nov 2017 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr Mark Gerald Goodwin como director el 06 abr 2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Richard Paul Brierley como director el 06 abr 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Michael James Stilwell como secretario el 06 abr 2018 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de QUADRANT INTEGRATED SYSTEMS LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEWART, Claire Susan | Secretario | 3-4 Broadfield Close S8 0XN Sheffield Synectics House England | 255934560001 | |||||||
BEDFORD, David Michael | Director | 3-4 Broadfield Close S8 0XN Sheffield Synectics House England | England | British | Finance Director | 302295360001 | ||||
BESWICK, Simon | Secretario | 3-4 Broadfield Close S8 0XN Sheffield Synectics House England | 253087930001 | |||||||
BRIERLEY, Richard Paul | Secretario | c/o Synectics Plc 88 Birmingham Road B80 7AS Studley Studley Point Warwickshire United Kingdom | 209176920001 | |||||||
GERAGHTY, Paul Kevin Ian | Secretario | Monkwood Cottage Whitakers Way IG10 1SQ Loughton Essex | British | Finance Director | 86029660001 | |||||
GOSS, Mark William | Secretario | 57 Highfield Drive Royton OL2 6AF Oldham Lancashire | British | Production Director | 3859880002 | |||||
HISCOCK, Bruce Edward Heath | Secretario | 2 Webbs Cottages The Green RG29 1HF North Warnborough Hampshire | British | 74922870001 | ||||||
MIGHELL, Howard Stanley | Secretario | 25 Goldings Close Kings Hill ME19 4BE West Malling Kent | British | 60739240001 | ||||||
POULTNEY, Nigel Charles | Secretario | 4 Holt Road B80 7NX Studley Warwickshire | British | Accountant | 8488600002 | |||||
STILWELL, Michael James | Secretario | c/o Synectics Plc 88 Birmingham Road B80 7AS Studley Studley Point Warwickshire | 245091810001 | |||||||
BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED | Secretario designado corporativo | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester | 900001550001 | |||||||
BAKER, Terence Ernest | Director | Pentewan Gravesend Road Wrotham TN15 7JS Sevenoaks Kent | British | Company Director | 20512740001 | |||||
BENTLEY, Christopher John | Director | 6 Cornwall Crescent Diggle OL3 5PW Oldham Lancashire | England | British | Design Consultant | 49363770001 | ||||
BESWICK, Simon | Director | 3-4 Broadfield Close S8 0XN Sheffield Synectics House England | Scotland | British | Finance Director | 133770010001 | ||||
BRIERLEY, Richard Paul | Director | c/o Synectics Plc 88 Birmingham Road B80 7AS Studley Studley Point Warwickshire United Kingdom | United Kingdom | British | Company Secretary | 209175910001 | ||||
GERAGHTY, Paul Kevin Ian | Director | Monkwood Cottage Whitakers Way IG10 1SQ Loughton Essex | United Kingdom | British | Finance Director | 86029660001 | ||||
GOODWIN, Mark Gerald | Director | c/o Synectics Plc 88 Birmingham Road B80 7AS Studley Studley Point Warwickshire | England | British | Accountant | 233845210001 | ||||
GOSS, Mark William | Director | 57 Highfield Drive Royton OL2 6AF Oldham Lancashire | England | British | Production Director | 3859880002 | ||||
HISCOCK, Bruce Edward Heath | Director | 2 Webbs Cottages The Green RG29 1HF North Warnborough Hampshire | United Kingdom | British | Accountant | 74922870001 | ||||
KENWAY, Ian David | Director | 5 Duncote Grove Royton OL2 6LL Oldham Lancashire | British | Technical Director | 3859890003 | |||||
LARNDER, Amanda Louise | Director | 3-4 Broadfield Close S8 0XN Sheffield Synectics House England | England | British | Head Of Finance | 257818550001 | ||||
MIGHELL, Howard Stanley | Director | 25 Goldings Close Kings Hill ME19 4BE West Malling Kent | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 60739240001 | ||||
MOIR, William John Wallace | Director | Shrublands Lockhampton Hill GL53 9QJ Cheltenham Gloucestershire | United Kingdom | British | Company Director | 394130001 | ||||
MOIR, William John Wallace | Director | Shrublands Lockhampton Hill GL53 9QJ Cheltenham Gloucestershire | United Kingdom | British | Director | 394130001 | ||||
PARKER, Philip Hull | Director | 1 Quarry Lane Lower Shiplake RG9 3JW Henley Oxfordshire | British | Director | 99496350001 | |||||
POULTNEY, Nigel Charles | Director | 4 Holt Road B80 7NX Studley Warwickshire | England | British | Accountant | 8488600002 | ||||
RICKS, Roy William | Director | 87 St Marys Drive SS7 1LH Benfleet Essex | British | Company Director | 68026600001 | |||||
SHEPHERD, John, Mr. | Director | c/o Synectics Plc 88 Birmingham Road B80 7AS Studley Studley Point Warwickshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 151588320001 | ||||
SINGLETON, Russell Craig | Director | 417 Whirlowdale Road S11 9NG Sheffield South Yorkshire | England | British | Director | 3492940001 | ||||
SMITH, Clive Alan | Director | The Spinney Devenish Lane SL5 9QU Ascot Berkshire | British | Director | 62182450003 | |||||
STILWELL, Michael James | Director | c/o Synectics Plc 88 Birmingham Road B80 7AS Studley Studley Point Warwickshire | England | British | Accountant | 194783340001 | ||||
TAYLOR, Roger | Director | St Georges House St Georges Place GY1 2BH St Peter Port Guernsey | Channel Islands | British | Company Director | 109462320001 | ||||
UNWIN, Michael Richard | Director | Beechcomber Station Road RH19 4NY Sharpethorne West Sussex | West Sussex | British | Engineer | 43396130001 | ||||
DEANSGATE COMPANY FORMATIONS LIMITED | Director designado corporativo | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester | 900001540001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de QUADRANT INTEGRATED SYSTEMS LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Protec Plc | 06 abr 2016 | 88 Birmingham Road B80 7AS Studley Studley Point England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene QUADRANT INTEGRATED SYSTEMS LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Mortgage debenture | Creado el 29 may 1996 Entregado el 05 jun 1996 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0