QUADRANT INTEGRATED SYSTEMS LIMITED

QUADRANT INTEGRATED SYSTEMS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaQUADRANT INTEGRATED SYSTEMS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02583461
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de QUADRANT INTEGRATED SYSTEMS LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra QUADRANT INTEGRATED SYSTEMS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Synectics House
    3-4 Broadfield Close
    S8 0XN Sheffield
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de QUADRANT INTEGRATED SYSTEMS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    SYNECTICS MANAGED SERVICES LIMITED17 abr 201017 abr 2010
    DIGITAL DIRECT LIMITED27 ago 199827 ago 1998
    ICM SECURITY PRODUCTS LIMITED10 oct 199510 oct 1995
    I C M DEVELOPMENTS LIMITED18 feb 199118 feb 1991

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de QUADRANT INTEGRATED SYSTEMS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 nov 2019

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para QUADRANT INTEGRATED SYSTEMS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    1 páginasDS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 nov 2019

    3 páginasAA

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 04 may 2020

    RES15

    Aviso de cambio de nombre

    2 páginasCONNOT

    Declaración de confirmación presentada el 05 feb 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Mr David Michael Bedford como director el 06 ene 2020

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Amanda Louise Larnder como director el 06 ene 2020

    1 páginasTM01

    Domicilio social registrado cambiado de C/O Synectics Plc Studley Point 88 Birmingham Road Studley Warwickshire B80 7AS a Synectics House 3-4 Broadfield Close Sheffield S8 0XN el 02 dic 2019

    1 páginasAD01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 nov 2018

    3 páginasAA

    Nombramiento de Mrs Amanda Louise Larnder como director el 18 abr 2019

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Mark Gerald Goodwin como director el 18 abr 2019

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Simon Beswick como director el 18 abr 2019

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mrs Claire Susan Stewart como secretario el 04 mar 2019

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Simon Beswick como secretario el 04 mar 2019

    1 páginasTM02

    Declaración de confirmación presentada el 05 feb 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Mr Simon Beswick como director el 30 nov 2018

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Simon Beswick como secretario el 30 nov 2018

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Michael James Stilwell como director el 30 nov 2018

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Michael James Stilwell como secretario el 30 nov 2018

    1 páginasTM02

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 nov 2017

    4 páginasAA

    Nombramiento de Mr Mark Gerald Goodwin como director el 06 abr 2018

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Richard Paul Brierley como director el 06 abr 2018

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Michael James Stilwell como secretario el 06 abr 2018

    2 páginasAP03

    ¿Quiénes son los directivos de QUADRANT INTEGRATED SYSTEMS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    STEWART, Claire Susan
    3-4 Broadfield Close
    S8 0XN Sheffield
    Synectics House
    England
    Secretario
    3-4 Broadfield Close
    S8 0XN Sheffield
    Synectics House
    England
    255934560001
    BEDFORD, David Michael
    3-4 Broadfield Close
    S8 0XN Sheffield
    Synectics House
    England
    Director
    3-4 Broadfield Close
    S8 0XN Sheffield
    Synectics House
    England
    EnglandBritishFinance Director302295360001
    BESWICK, Simon
    3-4 Broadfield Close
    S8 0XN Sheffield
    Synectics House
    England
    Secretario
    3-4 Broadfield Close
    S8 0XN Sheffield
    Synectics House
    England
    253087930001
    BRIERLEY, Richard Paul
    c/o Synectics Plc
    88 Birmingham Road
    B80 7AS Studley
    Studley Point
    Warwickshire
    United Kingdom
    Secretario
    c/o Synectics Plc
    88 Birmingham Road
    B80 7AS Studley
    Studley Point
    Warwickshire
    United Kingdom
    209176920001
    GERAGHTY, Paul Kevin Ian
    Monkwood Cottage
    Whitakers Way
    IG10 1SQ Loughton
    Essex
    Secretario
    Monkwood Cottage
    Whitakers Way
    IG10 1SQ Loughton
    Essex
    BritishFinance Director86029660001
    GOSS, Mark William
    57 Highfield Drive
    Royton
    OL2 6AF Oldham
    Lancashire
    Secretario
    57 Highfield Drive
    Royton
    OL2 6AF Oldham
    Lancashire
    BritishProduction Director3859880002
    HISCOCK, Bruce Edward Heath
    2 Webbs Cottages
    The Green
    RG29 1HF North Warnborough
    Hampshire
    Secretario
    2 Webbs Cottages
    The Green
    RG29 1HF North Warnborough
    Hampshire
    British74922870001
    MIGHELL, Howard Stanley
    25 Goldings Close
    Kings Hill
    ME19 4BE West Malling
    Kent
    Secretario
    25 Goldings Close
    Kings Hill
    ME19 4BE West Malling
    Kent
    British60739240001
    POULTNEY, Nigel Charles
    4 Holt Road
    B80 7NX Studley
    Warwickshire
    Secretario
    4 Holt Road
    B80 7NX Studley
    Warwickshire
    BritishAccountant8488600002
    STILWELL, Michael James
    c/o Synectics Plc
    88 Birmingham Road
    B80 7AS Studley
    Studley Point
    Warwickshire
    Secretario
    c/o Synectics Plc
    88 Birmingham Road
    B80 7AS Studley
    Studley Point
    Warwickshire
    245091810001
    BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED
    The Britannia Suite International House
    82-86 Deansgate
    M3 2ER Manchester
    Secretario designado corporativo
    The Britannia Suite International House
    82-86 Deansgate
    M3 2ER Manchester
    900001550001
    BAKER, Terence Ernest
    Pentewan Gravesend Road
    Wrotham
    TN15 7JS Sevenoaks
    Kent
    Director
    Pentewan Gravesend Road
    Wrotham
    TN15 7JS Sevenoaks
    Kent
    BritishCompany Director20512740001
    BENTLEY, Christopher John
    6 Cornwall Crescent
    Diggle
    OL3 5PW Oldham
    Lancashire
    Director
    6 Cornwall Crescent
    Diggle
    OL3 5PW Oldham
    Lancashire
    EnglandBritishDesign Consultant49363770001
    BESWICK, Simon
    3-4 Broadfield Close
    S8 0XN Sheffield
    Synectics House
    England
    Director
    3-4 Broadfield Close
    S8 0XN Sheffield
    Synectics House
    England
    ScotlandBritishFinance Director133770010001
    BRIERLEY, Richard Paul
    c/o Synectics Plc
    88 Birmingham Road
    B80 7AS Studley
    Studley Point
    Warwickshire
    United Kingdom
    Director
    c/o Synectics Plc
    88 Birmingham Road
    B80 7AS Studley
    Studley Point
    Warwickshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Secretary209175910001
    GERAGHTY, Paul Kevin Ian
    Monkwood Cottage
    Whitakers Way
    IG10 1SQ Loughton
    Essex
    Director
    Monkwood Cottage
    Whitakers Way
    IG10 1SQ Loughton
    Essex
    United KingdomBritishFinance Director86029660001
    GOODWIN, Mark Gerald
    c/o Synectics Plc
    88 Birmingham Road
    B80 7AS Studley
    Studley Point
    Warwickshire
    Director
    c/o Synectics Plc
    88 Birmingham Road
    B80 7AS Studley
    Studley Point
    Warwickshire
    EnglandBritishAccountant233845210001
    GOSS, Mark William
    57 Highfield Drive
    Royton
    OL2 6AF Oldham
    Lancashire
    Director
    57 Highfield Drive
    Royton
    OL2 6AF Oldham
    Lancashire
    EnglandBritishProduction Director3859880002
    HISCOCK, Bruce Edward Heath
    2 Webbs Cottages
    The Green
    RG29 1HF North Warnborough
    Hampshire
    Director
    2 Webbs Cottages
    The Green
    RG29 1HF North Warnborough
    Hampshire
    United KingdomBritishAccountant74922870001
    KENWAY, Ian David
    5 Duncote Grove
    Royton
    OL2 6LL Oldham
    Lancashire
    Director
    5 Duncote Grove
    Royton
    OL2 6LL Oldham
    Lancashire
    BritishTechnical Director3859890003
    LARNDER, Amanda Louise
    3-4 Broadfield Close
    S8 0XN Sheffield
    Synectics House
    England
    Director
    3-4 Broadfield Close
    S8 0XN Sheffield
    Synectics House
    England
    EnglandBritishHead Of Finance257818550001
    MIGHELL, Howard Stanley
    25 Goldings Close
    Kings Hill
    ME19 4BE West Malling
    Kent
    Director
    25 Goldings Close
    Kings Hill
    ME19 4BE West Malling
    Kent
    United KingdomBritishChartered Accountant60739240001
    MOIR, William John Wallace
    Shrublands
    Lockhampton Hill
    GL53 9QJ Cheltenham
    Gloucestershire
    Director
    Shrublands
    Lockhampton Hill
    GL53 9QJ Cheltenham
    Gloucestershire
    United KingdomBritishCompany Director394130001
    MOIR, William John Wallace
    Shrublands
    Lockhampton Hill
    GL53 9QJ Cheltenham
    Gloucestershire
    Director
    Shrublands
    Lockhampton Hill
    GL53 9QJ Cheltenham
    Gloucestershire
    United KingdomBritishDirector394130001
    PARKER, Philip Hull
    1 Quarry Lane
    Lower Shiplake
    RG9 3JW Henley
    Oxfordshire
    Director
    1 Quarry Lane
    Lower Shiplake
    RG9 3JW Henley
    Oxfordshire
    BritishDirector99496350001
    POULTNEY, Nigel Charles
    4 Holt Road
    B80 7NX Studley
    Warwickshire
    Director
    4 Holt Road
    B80 7NX Studley
    Warwickshire
    EnglandBritishAccountant8488600002
    RICKS, Roy William
    87 St Marys Drive
    SS7 1LH Benfleet
    Essex
    Director
    87 St Marys Drive
    SS7 1LH Benfleet
    Essex
    BritishCompany Director68026600001
    SHEPHERD, John, Mr.
    c/o Synectics Plc
    88 Birmingham Road
    B80 7AS Studley
    Studley Point
    Warwickshire
    United Kingdom
    Director
    c/o Synectics Plc
    88 Birmingham Road
    B80 7AS Studley
    Studley Point
    Warwickshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector151588320001
    SINGLETON, Russell Craig
    417 Whirlowdale Road
    S11 9NG Sheffield
    South Yorkshire
    Director
    417 Whirlowdale Road
    S11 9NG Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritishDirector3492940001
    SMITH, Clive Alan
    The Spinney Devenish Lane
    SL5 9QU Ascot
    Berkshire
    Director
    The Spinney Devenish Lane
    SL5 9QU Ascot
    Berkshire
    BritishDirector62182450003
    STILWELL, Michael James
    c/o Synectics Plc
    88 Birmingham Road
    B80 7AS Studley
    Studley Point
    Warwickshire
    Director
    c/o Synectics Plc
    88 Birmingham Road
    B80 7AS Studley
    Studley Point
    Warwickshire
    EnglandBritishAccountant194783340001
    TAYLOR, Roger
    St Georges House
    St Georges Place
    GY1 2BH St Peter Port
    Guernsey
    Director
    St Georges House
    St Georges Place
    GY1 2BH St Peter Port
    Guernsey
    Channel IslandsBritishCompany Director109462320001
    UNWIN, Michael Richard
    Beechcomber
    Station Road
    RH19 4NY Sharpethorne
    West Sussex
    Director
    Beechcomber
    Station Road
    RH19 4NY Sharpethorne
    West Sussex
    West SussexBritishEngineer43396130001
    DEANSGATE COMPANY FORMATIONS LIMITED
    The Britannia Suite International House
    82-86 Deansgate
    M3 2ER Manchester
    Director designado corporativo
    The Britannia Suite International House
    82-86 Deansgate
    M3 2ER Manchester
    900001540001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de QUADRANT INTEGRATED SYSTEMS LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Protec Plc
    88 Birmingham Road
    B80 7AS Studley
    Studley Point
    England
    06 abr 2016
    88 Birmingham Road
    B80 7AS Studley
    Studley Point
    England
    No
    Forma jurídicaPublic Limited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalEngland And Wales
    Lugar de registroUk Register Of Companies
    Número de registro2876304
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre las actividades de una firma que, según la ley que la rige, no es una persona jurídica; y los miembros de esa firma (en su calidad como tales) tienen el derecho de ejercer, o realmente ejercen, una influencia o control significativo sobre la empresa.

    ¿Tiene QUADRANT INTEGRATED SYSTEMS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Mortgage debenture
    Creado el 29 may 1996
    Entregado el 05 jun 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 05 jun 1996Registro de un cargo (395)
    • 16 mar 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0