APACHE UK LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | APACHE UK LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02586435 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de APACHE UK LIMITED?
- Extracción de petróleo crudo (06100) / Explotación de minas y canteras
¿Dónde se encuentra APACHE UK LIMITED?
| Dirección de la sede social | 27-28 Eastcastle Street London W1W 8DH |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de APACHE UK LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| NOVUS UK (HARRIET) LIMITED | 07 jul 1995 | 07 jul 1995 |
| MONUMENT OIL (AUSTRALIA) LIMITED | 17 feb 1992 | 17 feb 1992 |
| SECAB OIL LIMITED | 15 mar 1991 | 15 mar 1991 |
| ALNERY NO. 1065 LIMITED | 27 feb 1991 | 27 feb 1991 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de APACHE UK LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2020 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para APACHE UK LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 4 páginas | DS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2020 | 18 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 jun 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Ross Michael Littlewood como director el 17 may 2021 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Ryan John James Chelte como director el 17 may 2021 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2019 | 17 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 jun 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Timothy Richard Custer como director el 01 abr 2020 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Jon Anthony Graham como director el 01 abr 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Ryan John James Chelte como director el 01 abr 2020 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Ms Susan Greig como director el 01 abr 2020 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Kenneth Hoyt Neupert como director el 01 abr 2020 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2018 | 17 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 jun 2019 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2017 | 17 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 jun 2018 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2016 | 18 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 jun 2017 con actualizaciones | 6 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Jon Anthony Graham como director el 01 abr 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Cory Lin Loegering como director el 01 abr 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 2 páginas | SH20 | ||||||||||
Estado de capital el 21 dic 2016
| 5 páginas | SH19 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de APACHE UK LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGIL MANAGEMENT SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | Eastcastle Street W1W 8DH London 27-28 United Kingdom | 38636470004 | |||||||
| CUSTER, Timothy Richard | Director | Eastcastle Street W1W 8DH London 27-28 United Kingdom | United States | American | 265498400001 | |||||
| GREIG, Susan | Director | Eastcastle Street W1W 8DH London 27-28 United Kingdom | Scotland | British | 268697430001 | |||||
| LITTLEWOOD, Ross Michael | Director | Eastcastle Street W1W 8DH London 27-28 United Kingdom | United Kingdom | British | 285461910001 | |||||
| NEUPERT, Kenneth Hoyt | Director | Eastcastle Street W1W 8DH London 27-28 United Kingdom | United States | American | 268697420001 | |||||
| SAUER, Jon William | Director | 19 Cleerebrook Place 77382 The Woodlands Texas United States | United States | American | 88461340001 | |||||
| GOODWIN, Keith John | Secretario | 24 Esher Avenue KT12 2TA Walton On Thames Surrey | British | 44556890001 | ||||||
| HORNABROOK, James Trevor | Secretario | Middle Luxton Upottery EX14 9PA Honiton Devon | British | 11673550001 | ||||||
| PEPER, Cheri Lynette | Secretario | 8503 Braes Meadow Drive Houston Texas 77071 Usa | American | 59487280001 | ||||||
| STEER, Janette Lesley | Secretario | 16 Foxberry Road Brockley SE4 2SP London | British | 5200300001 | ||||||
| AIREY, Elisabeth Patricia | Director | 20 St Jamess Walk EC1R 0AP London | England | British | 107419680001 | |||||
| CHAMBERS, Thomas Patrick | Director | 27-28 Eastcastle Street London W1W 8DH | United States | American | 159261770001 | |||||
| CHELTE, Ryan John James | Director | Eastcastle Street W1W 8DH London 27-28 United Kingdom | United Kingdom | Canadian | 268697440001 | |||||
| CRAVEN WALKER, Antony | Director | Square Du Val De La Cambre 3 1050 Bruxelles Belgium | British | 70900640001 | ||||||
| CRUM, John Alan | Director | 5341 Fayette Houston Texas Tx 77056 U.S.A. | American | 71107080011 | ||||||
| EICHLER, Rodney John | Director | South Niagra Circle Centennial 7267 Colorado 80112 United States | United States | American | 139236410001 | |||||
| FARRIS, George Steven | Director | 2606 Autumn Lake Drive Katy Texas 77450 Usa | American | 59487240001 | ||||||
| GOODWIN, Keith John | Director | 24 Esher Avenue KT12 2TA Walton On Thames Surrey | British | 44556890001 | ||||||
| GRAHAM, Jon Anthony | Director | 27-28 Eastcastle Street London W1W 8DH | United Kingdom | American | 228915630001 | |||||
| GUEST, James William | Director | Ash Farm Schoolhouse Lane Horsmonden TN12 8BJ Tonbridge Kent | United Kingdom | British | 11673540001 | |||||
| HORNABROOK, James Trevor | Director | Middle Luxton Upottery EX14 9PA Honiton Devon | England | British | 11673550001 | |||||
| HOUSE, James Lynn | Director | Eastcastle Street W1W 8DH London 27/28 United Kingdom | United States | American | 243265990001 | |||||
| KOBIASHVILI, Zurab Shakro | Director | 7 East Sunlight Forest Drive The Woodlands Texas 77381 Usa | American | 59487250001 | ||||||
| LEON ALONSO, Alfonso | Director | 27-28 Eastcastle Street London W1W 8DH | United States | Spanish | 191203250001 | |||||
| LOEGERING, Cory Lin | Director | 27-28 Eastcastle Street London W1W 8DH | United Kingdom | British | 200294400001 | |||||
| PATRICK, John Alexander | Director | Marley Mere Marley Lane GU27 3PZ Haslemere Surrey | British | 92558480001 | ||||||
| PLANK, Roger Barton | Director | 307 Teakwood Drive Houston Texas 77024 Usa | Usa | American | 59487200002 | |||||
| PRICE, Floyd Ray | Director | 4808 Laurel Street Bellaire Texas 77401 Usa | American | 59487230001 | ||||||
| VINGOE, Philip Arthur, Dr | Director | Bluebell Corner Deadhearn Lane HP8 4HG Chalfont St. Giles Buckinghamshire | Uk | British | 116452230001 | |||||
| VOYTOVICH, Thomas Edward | Director | 27-28 Eastcastle Street London W1W 8DH | United States Of America | American | 184028140001 | |||||
| WILLIAMS, Robert Charles, Dr | Director | Apt 2301 Observatory Tower 168 Kent Street Sydney New South Wales 2000 Australia | British | 44317420002 |
¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para APACHE UK LIMITED?
| Notificado el | Cesado el | Declaración |
|---|---|---|
| 01 jun 2017 | La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa. |
¿Tiene APACHE UK LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Rent deposit deed | Creado el 20 feb 1998 Entregado el 26 feb 1998 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada Payment of the rents reserved by and performance of the company's obligations in an underlease dated 20 february 1998 made between the city of london real property company limited and novus UK (harriet) limited | |
Breve descripción The sum of £10,312.50. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Fixed and floating equitable charge executed outside the united kingdom and comprising property situated outside the united kingdom | Creado el 26 jul 1995 Entregado el 16 ago 1995 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company (formerly known as monument oil (australia) limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the finance documents as defined therein | |
Breve descripción All the right title estate and interest of the company in the harriet interest. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| An agreement to grant a charge | Creado el 13 jun 1995 Entregado el 29 jun 1995 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All amounts due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of the finance documents (as defined) | |
Breve descripción All the present and future right title estate and interest of the borrower in the harriet interest all insurances and the policies constituting the insurances proceeds of sale choses in action the borrower's books of account. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0