TPS (INSURANCE ADMIN SERVICES) LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | TPS (INSURANCE ADMIN SERVICES) LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02587396 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de TPS (INSURANCE ADMIN SERVICES) LIMITED?
- Seguros no de vida (65120) / Actividades financieras y de seguros
¿Dónde se encuentra TPS (INSURANCE ADMIN SERVICES) LIMITED?
| Dirección de la sede social | Cast House Old Mill Business Park Gibraltar Island Road LS10 1RJ Leeds West Yorkshire |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de TPS (INSURANCE ADMIN SERVICES) LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| TRAVELLERS PROTECTION SERVICES LIMITED | 20 sept 1994 | 20 sept 1994 |
| GRAND UK INSURANCE SERVICES LIMITED | 01 mar 1991 | 01 mar 1991 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de TPS (INSURANCE ADMIN SERVICES) LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2016 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para TPS (INSURANCE ADMIN SERVICES) LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 mar 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2016 | 2 páginas | AA | ||||||||||
Cancelación total de la carga 1 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Nombramiento de Mrs Penny Fullerton como secretario el 24 mar 2016 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Stephen Blott como secretario el 24 mar 2016 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 mar 2016 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de Peter John Hubbard como director el 29 feb 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Stephen Blott como secretario el 01 nov 2015 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Jeffrey Christopher Orton como secretario el 01 nov 2015 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2015 | 2 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 mar 2015 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2014 | 2 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 mar 2014 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de Michael Warren como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Michael Warren como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Jeffrey Christopher Orton como secretario | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Penelope Fullerton como secretario | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Ryan Mark Gill como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mrs Penelope Jane Fullerton como secretario | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Stacey Zaczkiewicz como secretario | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2013 | 2 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 mar 2013 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de TPS (INSURANCE ADMIN SERVICES) LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FULLERTON, Penny | Secretario | Old Mill Business Park Gibraltar Island Road LS10 1RJ Leeds Cast House West Yorkshire | 206865730001 | |||||||
| BEALES, Karen Anne | Director | Marling Road Ainley Top HD2 2EE Huddersfield The Chalet Uk | England | British | 135540180002 | |||||
| GILL, Ryan Mark | Director | Old Mill Business Park Gibraltar Island Road LS10 1RJ Leeds Cast House West Yorkshire | England | British | 184068890001 | |||||
| SMITH, Malachy Paul | Director | Old Mill Business Park Gibraltar Island Road LS10 1RJ Leeds Cast House West Yorkshire | Ireland | Irish | 262619320001 | |||||
| BLOOM, Colin Preston Paul | Secretario | 27 Woodfields Stradbroke IP21 5JQ Eye Suffolk | British | 21182260001 | ||||||
| BLOTT, Stephen | Secretario | Old Mill Business Park Gibraltar Island Road LS10 1RJ Leeds Cast House West Yorkshire | 202286490001 | |||||||
| BLOTT, Stephen | Secretario | Low Wood Wilsden BD15 0JS Bradford 30 West Yorkshire England | British | 139352410001 | ||||||
| FULLERTON, Penelope Jane | Secretario | Old Mill Business Park Gibraltar Island Road LS10 1RJ Leeds Cast House West Yorkshire | 184069960001 | |||||||
| LAWRENCE, Christopher | Secretario | Dunelm House 47b The Street NR13 5AA Brundall Norfolk | British | 90712300001 | ||||||
| ORTON, Jeffrey Christopher | Secretario | Old Mill Business Park Gibraltar Island Road LS10 1RJ Leeds Cast House West Yorkshire | 185565520001 | |||||||
| THORLEY, Anne | Secretario | 51 Mill Lane NR17 2NW Attleborough Norfolk | British | 26486150002 | ||||||
| WARMAN, Paul Jonathan | Secretario | The Old Rectory Horsey NR29 4EF Great Yarmouth Norfolk | British | 25255550003 | ||||||
| WARMAN, Paul Jonathan | Secretario | The Old Rectory Horsey NR29 4EF Great Yarmouth Norfolk | British | 25255550003 | ||||||
| ZACZKIEWICZ, Stacey | Secretario | Old Mill Business Park Gibraltar Island Road LS10 1RJ Leeds Cast House West Yorkshire | 170325190001 | |||||||
| EVERSECRETARY LIMITED | Secretario corporativo | Eversheds House 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester | 60471940015 | |||||||
| PRIMARY GROUP SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | 10 King William Street EC4N 7TW London | 107712310001 | |||||||
| ASPROU, Caroline Anna | Director | Highnoon Woodbastwick Road, Blofield Heath NR13 4QH Norwich Norfolk | British | 76073630001 | ||||||
| BELL, Graeme Paul | Director | 6 Moule Rise LS25 2PH Garforth West Yorkshire | England | British | 100163980001 | |||||
| CAMM, Suzanne Mary | Director | The Old Coach House Norwich Road Reepham NR10 4JN Norwich Norfolk | British | 80914120002 | ||||||
| FRANCIS, Timothy John | Director | Farm End Topcroft NR35 2BB Bungay Norfolk | British | 80914650001 | ||||||
| HARNBY, Alastair John | Director | Dene Bank BD16 4AR Bingley 21 West Yorkshire Uk | United Kingdom | British | 172070220002 | |||||
| HUBBARD, Peter John | Director | Sevenleaze Lane Edge GL6 6NL Stroud Huddaknoll House Gloucestershire United Kingdom | England | British | 28375870003 | |||||
| JAMES, Philip William Henry | Director | Hampton Head 9 Peppercorn Lane Southampton Sn 04 Bermuda | England | British | 33901640008 | |||||
| LAIRD, Oliver Walter | Director | Old Mill Business Park Gibraltar Island Road LS10 1RJ Leeds Cast House West Yorkshire | United Kingdom | British | 233726140001 | |||||
| LAWRENCE, Christopher | Director | Dunelm House 47b The Street NR13 5AA Brundall Norfolk | British | 90712300001 | ||||||
| MARLEY, Nicholas James | Director | 6 The Brambles Woodside SW19 7AY London | United Kingdom | British | 113304050001 | |||||
| MCGUIRE, Elisabeth Mary | Director | 3 Landfall House Springvale PO34 5AN Seaview Isle Of Wight | British | 80914390001 | ||||||
| MEDDES, Kenneth Sydney | Director | Hillside Townhill Bramham LS23 6QD Wetherby | United Kingdom | British | 11486330002 | |||||
| NICHOL, Duncan Kirkbride, Sir | Director | 1 Pipers Close CH60 9LJ Heswall Merseyside | United Kingdom | British | 85618250001 | |||||
| POSNER, Howard Michael | Director | Stocks Lane HX2 6PR Luddenden Eaves House Halifax | United Kingdom | British | 139631580001 | |||||
| RIVETT, Paul Geoffrey Leo | Director | Westfield Place Whinburgh Road, Westfield NR19 1QJ Dereham Norfolk | British | 67188630001 | ||||||
| ROLFE, Timothy Paul | Director | 9 Overhill CR6 9JR Warlingham Surrey | England | British | 107872640001 | |||||
| SMITH, Paul Kenneth | Director | 4 Merchant Exchange Bridge Street YO1 6LT York North Yorkshire | United Kingdom | British | 126031290001 | |||||
| SMYTH, Timothy John | Director | 2 Knoll Road RH4 3EW Dorking Surrey | United Kingdom | British | 77794000002 | |||||
| THORLEY, Anne | Director | 51 Mill Lane NR17 2NW Attleborough Norfolk | British | 26486150002 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de TPS (INSURANCE ADMIN SERVICES) LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uk General Insurance Limited | 06 abr 2016 | Gibraltar Island Road Old Mill Business Park LS10 1RJ Leeds Cast House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene TPS (INSURANCE ADMIN SERVICES) LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creado el 28 feb 2007 Entregado el 15 mar 2007 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due of each obligor to the chargee and/or the finance parties and/or any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción First fixed charge all shares in any group company,all of its investments now or subsequently belonging to it held by an. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Charge of deposit | Creado el 24 dic 2004 Entregado el 31 dic 2004 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Deposit initially of £50,000 credited to account designation 68126255 with the bank and any addition to that deposit and any deposit or account of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposit or account. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0