TPS (INSURANCE ADMIN SERVICES) LIMITED

TPS (INSURANCE ADMIN SERVICES) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaTPS (INSURANCE ADMIN SERVICES) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02587396
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de TPS (INSURANCE ADMIN SERVICES) LIMITED?

    • Seguros no de vida (65120) / Actividades financieras y de seguros

    ¿Dónde se encuentra TPS (INSURANCE ADMIN SERVICES) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Cast House Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    West Yorkshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de TPS (INSURANCE ADMIN SERVICES) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    TRAVELLERS PROTECTION SERVICES LIMITED20 sept 199420 sept 1994
    GRAND UK INSURANCE SERVICES LIMITED01 mar 199101 mar 1991

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de TPS (INSURANCE ADMIN SERVICES) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2016

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para TPS (INSURANCE ADMIN SERVICES) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Declaración de confirmación presentada el 01 mar 2017 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2016

    2 páginasAA

    Cancelación total de la carga 1

    1 páginasMR04

    Nombramiento de Mrs Penny Fullerton como secretario el 24 mar 2016

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Stephen Blott como secretario el 24 mar 2016

    1 páginasTM02

    Déclaration annuelle établie au 01 mar 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital09 mar 2016

    Estado de capital el 09 mar 2016

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Cese del nombramiento de Peter John Hubbard como director el 29 feb 2016

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Stephen Blott como secretario el 01 nov 2015

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Jeffrey Christopher Orton como secretario el 01 nov 2015

    1 páginasTM02

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2015

    2 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 01 mar 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital10 mar 2015

    Estado de capital el 10 mar 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2014

    2 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 01 mar 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital05 mar 2014

    Estado de capital el 05 mar 2014

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Cese del nombramiento de Michael Warren como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Michael Warren como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Jeffrey Christopher Orton como secretario

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Penelope Fullerton como secretario

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Mr Ryan Mark Gill como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mrs Penelope Jane Fullerton como secretario

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Stacey Zaczkiewicz como secretario

    1 páginasTM02

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2013

    2 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 01 mar 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    ¿Quiénes son los directivos de TPS (INSURANCE ADMIN SERVICES) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    FULLERTON, Penny
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    Secretario
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    206865730001
    BEALES, Karen Anne
    Marling Road
    Ainley Top
    HD2 2EE Huddersfield
    The Chalet
    Uk
    Director
    Marling Road
    Ainley Top
    HD2 2EE Huddersfield
    The Chalet
    Uk
    EnglandBritish135540180002
    GILL, Ryan Mark
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    Director
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    EnglandBritish184068890001
    SMITH, Malachy Paul
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    Director
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    IrelandIrish262619320001
    BLOOM, Colin Preston Paul
    27 Woodfields
    Stradbroke
    IP21 5JQ Eye
    Suffolk
    Secretario
    27 Woodfields
    Stradbroke
    IP21 5JQ Eye
    Suffolk
    British21182260001
    BLOTT, Stephen
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    Secretario
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    202286490001
    BLOTT, Stephen
    Low Wood
    Wilsden
    BD15 0JS Bradford
    30
    West Yorkshire
    England
    Secretario
    Low Wood
    Wilsden
    BD15 0JS Bradford
    30
    West Yorkshire
    England
    British139352410001
    FULLERTON, Penelope Jane
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    Secretario
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    184069960001
    LAWRENCE, Christopher
    Dunelm House 47b The Street
    NR13 5AA Brundall
    Norfolk
    Secretario
    Dunelm House 47b The Street
    NR13 5AA Brundall
    Norfolk
    British90712300001
    ORTON, Jeffrey Christopher
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    Secretario
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    185565520001
    THORLEY, Anne
    51 Mill Lane
    NR17 2NW Attleborough
    Norfolk
    Secretario
    51 Mill Lane
    NR17 2NW Attleborough
    Norfolk
    British26486150002
    WARMAN, Paul Jonathan
    The Old Rectory
    Horsey
    NR29 4EF Great Yarmouth
    Norfolk
    Secretario
    The Old Rectory
    Horsey
    NR29 4EF Great Yarmouth
    Norfolk
    British25255550003
    WARMAN, Paul Jonathan
    The Old Rectory
    Horsey
    NR29 4EF Great Yarmouth
    Norfolk
    Secretario
    The Old Rectory
    Horsey
    NR29 4EF Great Yarmouth
    Norfolk
    British25255550003
    ZACZKIEWICZ, Stacey
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    Secretario
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    170325190001
    EVERSECRETARY LIMITED
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    Secretario corporativo
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    60471940015
    PRIMARY GROUP SERVICES LIMITED
    10 King William Street
    EC4N 7TW London
    Secretario corporativo
    10 King William Street
    EC4N 7TW London
    107712310001
    ASPROU, Caroline Anna
    Highnoon
    Woodbastwick Road, Blofield Heath
    NR13 4QH Norwich
    Norfolk
    Director
    Highnoon
    Woodbastwick Road, Blofield Heath
    NR13 4QH Norwich
    Norfolk
    British76073630001
    BELL, Graeme Paul
    6 Moule Rise
    LS25 2PH Garforth
    West Yorkshire
    Director
    6 Moule Rise
    LS25 2PH Garforth
    West Yorkshire
    EnglandBritish100163980001
    CAMM, Suzanne Mary
    The Old Coach House
    Norwich Road Reepham
    NR10 4JN Norwich
    Norfolk
    Director
    The Old Coach House
    Norwich Road Reepham
    NR10 4JN Norwich
    Norfolk
    British80914120002
    FRANCIS, Timothy John
    Farm End
    Topcroft
    NR35 2BB Bungay
    Norfolk
    Director
    Farm End
    Topcroft
    NR35 2BB Bungay
    Norfolk
    British80914650001
    HARNBY, Alastair John
    Dene Bank
    BD16 4AR Bingley
    21
    West Yorkshire
    Uk
    Director
    Dene Bank
    BD16 4AR Bingley
    21
    West Yorkshire
    Uk
    United KingdomBritish172070220002
    HUBBARD, Peter John
    Sevenleaze Lane
    Edge
    GL6 6NL Stroud
    Huddaknoll House
    Gloucestershire
    United Kingdom
    Director
    Sevenleaze Lane
    Edge
    GL6 6NL Stroud
    Huddaknoll House
    Gloucestershire
    United Kingdom
    EnglandBritish28375870003
    JAMES, Philip William Henry
    Hampton Head
    9 Peppercorn Lane
    Southampton
    Sn 04
    Bermuda
    Director
    Hampton Head
    9 Peppercorn Lane
    Southampton
    Sn 04
    Bermuda
    EnglandBritish33901640008
    LAIRD, Oliver Walter
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    Director
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    United KingdomBritish233726140001
    LAWRENCE, Christopher
    Dunelm House 47b The Street
    NR13 5AA Brundall
    Norfolk
    Director
    Dunelm House 47b The Street
    NR13 5AA Brundall
    Norfolk
    British90712300001
    MARLEY, Nicholas James
    6 The Brambles
    Woodside
    SW19 7AY London
    Director
    6 The Brambles
    Woodside
    SW19 7AY London
    United KingdomBritish113304050001
    MCGUIRE, Elisabeth Mary
    3 Landfall House
    Springvale
    PO34 5AN Seaview
    Isle Of Wight
    Director
    3 Landfall House
    Springvale
    PO34 5AN Seaview
    Isle Of Wight
    British80914390001
    MEDDES, Kenneth Sydney
    Hillside Townhill
    Bramham
    LS23 6QD Wetherby
    Director
    Hillside Townhill
    Bramham
    LS23 6QD Wetherby
    United KingdomBritish11486330002
    NICHOL, Duncan Kirkbride, Sir
    1 Pipers Close
    CH60 9LJ Heswall
    Merseyside
    Director
    1 Pipers Close
    CH60 9LJ Heswall
    Merseyside
    United KingdomBritish85618250001
    POSNER, Howard Michael
    Stocks Lane
    HX2 6PR Luddenden
    Eaves House
    Halifax
    Director
    Stocks Lane
    HX2 6PR Luddenden
    Eaves House
    Halifax
    United KingdomBritish139631580001
    RIVETT, Paul Geoffrey Leo
    Westfield Place
    Whinburgh Road, Westfield
    NR19 1QJ Dereham
    Norfolk
    Director
    Westfield Place
    Whinburgh Road, Westfield
    NR19 1QJ Dereham
    Norfolk
    British67188630001
    ROLFE, Timothy Paul
    9 Overhill
    CR6 9JR Warlingham
    Surrey
    Director
    9 Overhill
    CR6 9JR Warlingham
    Surrey
    EnglandBritish107872640001
    SMITH, Paul Kenneth
    4 Merchant Exchange
    Bridge Street
    YO1 6LT York
    North Yorkshire
    Director
    4 Merchant Exchange
    Bridge Street
    YO1 6LT York
    North Yorkshire
    United KingdomBritish126031290001
    SMYTH, Timothy John
    2 Knoll Road
    RH4 3EW Dorking
    Surrey
    Director
    2 Knoll Road
    RH4 3EW Dorking
    Surrey
    United KingdomBritish77794000002
    THORLEY, Anne
    51 Mill Lane
    NR17 2NW Attleborough
    Norfolk
    Director
    51 Mill Lane
    NR17 2NW Attleborough
    Norfolk
    British26486150002

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de TPS (INSURANCE ADMIN SERVICES) LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Gibraltar Island Road
    Old Mill Business Park
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    England
    06 abr 2016
    Gibraltar Island Road
    Old Mill Business Park
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    England
    No
    Forma jurídicaLimited
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalCompanies Act
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro04506493
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene TPS (INSURANCE ADMIN SERVICES) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 28 feb 2007
    Entregado el 15 mar 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due of each obligor to the chargee and/or the finance parties and/or any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    First fixed charge all shares in any group company,all of its investments now or subsequently belonging to it held by an. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Credit Suisse,London Branch
    Transacciones
    • 15 mar 2007Registro de un cargo (395)
    • 14 feb 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge of deposit
    Creado el 24 dic 2004
    Entregado el 31 dic 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Deposit initially of £50,000 credited to account designation 68126255 with the bank and any addition to that deposit and any deposit or account of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposit or account.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 31 dic 2004Registro de un cargo (395)
    • 05 sept 2016Satisfacción de una carga (MR04)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0