THE SPA ILKLEY (MANAGEMENT) LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | THE SPA ILKLEY (MANAGEMENT) LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Activa |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 02594281 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | No |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de THE SPA ILKLEY (MANAGEMENT) LIMITED?
- Administración de la propiedad de los residentes (98000) / Actividades de los hogares como empleadores; actividades de producción de bienes y servicios no diferenciadas de los hogares para uso propio
¿Dónde se encuentra THE SPA ILKLEY (MANAGEMENT) LIMITED?
Dirección de la sede social | C/O Cja Property Management 35 Brook Street LS29 8AG Ilkley United Kingdom |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de THE SPA ILKLEY (MANAGEMENT) LIMITED?
Vencido | No |
---|---|
Próximas cuentas | |
Próximo período contable finaliza el | 31 mar 2025 |
Próximas cuentas vencen el | 31 dic 2025 |
Últimas cuentas | |
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para THE SPA ILKLEY (MANAGEMENT) LIMITED?
Última declaración de confirmación cerrada hasta | 22 mar 2025 |
---|---|
Próxima declaración de confirmación vence | 05 abr 2025 |
Última declaración de confirmación | |
Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 22 mar 2024 |
Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para THE SPA ILKLEY (MANAGEMENT) LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2024 | 7 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 22 mar 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2023 | 7 páginas | AA | ||
Nombramiento de Mrs Alma Marshall como director el 29 jun 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Michael Ryder como director el 21 abr 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 22 mar 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2022 | 6 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 22 mar 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mr Michael Ryder como director el 18 oct 2021 | 2 páginas | AP01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2021 | 6 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 22 mar 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 mar 2020 | 3 páginas | AA | ||
Domicilio social registrado cambiado de Close House Giggleswick Settle North Yorkshire BD24 0EA England a C/O Cja Property Management 35 Brook Street Ilkley LS29 8AG el 03 mar 2021 | 1 páginas | AD01 | ||
Cese del nombramiento de Ian Stuart Horsfall Rhodes como director el 25 feb 2021 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Andrew David Earnshaw como secretario el 25 feb 2021 | 1 páginas | TM02 | ||
Nombramiento de Mr Gerald Edwin Yates como director el 11 nov 2020 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr Brian Mann como director el 11 nov 2020 | 2 páginas | AP01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 22 mar 2020 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 mar 2019 | 2 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 22 mar 2019 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 mar 2018 | 2 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 22 mar 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 mar 2017 | 2 páginas | AA | ||
Nombramiento de Mr Andrew David Earnshaw como secretario el 06 may 2017 | 2 páginas | AP03 | ||
Cese del nombramiento de Eileen Drummond-Rigby como secretario el 05 may 2017 | 1 páginas | TM02 | ||
¿Quiénes son los directivos de THE SPA ILKLEY (MANAGEMENT) LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANN, Brian | Director | 35 Brook Street LS29 8AG Ilkley C/O Cja Property Management United Kingdom | England | British | Retired | 280165140001 | ||||
MARSHALL, Alma | Director | 35 Brook Street LS29 8AG Ilkley C/O Cja Property Management United Kingdom | England | British | Retired | 310761960001 | ||||
YATES, Gerald Edwin | Director | 35 Brook Street LS29 8AG Ilkley C/O Cja Property Management United Kingdom | England | British | Retired | 280165150001 | ||||
BILBOROUGH, Christopher | Secretario | Hw Baines Building Fisher Green GH4 1NN Ripon North Yorkshire | British | Property | 44860720001 | |||||
BROWNLOW, Robert David | Secretario | 6a Campo Lane S1 1TP Sheffield | British | 42069200001 | ||||||
CARVER, Louisa | Secretario | Beech House 15 Croft Park Menston LS29 6LY Ilkley West Yorkshire | British | Director | 77932710001 | |||||
DRUMMOND-RIGBY, Eileen | Secretario | Apt 3 The Spa LS29 9NQ Ilkley West Yorkshire | British | Retired | 123557540001 | |||||
EARNSHAW, Andrew David | Secretario | Giggleswick BD24 0EA Settle Close House North Yorkshire England | 230850600001 | |||||||
FACER, Jonathan Mark | Secretario | 37 Raikeswood Drive BD23 1NA Skipton North Yorkshire | British | 40068230001 | ||||||
FREEGARD, Stephen Roger | Secretario | Farrand House Langbar LS29 0ER Ilkley West Yorkshire | British | Company Chairman | 2999760001 | |||||
NAVIEDE, Justine Penrose | Secretario | Melilia House Mereside Road Mere WA16 6QW Knutsford Cheshire | British | Company Director | 36734870001 | |||||
PEARSON, Geoffrey Stuart | Secretario | Hill Top Farm Stainburn LS21 2LT Otley West Yorkshire | British | Chartered Accountant | 100983390001 | |||||
RYDER, Michael | Secretario | 11 The Spa The Grove LS29 9NQ Ilkley West Yorkshire | British | Retired Police Officer | 57233940001 | |||||
SHEPHERD, Valerie Patricia | Secretario | Low Gables Foxhill Drive Westwood LS16 5PG Leeds West Yorkshire | British | Footwear Retailer | 50528600001 | |||||
LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED | Secretario designado corporativo | 84 Temple Chambers Temple Avenue EC4Y 0HP London | 900001510001 | |||||||
BILBOROUGH, Christopher | Director | Hw Baines Building Fisher Green GH4 1NN Ripon North Yorkshire | British | Property | 44860720001 | |||||
BOYLE, Brian Robert Calton | Director | Apartment No 5 The Spa The Grove LS29 9NQ Ilkley West Yorkshire | British | Retired | 57398270001 | |||||
CARVER, Louisa | Director | Beech House 15 Croft Park Menston LS29 6LY Ilkley West Yorkshire | British | Administrator | 77932710001 | |||||
DRUMMOND RIGBY, Eileen | Director | 3 Spa Apartments The Grove LS29 9NQ Ilkley West Yorkshire | England | British | Retired | 95731530001 | ||||
FREEGARD, Stephen Roger | Director | Farrand House Langbar LS29 0ER Ilkley West Yorkshire | England | British | Company Chairman | 2999760001 | ||||
GILLHAM, Hilda | Director | 4 Spa Apartments The Grove LS29 9NQ Ilkley West Yorkshire | British | Retired None | 95983900001 | |||||
HAMILTON, Julie | Director | Upper Stubbings Buttress Lane Luddendenfoot HX2 6SN Halifax West Yorkshire | British | Administrator | 14952630001 | |||||
HOOPER, Kenneth Frederick | Director | 19 The Spa The Grove LS29 9NQ Ilkley West Yorkshire | British | Retired | 97253010001 | |||||
JOYCE, Martin Andrew | Director | Low Hall Rupert Road LS29 0AQ Ilkley West Yorkshire | England | British | Director | 99916480001 | ||||
MERCER, Julian Howard | Director | 34 Ormonde Gate Chelsea SW3 4HA London | British | Property Development | 62166560002 | |||||
NAVIEDE, Pervaiz | Director | Melilia Mereside Road Mere WA16 6QW Knutsford Cheshire | Uk | British | Company Director | 6364190001 | ||||
PATCHETT, Betty | Director | Apt 17 The Spa The Grove LS29 9NQ Ilkley West Yorkshire | British | Retired | 63808320001 | |||||
PATTERSON, Winifred Patricia | Director | 18 Spa Apartments The Grove LS29 9NQ Ilkley West Yorkshire | British | None | 95983980001 | |||||
PEARSON, Geoffrey Stuart | Director | Hill Top Farm Stainburn LS21 2LT Otley West Yorkshire | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 100983390001 | ||||
RHODES, Ian Stuart Horsfall | Director | Westwood Drive LS29 9QX Ilkley Cherry Bank West Yorkshire | England | British | Company Director Printing And Mailing | 13685480001 | ||||
RHODES, Kenneth Horsfall | Director | Apartment 14 The Spa The Grove LS29 9NQ Ilkley West Yorkshire | United Kingdom | British | Retired | 57233880001 | ||||
RUSLING, Guy James | Director | 6a Campo Lane S1 1TP Sheffield South Yorkshire | British | Surveyor | 48088900002 | |||||
RYDER, Elaine | Director | The Grove LS29 9NQ Ilkley 11 Spa Apartments West Yorks England | England | British | Retired | 170430050001 | ||||
RYDER, Michael | Director | 35 Brook Street LS29 8AG Ilkley C/O Cja Property Management United Kingdom | England | British | Retired | 57233940001 | ||||
RYDER, Michael | Director | 11 The Spa The Grove LS29 9NQ Ilkley West Yorkshire | England | British | Retired | 57233940001 |
¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para THE SPA ILKLEY (MANAGEMENT) LIMITED?
Notificado el | Cesado el | Declaración |
---|---|---|
22 mar 2017 | La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa. |
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0