OLD LML LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaOLD LML LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02595154
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de OLD LML LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra OLD LML LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Unit 2 Atworth Business Park
    Bath Road
    SN12 8SB Atworth, Melksham
    Wiltshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de OLD LML LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    LEAFIELD MARINE LIMITED23 jun 199923 jun 1999
    LEAFIELD SEABASS LIMITED28 jun 199128 jun 1991
    OVAL (704) LIMITED25 mar 199125 mar 1991

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de OLD LML LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 oct 2011

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para OLD LML LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 oct 2011

    4 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 25 mar 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital26 mar 2012

    Estado de capital el 26 mar 2012

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Déclaration annuelle établie au 25 mar 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 oct 2010

    4 páginasAA

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 oct 2009

    12 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 25 mar 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cambio de datos del director David Louis Dickins el 25 mar 2010

    2 páginasCH01

    Certificado de cambio de nombre

    Company name changed leafield marine LIMITED\certificate issued on 28/10/09
    2 páginasCERTNM
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 16 oct 2009

    RES15

    Aviso de cambio de nombre

    2 páginasCONNOT

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 oct 2008

    12 páginasAA

    legacy

    3 páginas363a

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 oct 2007

    12 páginasAA

    legacy

    3 páginas363a

    legacy

    1 páginas287

    legacy

    1 páginas287

    legacy

    3 páginas363a

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 oct 2006

    18 páginasAA

    legacy

    6 páginas155(6)a

    legacy

    7 páginas395

    legacy

    1 páginas287

    ¿Quiénes son los directivos de OLD LML LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    CHAPPLE, Timothy Jonathan
    10 St Mellion Close
    Monkton Park
    SN15 3XN Chippenham
    Wiltshire
    Secretario
    10 St Mellion Close
    Monkton Park
    SN15 3XN Chippenham
    Wiltshire
    British28933940004
    CHAPPLE, Timothy Jonathan
    10 St Mellion Close
    Monkton Park
    SN15 3XN Chippenham
    Wiltshire
    Director
    10 St Mellion Close
    Monkton Park
    SN15 3XN Chippenham
    Wiltshire
    United KingdomBritish28933940004
    DICKINS, David Louis
    6 Greenfield Road
    SN10 5BP Devizes
    Wiltshire
    Director
    6 Greenfield Road
    SN10 5BP Devizes
    Wiltshire
    United KingdomBritish65876450001
    CHAPPLE, Timothy Jonathan
    10 St Mellion Close
    Monkton Park
    SN15 3XN Chippenham
    Wiltshire
    Secretario
    10 St Mellion Close
    Monkton Park
    SN15 3XN Chippenham
    Wiltshire
    British28933940004
    ELLARD, Sarah Louise
    7 Danehurst Place
    Locks Heath
    SO31 6PP Southampton
    Hampshire
    Secretario
    7 Danehurst Place
    Locks Heath
    SO31 6PP Southampton
    Hampshire
    British43855640011
    FORSYTH, Nigel John
    Park Farm Barn
    PO7 4SB Hambledon
    Hampshire
    Secretario
    Park Farm Barn
    PO7 4SB Hambledon
    Hampshire
    British59380470002
    WHADCOCK, Stephen Arthur
    75 Nursteed Road
    SN10 3AJ Devizes
    Wiltshire
    Secretario
    75 Nursteed Road
    SN10 3AJ Devizes
    Wiltshire
    British6425330001
    BLOTT, James
    The Rest
    West Street
    PO7 4RW Hambledon
    Hampshire
    Director
    The Rest
    West Street
    PO7 4RW Hambledon
    Hampshire
    British59380580002
    CHAPPLE, Timothy Jonathan
    10 St Mellion Close
    Monkton Park
    SN15 3XN Chippenham
    Wiltshire
    Director
    10 St Mellion Close
    Monkton Park
    SN15 3XN Chippenham
    Wiltshire
    United KingdomBritish28933940004
    DYKE, Robert Alexander
    Grove Farm 156 Winsley Road
    BA15 1PA Bradford On Avon
    Wiltshire
    Director
    Grove Farm 156 Winsley Road
    BA15 1PA Bradford On Avon
    Wiltshire
    EnglandBritish51678350002
    FORSYTH, Nigel John
    Park Farm Barn
    PO7 4SB Hambledon
    Hampshire
    Director
    Park Farm Barn
    PO7 4SB Hambledon
    Hampshire
    British59380470002
    HELME, Michael John
    The Coach House
    Main Road, Lea
    DE4 5GJ Matlock
    Director
    The Coach House
    Main Road, Lea
    DE4 5GJ Matlock
    EnglandBritish91910030001
    JACOMB, Kenneth Edward
    Holly Tree Farm
    Sandy Lane
    SN12 2QB Chippenham
    Wiltshire
    Director
    Holly Tree Farm
    Sandy Lane
    SN12 2QB Chippenham
    Wiltshire
    British6425340001
    MEREDITH, Brian Horace
    20a The Street
    Broughton Gifford
    SN12 8PW Melksham
    Wiltshire
    Director
    20a The Street
    Broughton Gifford
    SN12 8PW Melksham
    Wiltshire
    British26601600001
    MUNRO, Peter Austin Dods
    Top Acres
    Chapmanslade
    BA13 4AP Westbury
    Wiltshire
    Director
    Top Acres
    Chapmanslade
    BA13 4AP Westbury
    Wiltshire
    British67696410001
    PRICE, David John
    Ashe Hill
    Ashe
    RG25 3AE Basingstoke
    Hampshire
    Director
    Ashe Hill
    Ashe
    RG25 3AE Basingstoke
    Hampshire
    United KingdomBritish75259760004
    RAYNER, Paul Adrian
    48 Kilham Lane
    SO22 5QD Winchester
    Hampshire
    Director
    48 Kilham Lane
    SO22 5QD Winchester
    Hampshire
    United KingdomBritish45628680002
    TONGE, Richard Leslie
    4 Trimnells
    Colerne
    SN14 8EP Chippenham
    Wiltshire
    Director
    4 Trimnells
    Colerne
    SN14 8EP Chippenham
    Wiltshire
    British6425360001

    ¿Tiene OLD LML LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 21 dic 2006
    Entregado el 05 ene 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 05 ene 2007Registro de un cargo (395)
    • 12 jul 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 30 jun 2003
    Entregado el 05 jul 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 05 jul 2003Registro de un cargo (395)
    • 12 jul 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture deed
    Creado el 29 sept 1999
    Entregado el 07 oct 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 07 oct 1999Registro de un cargo (395)
    • 19 ene 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0