CEDO HOUSEHOLD PRODUCTS LIMITED

CEDO HOUSEHOLD PRODUCTS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Declaraciones de personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCEDO HOUSEHOLD PRODUCTS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02595181
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de CEDO HOUSEHOLD PRODUCTS LIMITED?

    • fabricación de otros productos de plástico (22290) / Industrias manufactureras

    ¿Dónde se encuentra CEDO HOUSEHOLD PRODUCTS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Cedo
    Halesfield 11
    TF7 4LZ Telford
    Shropshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CEDO HOUSEHOLD PRODUCTS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    P L HOLDINGS LIMITED23 jul 199123 jul 1991
    ADVISER (185) LIMITED25 mar 199125 mar 1991

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de CEDO HOUSEHOLD PRODUCTS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2017

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para CEDO HOUSEHOLD PRODUCTS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ2

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Cese del nombramiento de Helen Catherine Allum como director el 03 oct 2019

    1 páginasTM01

    Exercice comptable en cours raccourci du 31 dic 2019 au 30 dic 2019

    1 páginasAA01

    Declaración de confirmación presentada el 01 abr 2019 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 07 nov 2018

    • Capital: GBP 1.00
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Cancellation of share premium account. 06/11/2018
    RES13
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 05 nov 2018

    • Capital: GBP 6,582,757
    3 páginasSH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2017

    18 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 01 abr 2018 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cambio de datos del director Mrs Helen Catherine Allum el 20 nov 2017

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Andrzej Rafal Ostrowski el 12 dic 2017

    2 páginasCH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2016

    18 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 01 abr 2017 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Nombramiento de Mrs Helen Catherine Allum como director el 03 oct 2016

    2 páginasAP01

    Cancelación total de la carga 5

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 4

    4 páginasMR04

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2015

    17 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 01 abr 2016 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital01 abr 2016

    Estado de capital el 01 abr 2016

    • Capital: GBP 6,051,757
    SH01

    Cese del nombramiento de David James Pearce como director el 19 feb 2016

    1 páginasTM01

    Resoluciones

    Resolutions
    13 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01

    Déclaration annuelle établie au 31 dic 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital12 ene 2016

    Estado de capital el 12 ene 2016

    • Capital: GBP 6,051,757
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2014

    17 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de CEDO HOUSEHOLD PRODUCTS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    OSTROWSKI, Andrzej Rafal
    Halesfield 11
    TF7 4LZ Telford
    Cedo
    Shropshire
    United Kingdom
    Director
    Halesfield 11
    TF7 4LZ Telford
    Cedo
    Shropshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish195252290003
    FERGUSON, Donald Alexander Hall
    54 Greenway
    Southgate
    N14 6NS London
    Secretario
    54 Greenway
    Southgate
    N14 6NS London
    British65742890001
    MURRAY, Sylvia Joan
    45 Newlands Road
    IG8 0RS Woodford Green
    Essex
    Secretario
    45 Newlands Road
    IG8 0RS Woodford Green
    Essex
    British58353930001
    OSTROWSKI, Andrzej Rafal
    Halesfield 11
    Telford
    TF7 4LZ Shropshire
    Secretario
    Halesfield 11
    Telford
    TF7 4LZ Shropshire
    Polish130241980001
    MBC SECRETARIES LIMITED
    Classic House
    174-180 Old Street
    EC1V 9BP London
    Secretario designado corporativo
    Classic House
    174-180 Old Street
    EC1V 9BP London
    900000700001
    TSD NOMINEES LIMITED
    2 Serjeants Inn
    EC4Y 1LT London
    Secretario designado corporativo
    2 Serjeants Inn
    EC4Y 1LT London
    900007440001
    ALLUM, Helen Catherine
    Halesfield 11
    TF7 4LZ Telford
    Cedo
    Shropshire
    Director
    Halesfield 11
    TF7 4LZ Telford
    Cedo
    Shropshire
    United KingdomBritish80472920003
    BURLEY, Jeremiah
    Maryfield High Street
    Taplow
    SL6 0EX Maidenhead
    Berkshire
    Director
    Maryfield High Street
    Taplow
    SL6 0EX Maidenhead
    Berkshire
    British29315500001
    BUTT, Stephen Andrew
    Lacon Crest Lacon Street
    Prees
    SY13 2EP Whitchurch
    Shropshire
    Director
    Lacon Crest Lacon Street
    Prees
    SY13 2EP Whitchurch
    Shropshire
    British24813290002
    CASWELL, Christopher John
    4 The Dovecotes
    B75 5DN Sutton Coldfield
    West Midlands
    Director
    4 The Dovecotes
    B75 5DN Sutton Coldfield
    West Midlands
    British85349980001
    CLAUSEN-BRUUN, Soren
    8 Deards End Lane
    SG3 6NL Knebworth
    Hertfordshire
    Director
    8 Deards End Lane
    SG3 6NL Knebworth
    Hertfordshire
    United KingdomDanish24813300004
    FERGUSON, Donald Alexander Hall
    67 New Road
    AL6 0AL Welwyn
    Hertfordshire
    Director
    67 New Road
    AL6 0AL Welwyn
    Hertfordshire
    EnglandBritish65742890002
    FERGUSON, Donald Alexander Hall
    54 Greenway
    Southgate
    N14 6NS London
    Director
    54 Greenway
    Southgate
    N14 6NS London
    British65742890001
    GOESEKE, Christian, Dr
    Bregenzer Str 3
    FOREIGN Berlin
    10707
    Germany
    Director
    Bregenzer Str 3
    FOREIGN Berlin
    10707
    Germany
    GermanyGerman277601760001
    HOEM, Bjorn Arild
    Kraden Puhl 68
    Leichlingen
    D42799
    Director
    Kraden Puhl 68
    Leichlingen
    D42799
    German94300520001
    HOEM, Bjorn Arild
    30 Upland Drive
    Brookmans Park
    AL9 6PT Hatfield
    Hertfordshire
    Director
    30 Upland Drive
    Brookmans Park
    AL9 6PT Hatfield
    Hertfordshire
    German13653590002
    HOHMANN, Helmut Wilhelm Oswald, Dr
    Elmstein
    Helmbach 16
    Helmbach 16
    Germany
    Director
    Elmstein
    Helmbach 16
    Helmbach 16
    Germany
    German71899360001
    HUMPHREYS, Peter
    Chestnut House
    Mawsons Mead
    CF5 6SX St Nicholas
    Vale Of Glamorgan
    Director
    Chestnut House
    Mawsons Mead
    CF5 6SX St Nicholas
    Vale Of Glamorgan
    WalesBritish159765430001
    JAKEMAN, Arthur Leslie
    Garnhill Sandford Avenue
    SY6 7AE Church Stretton
    Salop
    Director
    Garnhill Sandford Avenue
    SY6 7AE Church Stretton
    Salop
    British6844230001
    JAMIESON, Alan Rae Dalziel
    Halesfield 11
    Telford
    TF7 4LZ Shropshire
    Director
    Halesfield 11
    Telford
    TF7 4LZ Shropshire
    EnglandBritish31138330004
    LANGAN, James Anthony
    Halesfield 11
    Telford
    TF7 4LZ Shropshire
    Director
    Halesfield 11
    Telford
    TF7 4LZ Shropshire
    United KingdomBritish161934440001
    MCCOMASKY, James Anthony
    Halesfield 11
    Telford
    TF7 4LZ Shropshire
    Director
    Halesfield 11
    Telford
    TF7 4LZ Shropshire
    EnglandBritish148271070001
    MORGAN, Jonathan Windsor
    51 Castelnau
    Barnes
    SW13 9RT London
    Director
    51 Castelnau
    Barnes
    SW13 9RT London
    British10387190002
    NAKHLA, Karim Paul
    Swan Hill Court House
    Swan Hill
    SY1 1NP Shrewsbury
    Director
    Swan Hill Court House
    Swan Hill
    SY1 1NP Shrewsbury
    EnglandBritish6844240002
    OSTROWSKI, Andrzej Rafal
    Kyffhauserstrasse
    Monchengladbach
    27/2
    Director
    Kyffhauserstrasse
    Monchengladbach
    27/2
    GermanyPolish130241980001
    PEARCE, David James
    Halesfield 11
    TF7 4LZ Telford
    Cedo
    Shropshire
    United Kingdom
    Director
    Halesfield 11
    TF7 4LZ Telford
    Cedo
    Shropshire
    United Kingdom
    Great BritainBritish146723580001
    TROMEL, Frank, Dr
    Gunther-Quandt-Haus
    Seedamnweg 55
    61352 Bad Homburg
    Germany
    Director
    Gunther-Quandt-Haus
    Seedamnweg 55
    61352 Bad Homburg
    Germany
    German48305810001
    TURNER, Matthew Charles
    Springfield Hall
    Star Lane Knowl Hill
    RG10 9UR Reading
    Berkshire
    Director
    Springfield Hall
    Star Lane Knowl Hill
    RG10 9UR Reading
    Berkshire
    United KingdomBritish115927000001
    WAGNER, Antonius Hugo, Dr
    Pater Dietrich Ring 34
    46286 Dorsten Rhade
    Germany
    Director
    Pater Dietrich Ring 34
    46286 Dorsten Rhade
    Germany
    German82010470001
    WILKENS, Michael Diederich
    Am Amburger Berg 4
    D61350 Bad Homburg
    Germany
    Director
    Am Amburger Berg 4
    D61350 Bad Homburg
    Germany
    German48455880001
    WINTER, Berndt Michael
    Mariannenweg 12
    D-61348 Bad Homburg Vdh
    FOREIGN Germany
    Director
    Mariannenweg 12
    D-61348 Bad Homburg Vdh
    FOREIGN Germany
    German64461820001
    WOOD, William Brian
    5 Bowood Drive
    Tettehall
    WV6 9AW Wolverhampton
    West Midlands
    Director
    5 Bowood Drive
    Tettehall
    WV6 9AW Wolverhampton
    West Midlands
    British79645330001
    ZAPKA-VOLKMANN, Heike-Anja
    Martinstrasse 14
    Wiesbaden
    65189
    Germany
    Director
    Martinstrasse 14
    Wiesbaden
    65189
    Germany
    German93015070001
    MBC NOMINEES LIMITED
    Classic House
    174-180 Old Street
    EC1V 9BP London
    Director designado corporativo
    Classic House
    174-180 Old Street
    EC1V 9BP London
    900000690001
    TSD NOMINEES LIMITED
    2 Serjeants Inn
    EC4Y 1LT London
    Director designado corporativo
    2 Serjeants Inn
    EC4Y 1LT London
    900007440001

    ¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para CEDO HOUSEHOLD PRODUCTS LIMITED?

    Declaraciones de personas con control significativo
    Notificado elCesado elDeclaración
    01 abr 2017La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa.

    ¿Tiene CEDO HOUSEHOLD PRODUCTS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture deed
    Creado el 31 ene 2013
    Entregado el 05 feb 2013
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 05 feb 2013Registro de un cargo (MG01)
    • 28 sept 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Non-receivables accession deed
    Creado el 16 sept 2009
    Entregado el 24 sept 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All its property assets and undertaking on the terms set out in clauses 3 (grant of security), 4 (fixed security) and 5 (floating charge) see image for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited (The Security Agent)
    Transacciones
    • 24 sept 2009Registro de un cargo (395)
    • 28 sept 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 24 jun 1991
    Entregado el 27 jun 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transacciones
    • 27 jun 1991Registro de una carga
    • 01 jul 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Letter of off set
    Creado el 14 jun 1991
    Entregado el 20 jun 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The balances at credit of any accounts held by the governor and company of the bank of scotland in the name of advisor (185) limited.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 20 jun 1991Registro de una carga
    • 01 jul 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 14 jun 1991
    Entregado el 19 jun 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 19 jun 1991Registro de una carga
    • 21 oct 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0