CEDO HOUSEHOLD PRODUCTS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | CEDO HOUSEHOLD PRODUCTS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02595181 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de CEDO HOUSEHOLD PRODUCTS LIMITED?
- fabricación de otros productos de plástico (22290) / Industrias manufactureras
¿Dónde se encuentra CEDO HOUSEHOLD PRODUCTS LIMITED?
| Dirección de la sede social | Cedo Halesfield 11 TF7 4LZ Telford Shropshire |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CEDO HOUSEHOLD PRODUCTS LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| P L HOLDINGS LIMITED | 23 jul 1991 | 23 jul 1991 |
| ADVISER (185) LIMITED | 25 mar 1991 | 25 mar 1991 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de CEDO HOUSEHOLD PRODUCTS LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2017 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para CEDO HOUSEHOLD PRODUCTS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación obligatoria | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria | 1 páginas | GAZ1 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Helen Catherine Allum como director el 03 oct 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Exercice comptable en cours raccourci du 31 dic 2019 au 30 dic 2019 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 abr 2019 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||||||
Estado de capital el 07 nov 2018
| 4 páginas | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Estado de capital tras una asignación de acciones el 05 nov 2018
| 3 páginas | SH01 | ||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2017 | 18 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 abr 2018 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cambio de datos del director Mrs Helen Catherine Allum el 20 nov 2017 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Cambio de datos del director Mr Andrzej Rafal Ostrowski el 12 dic 2017 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2016 | 18 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 abr 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mrs Helen Catherine Allum como director el 03 oct 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Cancelación total de la carga 5 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||||||
Cancelación total de la carga 4 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2015 | 17 páginas | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 abr 2016 avec liste complète des actionnaires | 3 páginas | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cese del nombramiento de David James Pearce como director el 19 feb 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 13 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 31 dic 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2014 | 17 páginas | AA | ||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de CEDO HOUSEHOLD PRODUCTS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSTROWSKI, Andrzej Rafal | Director | Halesfield 11 TF7 4LZ Telford Cedo Shropshire United Kingdom | United Kingdom | British | 195252290003 | |||||
| FERGUSON, Donald Alexander Hall | Secretario | 54 Greenway Southgate N14 6NS London | British | 65742890001 | ||||||
| MURRAY, Sylvia Joan | Secretario | 45 Newlands Road IG8 0RS Woodford Green Essex | British | 58353930001 | ||||||
| OSTROWSKI, Andrzej Rafal | Secretario | Halesfield 11 Telford TF7 4LZ Shropshire | Polish | 130241980001 | ||||||
| MBC SECRETARIES LIMITED | Secretario designado corporativo | Classic House 174-180 Old Street EC1V 9BP London | 900000700001 | |||||||
| TSD NOMINEES LIMITED | Secretario designado corporativo | 2 Serjeants Inn EC4Y 1LT London | 900007440001 | |||||||
| ALLUM, Helen Catherine | Director | Halesfield 11 TF7 4LZ Telford Cedo Shropshire | United Kingdom | British | 80472920003 | |||||
| BURLEY, Jeremiah | Director | Maryfield High Street Taplow SL6 0EX Maidenhead Berkshire | British | 29315500001 | ||||||
| BUTT, Stephen Andrew | Director | Lacon Crest Lacon Street Prees SY13 2EP Whitchurch Shropshire | British | 24813290002 | ||||||
| CASWELL, Christopher John | Director | 4 The Dovecotes B75 5DN Sutton Coldfield West Midlands | British | 85349980001 | ||||||
| CLAUSEN-BRUUN, Soren | Director | 8 Deards End Lane SG3 6NL Knebworth Hertfordshire | United Kingdom | Danish | 24813300004 | |||||
| FERGUSON, Donald Alexander Hall | Director | 67 New Road AL6 0AL Welwyn Hertfordshire | England | British | 65742890002 | |||||
| FERGUSON, Donald Alexander Hall | Director | 54 Greenway Southgate N14 6NS London | British | 65742890001 | ||||||
| GOESEKE, Christian, Dr | Director | Bregenzer Str 3 FOREIGN Berlin 10707 Germany | Germany | German | 277601760001 | |||||
| HOEM, Bjorn Arild | Director | Kraden Puhl 68 Leichlingen D42799 | German | 94300520001 | ||||||
| HOEM, Bjorn Arild | Director | 30 Upland Drive Brookmans Park AL9 6PT Hatfield Hertfordshire | German | 13653590002 | ||||||
| HOHMANN, Helmut Wilhelm Oswald, Dr | Director | Elmstein Helmbach 16 Helmbach 16 Germany | German | 71899360001 | ||||||
| HUMPHREYS, Peter | Director | Chestnut House Mawsons Mead CF5 6SX St Nicholas Vale Of Glamorgan | Wales | British | 159765430001 | |||||
| JAKEMAN, Arthur Leslie | Director | Garnhill Sandford Avenue SY6 7AE Church Stretton Salop | British | 6844230001 | ||||||
| JAMIESON, Alan Rae Dalziel | Director | Halesfield 11 Telford TF7 4LZ Shropshire | England | British | 31138330004 | |||||
| LANGAN, James Anthony | Director | Halesfield 11 Telford TF7 4LZ Shropshire | United Kingdom | British | 161934440001 | |||||
| MCCOMASKY, James Anthony | Director | Halesfield 11 Telford TF7 4LZ Shropshire | England | British | 148271070001 | |||||
| MORGAN, Jonathan Windsor | Director | 51 Castelnau Barnes SW13 9RT London | British | 10387190002 | ||||||
| NAKHLA, Karim Paul | Director | Swan Hill Court House Swan Hill SY1 1NP Shrewsbury | England | British | 6844240002 | |||||
| OSTROWSKI, Andrzej Rafal | Director | Kyffhauserstrasse Monchengladbach 27/2 | Germany | Polish | 130241980001 | |||||
| PEARCE, David James | Director | Halesfield 11 TF7 4LZ Telford Cedo Shropshire United Kingdom | Great Britain | British | 146723580001 | |||||
| TROMEL, Frank, Dr | Director | Gunther-Quandt-Haus Seedamnweg 55 61352 Bad Homburg Germany | German | 48305810001 | ||||||
| TURNER, Matthew Charles | Director | Springfield Hall Star Lane Knowl Hill RG10 9UR Reading Berkshire | United Kingdom | British | 115927000001 | |||||
| WAGNER, Antonius Hugo, Dr | Director | Pater Dietrich Ring 34 46286 Dorsten Rhade Germany | German | 82010470001 | ||||||
| WILKENS, Michael Diederich | Director | Am Amburger Berg 4 D61350 Bad Homburg Germany | German | 48455880001 | ||||||
| WINTER, Berndt Michael | Director | Mariannenweg 12 D-61348 Bad Homburg Vdh FOREIGN Germany | German | 64461820001 | ||||||
| WOOD, William Brian | Director | 5 Bowood Drive Tettehall WV6 9AW Wolverhampton West Midlands | British | 79645330001 | ||||||
| ZAPKA-VOLKMANN, Heike-Anja | Director | Martinstrasse 14 Wiesbaden 65189 Germany | German | 93015070001 | ||||||
| MBC NOMINEES LIMITED | Director designado corporativo | Classic House 174-180 Old Street EC1V 9BP London | 900000690001 | |||||||
| TSD NOMINEES LIMITED | Director designado corporativo | 2 Serjeants Inn EC4Y 1LT London | 900007440001 |
¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para CEDO HOUSEHOLD PRODUCTS LIMITED?
| Notificado el | Cesado el | Declaración |
|---|---|---|
| 01 abr 2017 | La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa. |
¿Tiene CEDO HOUSEHOLD PRODUCTS LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture deed | Creado el 31 ene 2013 Entregado el 05 feb 2013 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Non-receivables accession deed | Creado el 16 sept 2009 Entregado el 24 sept 2009 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción All its property assets and undertaking on the terms set out in clauses 3 (grant of security), 4 (fixed security) and 5 (floating charge) see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 24 jun 1991 Entregado el 27 jun 1991 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Letter of off set | Creado el 14 jun 1991 Entregado el 20 jun 1991 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción The balances at credit of any accounts held by the governor and company of the bank of scotland in the name of advisor (185) limited. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 14 jun 1991 Entregado el 19 jun 1991 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0