EXPRESS 2 AUTOMOTIVE LIMITED

EXPRESS 2 AUTOMOTIVE LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaEXPRESS 2 AUTOMOTIVE LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02595962
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de EXPRESS 2 AUTOMOTIVE LIMITED?

    • Otras industrias manufactureras n.c.p. (32990) / Industrias manufactureras

    ¿Dónde se encuentra EXPRESS 2 AUTOMOTIVE LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Unit Bt 95/2
    Tanfield Lea Industrial Estate
    DH9 9NX North, Stanley
    County Durham
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de EXPRESS 2 AUTOMOTIVE LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    CHROMEX (NORTH EAST) LIMITED30 abr 199130 abr 1991
    KEEPJOINT LIMITED27 mar 199127 mar 1991

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de EXPRESS 2 AUTOMOTIVE LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2011

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para EXPRESS 2 AUTOMOTIVE LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 dic 2011

    7 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 27 mar 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital30 may 2012

    Estado de capital el 30 may 2012

    • Capital: GBP 200,000
    SH01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2010

    7 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 27 mar 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2009

    14 páginasAA

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2008

    24 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 27 mar 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cambio de datos del director Mark David Hutchinson el 30 mar 2010

    2 páginasCH01

    legacy

    4 páginas363a

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2007

    24 páginasAA

    legacy

    4 páginas363a

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2006

    25 páginasAA

    legacy

    2 páginas403a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    3 páginas363a

    legacy

    1 páginas288c

    legacy

    1 páginas288c

    legacy

    1 páginas288c

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2005

    30 páginasAA

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    2 páginas363a

    ¿Quiénes son los directivos de EXPRESS 2 AUTOMOTIVE LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BROOKS, Charles David
    Planetrees
    Wall
    NE46 4EQ Hexham
    Northumberland
    Secretario
    Planetrees
    Wall
    NE46 4EQ Hexham
    Northumberland
    British78876890002
    BROOKS, Charles David
    Planetrees
    Wall
    NE46 4EQ Hexham
    Northumberland
    Director
    Planetrees
    Wall
    NE46 4EQ Hexham
    Northumberland
    EnglandBritish78876890002
    HUTCHINSON, Mark David
    15 Larkspur Close
    TS26 0WD Bishop Cuthbert
    Hartlepool
    Director
    15 Larkspur Close
    TS26 0WD Bishop Cuthbert
    Hartlepool
    United KingdomBritish66723660002
    STANLEY, Roy Robert Edward
    16 Graham Park Road
    Gosforth
    NE3 4BH Newcastle Upon Tyne
    Director
    16 Graham Park Road
    Gosforth
    NE3 4BH Newcastle Upon Tyne
    United KingdomBritish8609980002
    BORRELL, Arthur James Peter
    Pinedale
    Wallace Avenue
    NE16 4SX Whickham
    County Durham
    Secretario
    Pinedale
    Wallace Avenue
    NE16 4SX Whickham
    County Durham
    British47328860003
    HARRISON, Irene Lesley
    Fy Mwthin
    22 Merthyr Road Tongwynlais
    CF15 7LH Cardiff
    Secretario
    Fy Mwthin
    22 Merthyr Road Tongwynlais
    CF15 7LH Cardiff
    British39878290001
    ROBINSON, Timothy Philip
    Stanegates Leazes Lane
    NE46 3BA Hexham
    Secretario
    Stanegates Leazes Lane
    NE46 3BA Hexham
    British18158790003
    THOMPSON, Christopher Scott
    Highfield House
    Woodhill Farm
    NE20 0JA Ponteland
    Newcastle Upon Tyne
    Secretario
    Highfield House
    Woodhill Farm
    NE20 0JA Ponteland
    Newcastle Upon Tyne
    British42840520001
    WARD, David
    69 Langdale Way
    The Pastures
    NE36 0UF East Boldon
    Tyne & Wear
    Secretario
    69 Langdale Way
    The Pastures
    NE36 0UF East Boldon
    Tyne & Wear
    British79459910001
    YOUNG, Ronald Desmond
    42 Commissioners Wharf
    NE29 6DN North Shields
    Tyne & Wear
    Secretario
    42 Commissioners Wharf
    NE29 6DN North Shields
    Tyne & Wear
    British67962880001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretario designado corporativo
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    CLARK, Andrew Philip
    4 West Farm
    North Road
    NE36 0DQ East Boldon
    Tyne & Wear
    Director
    4 West Farm
    North Road
    NE36 0DQ East Boldon
    Tyne & Wear
    British73633070001
    GORDON, Jennifer
    The Old School
    Church Lane
    NE44 6DS Riding Mill
    Northumberland
    Director
    The Old School
    Church Lane
    NE44 6DS Riding Mill
    Northumberland
    British72057320004
    ROBINSON, Timothy Philip
    Stanegates Leazes Lane
    NE46 3BA Hexham
    Director
    Stanegates Leazes Lane
    NE46 3BA Hexham
    United KingdomBritish18158790003
    THOMPSON, Christopher Scott
    Highfield House
    Woodhill Farm
    NE20 0JA Ponteland
    Newcastle Upon Tyne
    Director
    Highfield House
    Woodhill Farm
    NE20 0JA Ponteland
    Newcastle Upon Tyne
    British42840520001
    THOMPSON, Christopher Scott
    Highfield House
    Woodhill Farm
    NE20 0JA Ponteland
    Newcastle Upon Tyne
    Director
    Highfield House
    Woodhill Farm
    NE20 0JA Ponteland
    Newcastle Upon Tyne
    British42840520001
    THOMPSON, Keith Fulton Scott
    22 Linden Way
    Ponteland
    NE20 9DP Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Director
    22 Linden Way
    Ponteland
    NE20 9DP Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British11845980001
    WARD, David
    69 Langdale Way
    The Pastures
    NE36 0UF East Boldon
    Tyne & Wear
    Director
    69 Langdale Way
    The Pastures
    NE36 0UF East Boldon
    Tyne & Wear
    British79459910001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Director designado corporativo
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    ¿Tiene EXPRESS 2 AUTOMOTIVE LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    All assets debenture (including qualifying floating charge)
    Creado el 19 may 2005
    Entregado el 28 may 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Five Arrows Commercial Finance Limited
    Transacciones
    • 28 may 2005Registro de un cargo (395)
    • 02 oct 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creado el 20 nov 2002
    Entregado el 25 nov 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Yamazaki mazak horizontal machining centre H500-5ON, 126734 - 336,043 - 204,006, (for details of further chattels charged please refer to form 395), the full benefit of any guarantee warranty or other obligation, the full benefit of all agreements, the intellectual property rights, the full benefit of the companys rights and interests in and to all insurance effected by the company or by any person of the mortgaged chattels or the use thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 25 nov 2002Registro de un cargo (395)
    • 25 may 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed charge
    Creado el 29 oct 2001
    Entregado el 31 oct 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £419,703 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the charge
    Breve descripción
    1 x used tooling package comprising pentium computer & accessories multiplex 625 126873 multiplex 625 126876 quick turn 30. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Udt Limited
    Transacciones
    • 31 oct 2001Registro de un cargo (395)
    • 25 may 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 25 jun 2001
    Entregado el 28 jun 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 28 jun 2001Registro de un cargo (395)
    • 25 may 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 28 sept 1999
    Entregado el 01 oct 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 01 oct 1999Registro de un cargo (395)
    • 20 sept 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed charge
    Creado el 28 sept 1999
    Entregado el 02 oct 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed charge over the goods listed in schedule. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Udt Limited
    Transacciones
    • 02 oct 1999Registro de un cargo (395)
    • 25 may 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Single debenture
    Creado el 07 oct 1991
    Entregado el 11 oct 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Including all heritable property and assets in scotland. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 11 oct 1991Registro de una carga
    • 25 may 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0