USHERS OF TROWBRIDGE LIMITED

USHERS OF TROWBRIDGE LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaUSHERS OF TROWBRIDGE LIMITED
    Estado de la empresaLiquidación
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02597688
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de USHERS OF TROWBRIDGE LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra USHERS OF TROWBRIDGE LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Jubilee House
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton On Trent
    Staffordshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de USHERS OF TROWBRIDGE LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    FILBUK 247 LIMITED03 abr 199103 abr 1991

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de USHERS OF TROWBRIDGE LIMITED?

    Vencido
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el11 ago 2022
    Próximas cuentas vencen el11 may 2023
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta15 ago 2021

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para USHERS OF TROWBRIDGE LIMITED?

    Vencido
    Última declaración de confirmación cerrada hasta13 mar 2023
    Próxima declaración de confirmación vence27 mar 2023
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta13 mar 2022
    Vencido

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para USHERS OF TROWBRIDGE LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 26 mar 2024

    9 páginasLIQ03

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    4 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 27 mar 2023

    LRESSP

    Declaración de solvencia

    5 páginasLIQ01

    Estado de capital el 09 mar 2023

    • Capital: GBP 1
    5 páginasSH19

    legacy

    2 páginasSH20

    legacy

    2 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01

    Memorándum y Estatutos

    8 páginasMA

    Nombramiento de Mr Derek Anthony Howell como director el 01 feb 2023

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Stephen Peter Dando como director el 01 feb 2023

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Edward Michael Bashforth como director el 01 feb 2023

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Francesca Appleby como secretario el 22 ago 2022

    1 páginasTM02

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 15 ago 2021

    4 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 13 mar 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Declaración de confirmación presentada el 13 mar 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 16 ago 2020

    17 páginasAA

    Exercice comptable précédent raccourci du 24 ago 2020 au 11 ago 2020

    1 páginasAA01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 18 ago 2019

    3 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 13 mar 2020 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 18 ago 2018

    3 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 13 mar 2019 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 19 ago 2017

    3 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 13 mar 2018 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    ¿Quiénes son los directivos de USHERS OF TROWBRIDGE LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    HOWELL, Derek Anthony
    Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    One
    England
    Director
    Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    One
    England
    United KingdomBritishDirector299032280001
    APPLEBY, Francesca
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secretario
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    191629440001
    COLES, Martin David
    14 Dymott Square
    Hilperton
    BA14 7RW Trowbridge
    Wiltshire
    Secretario
    14 Dymott Square
    Hilperton
    BA14 7RW Trowbridge
    Wiltshire
    BritishCompany Director7586530002
    DALLISON, Adrian John
    27 Marlborough Building
    BA1 2LY Bath
    Secretario
    27 Marlborough Building
    BA1 2LY Bath
    BritishChartered Accountant63086120002
    GREEN, Andrew Bernard
    Roddenbrook Lodge Huntenhull Lane
    Chapmanslade
    BA13 4AS Westbury
    Wiltshire
    Secretario
    Roddenbrook Lodge Huntenhull Lane
    Chapmanslade
    BA13 4AS Westbury
    Wiltshire
    British62833460001
    HARRIS, Claire Louise
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secretario
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    175489550001
    REES, William Arwel
    Woodlands
    Old Monmouth Road
    NP7 8BU Abergavenny
    Gwent
    Secretario
    Woodlands
    Old Monmouth Road
    NP7 8BU Abergavenny
    Gwent
    BritishAccountant3205450001
    RUDD, Susan Clare
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    Secretario
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    British81789210004
    STEWART, Claire Susan
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secretario
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    British117216940001
    TYRRELL, Helen
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secretario
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    161609220001
    FILBUK (SECRETARIES) LIMITED
    Fitzalan House
    Fitzalan Road
    CF2 1XZ Cardiff
    South Glamorgan
    Secretario designado corporativo
    Fitzalan House
    Fitzalan Road
    CF2 1XZ Cardiff
    South Glamorgan
    900004990001
    BASHFORTH, Edward Michael
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Director
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector131551840002
    BIRCH, James
    7 Woods Close
    Sherston
    SN16 0LF Malmesbury
    Wiltshire
    Director
    7 Woods Close
    Sherston
    SN16 0LF Malmesbury
    Wiltshire
    BritishDirector116449180001
    BLACKLEDGE, David Albert
    The Stoop
    Stanley
    SN15 3RF Chippenham
    Wiltshire
    Director
    The Stoop
    Stanley
    SN15 3RF Chippenham
    Wiltshire
    EnglandBritishDirector123065010001
    BOYLE, Joseph Michael
    58 Candlemas Lane
    HP9 1AF Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Director
    58 Candlemas Lane
    HP9 1AF Beaconsfield
    Buckinghamshire
    IrishRetail Director39039380003
    BREARE, Robert Roddick Ackrill
    42 Magdalen Road
    SW18 3NP London
    Director
    42 Magdalen Road
    SW18 3NP London
    BritishDirector38255700004
    BROOK, Peter Stuart
    Curzon House
    Rode
    BA11 6QW Frome
    Somerset
    Director
    Curzon House
    Rode
    BA11 6QW Frome
    Somerset
    EnglandBritishDirector120715800001
    BUCKLEY, Simon
    Abbotshill 2 Abbey Terrace
    SA19 6BD Llandeilo
    Dyfed
    Director
    Abbotshill 2 Abbey Terrace
    SA19 6BD Llandeilo
    Dyfed
    WalesWelshDirector45611200001
    BUCKLEY, Simon
    Abbotshill 2 Abbey Terrace
    SA19 6BD Llandeilo
    Dyfed
    Director
    Abbotshill 2 Abbey Terrace
    SA19 6BD Llandeilo
    Dyfed
    WalesWelshDirector45611200001
    COLES, Martin David
    14 Dymott Square
    Hilperton
    BA14 7RW Trowbridge
    Wiltshire
    Director
    14 Dymott Square
    Hilperton
    BA14 7RW Trowbridge
    Wiltshire
    EnglandBritishCompany Director7586530002
    DANDO, Stephen Peter
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Director
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant152083750001
    DUTTON, Philip
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Director
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector141395280001
    ENG, Siang Yang Veronica
    6 Frewin Road
    SW18 3LP London
    Director
    6 Frewin Road
    SW18 3LP London
    SingaporeanFund Manager43564360001
    HUMPHREY, Peter Michael
    The Coppice
    Bowden Hill Lacock
    SN15 2PP Chippenham
    Wiltshire
    Director
    The Coppice
    Bowden Hill Lacock
    SN15 2PP Chippenham
    Wiltshire
    BritishDirector36114040002
    JONES, Owen Griffiths Ronald
    43a Holly Bush Road
    Cyncoed
    CF2 6SY Cardiff
    South Glamorgan
    Director
    43a Holly Bush Road
    Cyncoed
    CF2 6SY Cardiff
    South Glamorgan
    WelshDirector34313410001
    LARGE, Peter Francis William
    Heath Lodge Heath Road
    LU7 8AU Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    Director
    Heath Lodge Heath Road
    LU7 8AU Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    BritishInvestment Banker66271370001
    LUSCOMBE, Richard William
    Lauriston House
    Town Barton, Norton St. Philip
    BA2 7LN Bath
    Avon
    Director
    Lauriston House
    Town Barton, Norton St. Philip
    BA2 7LN Bath
    Avon
    BritishDirector70464690001
    MACLEAY, Alastair
    Prospect House
    Trudoxhill
    BA11 5DP Frome
    Somerset
    Director
    Prospect House
    Trudoxhill
    BA11 5DP Frome
    Somerset
    EnglandBritishDirector28099710001
    MCDONALD, Robert James
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    Director
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    BritishDirector42019620001
    MCLACHLAN, John James
    Amberwood
    Woodland Rise
    TN15 0HZ Sevenoaks
    Kent
    Director
    Amberwood
    Woodland Rise
    TN15 0HZ Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritishChartered Accountant7039760002
    MOULTON, Jonathan Paul
    Sequoia
    57 Kippington Road
    TN13 2LL Sevenoaks
    Kent
    Director
    Sequoia
    57 Kippington Road
    TN13 2LL Sevenoaks
    Kent
    BritishDirector14450900001
    NORTH, Roger Richard George
    Eastleigh Stables
    Bishopstrow
    BA12 9HW Warminster
    Wiltshire
    Director
    Eastleigh Stables
    Bishopstrow
    BA12 9HW Warminster
    Wiltshire
    BritishCheif Executive32490940002
    PRESTON, Neil David
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Director
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector63043630002
    REES, William Arwel
    Woodlands
    Old Monmouth Road
    NP7 8BU Abergavenny
    Gwent
    Director
    Woodlands
    Old Monmouth Road
    NP7 8BU Abergavenny
    Gwent
    United KingdomBritishAccountant3205450001
    STAFFORD, Richard Anthony
    Oldmill Barn Henfords Marsh
    BA12 9PA Warminster
    Wiltshire
    Director
    Oldmill Barn Henfords Marsh
    BA12 9PA Warminster
    Wiltshire
    BritishDirector63206930002

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de USHERS OF TROWBRIDGE LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    06 abr 2016
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland And Wales
    Autoridad legalUnited Kingdom (England And Wales)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro3635246
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene USHERS OF TROWBRIDGE LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 15 may 2001
    Entregado el 22 may 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    6A george street and land and buildings on the north west side of union street trowbridge wiltshire. T/no. WT108923 and land and buildings on hte north west side of fore street trowbridge wiltshire. T/no. WT108921 and WT137825. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Skandinaviska Enskilda Banken Ab (Publ)
    Transacciones
    • 22 may 2001Registro de un cargo (395)
    • 21 oct 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 01 jun 2000
    Entregado el 16 jun 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H property k/a the brewery fore street trowbridge wiltshire - WT108921 WT137825 and WT108923. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 16 jun 2000Registro de un cargo (395)
    • 13 oct 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 24 may 2000
    Entregado el 02 jun 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 02 jun 2000Registro de un cargo (395)
    • 19 jul 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creado el 18 oct 1996
    Entregado el 22 oct 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The goods specified in the schedule to form 395 together with the benefitv of contracts per the acquisition of goods and all and any representations warranties and guarantees. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Nws Bank PLC
    Transacciones
    • 22 oct 1996Registro de un cargo (395)
    • 22 dic 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Seventh supplemental debenture
    Creado el 30 jul 1996
    Entregado el 12 ago 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee arising under or in connection with the financing documents (as defined)
    Breve descripción
    .. undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC, (The "Security Trustee") as Security Agent and Trustee for Thelenders
    Transacciones
    • 12 ago 1996Registro de un cargo (395)
    • 22 dic 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Sixth supplemental debenture
    Creado el 24 may 1996
    Entregado el 13 jun 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee (actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity) arising under or in connection with the financing documents as defined if and to the extent that such obligations and liabilities do not form part of the secured liabilities as defined in the original debenture
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 13 jun 1996Registro de un cargo (395)
    • 22 dic 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fifth supplemental debenture
    Creado el 04 jul 1995
    Entregado el 12 jul 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    A) all monies due or to become due from the company to the chargee and b) each obligor to the senior creditors under or in connection with the senior finance documents; and c) each obligor to the hedging bank under or in connection with the hedging document; and d) each obligor to the mezzanine creditors under or in connection with the mezzanine finance documents
    Breve descripción
    Various properties as detailed in the schedule to form 395 including :- alpha arms, 26 alpha street, slough t/n bk 320525; the crofton, crofton lane, hillhead, PO14 3QF t/n hp 439538; and the crown, timbrell street BA14 8PP t/n wt 108692. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 12 jul 1995Registro de un cargo (395)
    • 22 dic 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 04 jul 1995
    Entregado el 11 jul 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    The deferred consideration as defined in an agreement dated 30TH june 1996 and made between inntrepreneur estates (cpc) limited and the company together with interest thereon payable in accordance with the provisions thereof
    Breve descripción
    Property k/a the railway arms station road west drayton middlesex and all fixtures & fittings.
    Personas con derecho
    • Inntrepreneur Estates (Cpc) Limited
    Transacciones
    • 11 jul 1995Registro de un cargo (395)
    • 22 dic 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 04 jul 1995
    Entregado el 11 jul 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    The deferred consideration as defined in an agreement dated 30TH june 1995 and made between inntrepreneur (cpc) limited and the company together with interest thereon payable in accordance with the provisions thereof
    Breve descripción
    Property k/a the railway tavern 39 bedfont lane feltham middlesex & fixtures & fittings.
    Personas con derecho
    • Inntrepreneur Estates (Cpc) Limited
    Transacciones
    • 11 jul 1995Registro de un cargo (395)
    • 22 dic 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 04 jul 1995
    Entregado el 11 jul 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    The deferred consideration as defined in an agreement dated 30TH june 1995 and made between inntrepreneur estates (gl) limited and the company together with interest thereon payable in accordance with the provisions thereof
    Breve descripción
    Property k/a the royal oak hawkeridge westbury wiltshire and all fixtures & fittings.
    Personas con derecho
    • Inntrepreneur Estates (Gl) Limited
    Transacciones
    • 11 jul 1995Registro de un cargo (395)
    • 22 dic 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 04 jul 1995
    Entregado el 11 jul 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    The deferred consideration as defined in an agreement dated 30TH june 1995 and made between inntrepreneur estates (cpc) limited and the company together with interest thereon payable in accordance with the provisions thereof
    Breve descripción
    Property k/a the white lion 115 high street egham surrey and all fixtures & fittings.
    Personas con derecho
    • Inntrepreneur Estates (Cpc) Limited
    Transacciones
    • 11 jul 1995Registro de un cargo (395)
    • 22 dic 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 04 jul 1995
    Entregado el 11 jul 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    The deferred consideration as defined in an agreement dated 30TH june 1995 and made between inntrepreneur estates (cpc) limited and the company together with interest thereon payable in accordance with the provisions thereof
    Breve descripción
    Property k/a the jolly farmer guildford road runfold farnham surrey and all fixtures & fittings.
    Personas con derecho
    • Inntrepreneur Estates (Cpc) Limited
    Transacciones
    • 11 jul 1995Registro de un cargo (395)
    • 22 dic 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 04 jul 1995
    Entregado el 11 jul 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    The deferred consideration as defined in an agreement dated 30TH june 1995 and made between inntrepreneur estates (gl) limited and the company together with interest thereon payable in accordance with the provisions thereof
    Breve descripción
    Property k/a the crown staplehay trull taunton somerset and all fixtures & fittings.
    Personas con derecho
    • Inntrepreneur Estates (Gl) Limited
    Transacciones
    • 11 jul 1995Registro de un cargo (395)
    • 22 dic 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fourth supplemental debenture
    Creado el 18 may 1995
    Entregado el 26 may 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    For securing a) all monies due or to become due from the company to the chargee (the security trustee) as security agent and trustee for the lenders (as defined) under the debenture and from b) each obligor to the senior creditors under or in connection with the senior finance documents; and c) each obligor to the hedging bank under or in connection with the hedging document; and d) each obligor to the mezzanine creditors under or in connection with the mezzanine finance documents
    Breve descripción
    All property specified in the schedule to this form 395 together with all buildings and fixtures on the property. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 26 may 1995Registro de un cargo (395)
    • 22 dic 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 18 may 1995
    Entregado el 19 may 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of a portfolio disposal contract dated 16/5/95 and/or this debenture
    Breve descripción
    First legal mortgage the real property and first fixed equitable charge all its right title and interet in the property. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Marr Taverns Limited
    Transacciones
    • 19 may 1995Registro de un cargo (395)
    • 22 dic 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Third supplemental debenture
    Creado el 15 mar 1995
    Entregado el 03 abr 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    (A) all monies due or to become due from the company to the chargee (the security trustee) as security agent and trustee for the lenders (as defined) under the debenture and from (b) each obligor to the senior creditors under or in connection with the senior finance documents and from (c) each obligor to the hedging bank under or in connection with the hedging documents and from (d) each obligor to the mezzanine creditors under or in connection with the mezzanine finance documents
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 03 abr 1995Registro de un cargo (395)
    • 22 dic 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Second supplemental debenture
    Creado el 24 oct 1994
    Entregado el 08 nov 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    A) all monies due or to become due from the company to the chargee (the security trustee) as security agent and trustee for the lenders (as defined) under the debenture and from b) each obligor to the senior creditors under or in connection with the senior finance documents; and c) each obligor to the hedging bank under or in connection with the hedging documents; and d) each obligor to the mezzanine creditors under or in connection with the mezzanine finance documents
    Breve descripción
    All of the mortgaged property together with all buildings and fixtures thereon, the proceeds of sale and the benefit of any covenants and all plant and machinery; all bnefits in respect of insurances and the benefit of all present and future licences etc.. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 08 nov 1994Registro de un cargo (395)
    • 22 dic 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Supplemental debenture
    Creado el 24 nov 1992
    Entregado el 25 nov 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    For securing a)all monies due or to become due from the company to national westminster bank PLC(the security trustee) as security agent and trustee for the lenders (as defined) under the debenture and from b)each obligor to the senior creditors under or in connection with the senior finance documents;and c) each obligor to the hedging bank under or in connection with the hedging documents;and d) each obligor to the mezzanine creditors under or in connection with the mezzanine finance documents.
    Breve descripción
    All of the mortgaged property together with all buildings and fixtures thereon,the proceeds of sale and the benefit of any covenants and all plant and machinery;all benefits in respect of the insurances and the benefit of all present and future licences.please see doc M167C for full details.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 25 nov 1992Registro de un cargo (395)
    • 22 dic 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 11 nov 1991
    Entregado el 27 nov 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    For securing a)all monies due or to become due from the company to national westminster bank PLC (the security trustee)as security agent and trustee for the lenders(as defined) under the debenture and from b) each obligor to the senior creditors under or in connection with the senior finance documents;and c)each obligor to the hedging bank under or in connection with the hedging documents;and d)each obligor to the mezzanine creditors under or in connection with the mezzanine finance documents.
    Breve descripción
    Please see M395 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Mezzanine Creditorsunder the Mezzanine Finance Documents
    • National Westminster Bank PLC (The Security Trustee)as Security Agent and Trustee for the Lenders(Asdefined) Under the Debenture
    • Senior Creditorsunder the Senior Finance Documents
    • Hedging Bankunder the Hedging Documents
    Transacciones
    • 27 nov 1991Registro de un cargo (395)
    • 22 dic 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene USHERS OF TROWBRIDGE LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    27 mar 2023Inicio de la liquidación
    21 mar 2023Fecha de la declaración de solvencia jurada
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Steven Sherry
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Profesional
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    David Matthew Hammond
    1 Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Profesional
    1 Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Emma Cray
    One Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Profesional
    One Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0